H (BARNSTAPLE) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামH (BARNSTAPLE) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02047347
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    H (BARNSTAPLE) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    H (BARNSTAPLE) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    H (BARNSTAPLE) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    NORTH DEVON FOODS LIMITED০১ মার্চ, ১৯৯৬০১ মার্চ, ১৯৯৬
    FMC (NORTH DEVON) LIMITED১৬ সেপ, ১৯৯৩১৬ সেপ, ১৯৯৩
    NORTH DEVON MEAT LIMITED১৫ আগ, ১৯৮৬১৫ আগ, ১৯৮৬

    H (BARNSTAPLE) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১২

    H (BARNSTAPLE) LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    H (BARNSTAPLE) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    ০৭ জানু, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,000
    4 পৃষ্ঠাSH19

    মূলধনের বিবরণ

    SH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    4 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    ০৯ জুল, ২০১৩ তারিখে Emmett Mcevoy-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৯ জুল, ২০১৩ তারিখে Mr Andrew John Mcdonald-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Emmett Mcevoy-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Antony Smith এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Andrew Mcdonald-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Suzanne Wise এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    কোম্পানির উদ্দেশ্যের বিবৃতি

    2 পৃষ্ঠাCC04

    কোম্পানির আর্টিকেলগুলিতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCC02

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    34 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    সিকিউরিটিজ বরাদ্দের রেজুলেশন

    RES10
    incorporation

    সংঘের স্মারকলিপি এবং/অথবা নিবন্ধের রেজুলেশন

    RES01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ জুল, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    ০১ জুল, ২০১১ তারিখে Mr Simon Nicholas Wilbraham-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    H (BARNSTAPLE) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    সচিব
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    MCDONALD, Andrew John
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishGeneral Counsel & Company Secretary164670820001
    MCEVOY, Emmett
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomIrishDirector168590540001
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Secretary125719290002
    ASHTON, Stephen David
    11 High Street
    SN11 0BN Calne
    Wiltshire
    সচিব
    11 High Street
    SN11 0BN Calne
    Wiltshire
    British50420410003
    BAMFORD, Philip Ian
    High Leys
    Danesbower Lane Blofield
    NR13 4LP Norwich
    Norfolk
    সচিব
    High Leys
    Danesbower Lane Blofield
    NR13 4LP Norwich
    Norfolk
    British4386590001
    DANIELS, Anthony Patrick
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    সচিব
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishFinancial Director24297480001
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    সচিব
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    MEHEW, Barry James
    16f Garlinge Road
    NW2 3TR London
    সচিব
    16f Garlinge Road
    NW2 3TR London
    BritishCompany Director54902120001
    MONKS, Anthony James
    Yarrow Cottage Severn Road
    Hallen
    BS10 7RZ Bristol
    Avon
    সচিব
    Yarrow Cottage Severn Road
    Hallen
    BS10 7RZ Bristol
    Avon
    British1374420001
    SHAW, Oliver Samuel
    8 Windsor Drive
    ST7 2TE Alsager
    Cheshire
    সচিব
    8 Windsor Drive
    ST7 2TE Alsager
    Cheshire
    British62518910001
    SMITH, Marie
    10 Hatch Place
    KT2 5NB Kingston Upon Thames
    Surrey
    সচিব
    10 Hatch Place
    KT2 5NB Kingston Upon Thames
    Surrey
    British40935980001
    ASHTON, Stephen David
    11 High Street
    SN11 0BN Calne
    Wiltshire
    পরিচালক
    11 High Street
    SN11 0BN Calne
    Wiltshire
    BritishCompany Director50420410003
    BUCHANAN, Keith Michael
    The Seedlings
    Bridge Road
    PE12 9EQ Long Sutton
    Lincolnshire
    পরিচালক
    The Seedlings
    Bridge Road
    PE12 9EQ Long Sutton
    Lincolnshire
    BritishChartered Accountant6017680002
    BUSWELL, Michel Norman
    The Dower House
    1 The Green
    NN12 8PD Blakesley
    Northants
    পরিচালক
    The Dower House
    1 The Green
    NN12 8PD Blakesley
    Northants
    BritishCompany Director15685720001
    CAMPBELL, Rosalind Ilona
    6 Hawthorn Close
    WD17 4SB Watford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    6 Hawthorn Close
    WD17 4SB Watford
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant58191970001
    CAWTHORNE, Raymond Richard
    11 Marine Court
    Instow
    EX39 4JP Bideford
    Devon
    পরিচালক
    11 Marine Court
    Instow
    EX39 4JP Bideford
    Devon
    EnglandBritishCompany Director9438230001
    CROSLAND, John Morton
    Darroch Beech Hill
    Mayford
    GU22 0SB Woking
    Surrey
    পরিচালক
    Darroch Beech Hill
    Mayford
    GU22 0SB Woking
    Surrey
    BritishChartered Surveyor36081540001
    DANIELS, Anthony Patrick
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishFinancial Director24297480001
    DANIELS, Anthony Patrick
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishFinancial Director24297480001
    GRAY, David
    32 Hampstead High Street
    NW3 1QD London
    পরিচালক
    32 Hampstead High Street
    NW3 1QD London
    BritishCompany Director52227630001
    HEWITT, Allan Joseph
    Glenmarrick
    Southstoke Road Combe Down
    BA2 5SN Bath
    Avon
    পরিচালক
    Glenmarrick
    Southstoke Road Combe Down
    BA2 5SN Bath
    Avon
    BritishCompany Director642200001
    JAY, Colin Edward
    25 Firsway
    Wightwick
    WV6 8BJ Wolverhampton
    West Midlands
    পরিচালক
    25 Firsway
    Wightwick
    WV6 8BJ Wolverhampton
    West Midlands
    BritishChief Executive Company Direct10510180001
    LANE, Jim
    St Edmunds House St Edmunds Drive
    Elmswell
    IP30 9HF Bury St Edmunds
    Suffolk
    পরিচালক
    St Edmunds House St Edmunds Drive
    Elmswell
    IP30 9HF Bury St Edmunds
    Suffolk
    BritishDirector64861520001
    LEACH, Paul Alan
    Station Road
    Bletchingdon
    OX5 3DE Kidlington
    8
    Oxfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Station Road
    Bletchingdon
    OX5 3DE Kidlington
    8
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishTreasurer136797430001
    LIFE, William Davey
    2 St Edmunds Drive
    Elmswell
    IP30 9HF Bury St Edmunds
    Suffolk
    পরিচালক
    2 St Edmunds Drive
    Elmswell
    IP30 9HF Bury St Edmunds
    Suffolk
    BritishCompany Director43610920002
    LIGHTON, John Kenneth
    Canns House
    Ide
    Exeter
    Devon
    পরিচালক
    Canns House
    Ide
    Exeter
    Devon
    BritishCompany Director28688020001
    MEHEW, Barry James
    16f Garlinge Road
    NW2 3TR London
    পরিচালক
    16f Garlinge Road
    NW2 3TR London
    BritishChartered Accountant54902120001
    PEELER, Andrew Michael
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant87359710001
    PINKNEY, Graham Richard
    2 St Edmunds Drive
    Elmswell
    IP30 9HF Bury St Edmunds
    Suffolk
    পরিচালক
    2 St Edmunds Drive
    Elmswell
    IP30 9HF Bury St Edmunds
    Suffolk
    BritishCompany Director43612220003
    ROSEN, Andrew Scott
    301 West 53rd Street
    New York
    Ny 10019
    United States
    পরিচালক
    301 West 53rd Street
    New York
    Ny 10019
    United States
    AmericanCompany Secretary64268220001
    SMITH, Antony David
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director147725160001
    TYLEY, Gwynfor Paul
    12 Prospect Road
    AL1 2AX St. Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    12 Prospect Road
    AL1 2AX St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant66169120001
    WISE, Suzanne Elizabeth
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishGeneral Counsel & Company Secretary136781050001
    WOOD-DOW, Terence John Shore
    Old Dimmings Village Road
    Dorney
    SL4 6QW Windsor
    Berkshire
    পরিচালক
    Old Dimmings Village Road
    Dorney
    SL4 6QW Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritishCorporate Executive19976310001

    H (BARNSTAPLE) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Group debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ নভে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ ডিসে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P. Morgan Europe Limited Acting as Security Agent for the Finance Parties
    ব্যবসায়
    • ১৫ ডিসে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জুল, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১০ আগ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company and/or each obligor company (as defined) to the chargee and/or the finance parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chase Manhattan International Limited Acting as Security Agent for the Finance Parties Pursuantto the Facilities Agreement
    ব্যবসায়
    • ২৬ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জুল, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0