CITY ANALYTICAL SERVICES LTD

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCITY ANALYTICAL SERVICES LTD
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02050581
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CITY ANALYTICAL SERVICES LTD এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    CITY ANALYTICAL SERVICES LTD কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Severn Trent Centre
    2 St John's Street
    CV1 2LZ Coventry
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CITY ANALYTICAL SERVICES LTD এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১৮

    CITY ANALYTICAL SERVICES LTD এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Section 1003 of the companies act 2006 28/09/2018
    RES13

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ১৯ অক্টো, ২০১৮ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    5 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ১১ এপ্রি, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ২৫ এপ্রি, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Richard Eadie-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    অডিট ছাড় সহায়ক হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    196 পৃষ্ঠাPARENT_ACC

    legacy

    1 পৃষ্ঠাAGREEMENT2

    legacy

    3 পৃষ্ঠাGUARANTEE2

    ১৪ ডিসে, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mark James Dovey এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১১ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১১ এপ্রি, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৩ মে, ২০১৬

    ০৩ মে, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 50,000
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১১ এপ্রি, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৩ মে, ২০১৫

    ১৩ মে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 50,000
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ০৪ সেপ, ২০১৪ তারিখে সচিব হিসাবে Aline Anne Campbell-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ০৩ সেপ, ২০১৪ তারিখে সচিব হিসাবে Matthew Armitage এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    CITY ANALYTICAL SERVICES LTD এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CAMPBELL, Aline Anne
    2 St John's Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    সচিব
    2 St John's Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    191783570001
    EADIE, Richard
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    পরিচালক
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector208711590001
    MCPHEELY, Robert Craig
    2 St John's Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    পরিচালক
    2 St John's Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    EnglandBritishAccountant104273610001
    ARMITAGE, Matthew
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    সচিব
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    157947290001
    BRIERLEY, Richard Paul
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    সচিব
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    146000940001
    CHETTLE, David
    Arden
    4 Leire Lane
    LE17 5JP Dunton Bassett
    Leicestershire
    সচিব
    Arden
    4 Leire Lane
    LE17 5JP Dunton Bassett
    Leicestershire
    British39794800007
    DAVIES, Peter Peers
    Birch House 20 Plymouth Road
    Barnt Green
    B45 8JA Birmingham
    সচিব
    Birch House 20 Plymouth Road
    Barnt Green
    B45 8JA Birmingham
    British58764390002
    GEANEY, Barry Patrick
    2 Elizabeth Court
    Myton Crescent
    CV34 6QB Warwick
    Warwickshire
    সচিব
    2 Elizabeth Court
    Myton Crescent
    CV34 6QB Warwick
    Warwickshire
    BritishCompany Accountant41231340001
    HANSFORD, Hazel Christine
    44 Stanley Road
    CV21 3UE Rugby
    Warwickshire
    সচিব
    44 Stanley Road
    CV21 3UE Rugby
    Warwickshire
    British17319060001
    PORRITT, Kerry Anne Abigail
    Brushwood House
    22 Clarence Road
    WR14 3EH Great Malvern
    Worcestershire
    সচিব
    Brushwood House
    22 Clarence Road
    WR14 3EH Great Malvern
    Worcestershire
    BritishChartered Secretary166987180001
    BALDWIN, Christopher Edward
    4 Robins Grove
    CV34 6RF Warwick
    Warwickshire
    পরিচালক
    4 Robins Grove
    CV34 6RF Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritishCompany Director73095720003
    BILLINGS, Clifford Victor
    8 Chestnut Spinney
    WR9 7QD Droitwich
    Worcestershire
    পরিচালক
    8 Chestnut Spinney
    WR9 7QD Droitwich
    Worcestershire
    BritishDirector63636900001
    DOVEY, Mark James, Mr.
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    পরিচালক
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Tax Manager166254070001
    GEANEY, Barry Patrick
    2 Elizabeth Court
    Myton Crescent
    CV34 6QB Warwick
    Warwickshire
    পরিচালক
    2 Elizabeth Court
    Myton Crescent
    CV34 6QB Warwick
    Warwickshire
    United KingdomBritishFinance Director41231340001
    GIBSON, Andrew Watson
    7 Peregrine Close
    Whittington
    WS14 9WA Lichfield
    Staffordshire
    পরিচালক
    7 Peregrine Close
    Whittington
    WS14 9WA Lichfield
    Staffordshire
    BritishMechanical Engineer80848530001
    HANSFORD, Hazel Christine
    44 Stanley Road
    CV21 3UE Rugby
    Warwickshire
    পরিচালক
    44 Stanley Road
    CV21 3UE Rugby
    Warwickshire
    BritishDirector17319060001
    HANSFORD, Hazel Christine
    44 Stanley Road
    CV21 3UE Rugby
    Warwickshire
    পরিচালক
    44 Stanley Road
    CV21 3UE Rugby
    Warwickshire
    BritishManaging Director17319060001
    HENTON, Rachel Ann
    25 Cromwell Road
    Coton Green
    B79 8ND Tamworth
    Staffordshire
    পরিচালক
    25 Cromwell Road
    Coton Green
    B79 8ND Tamworth
    Staffordshire
    BritishAccountant73002570001
    HOOD PICKARD, Tracy Linda
    5 Young Close
    Chase Meadow
    CV34 6PW Warwick
    Warwickshire
    পরিচালক
    5 Young Close
    Chase Meadow
    CV34 6PW Warwick
    Warwickshire
    BritishCompany Director71169530001
    MARSHALL, Katharine
    School House School Lane
    CV33 0BX Ladbroke
    Warwickshire
    পরিচালক
    School House School Lane
    CV33 0BX Ladbroke
    Warwickshire
    BritishCompany Director57907510001
    MARSHALL, Stephen Michael
    School House
    School Lane
    CV33 0BX Ladbroke
    Warwickshire
    পরিচালক
    School House
    School Lane
    CV33 0BX Ladbroke
    Warwickshire
    BritishDirector51921660002
    PEACE, Roger Kenneth
    Stamford House,
    Millfield,, Pebworth,
    CV37 8UX Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    পরিচালক
    Stamford House,
    Millfield,, Pebworth,
    CV37 8UX Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritishChartered Accountant41697510007
    PICKARD, James Arthur
    5 Young Close
    Chase Meadow
    CV34 6PW Warwick
    Warwickshire
    পরিচালক
    5 Young Close
    Chase Meadow
    CV34 6PW Warwick
    Warwickshire
    BritishManaging Director17608620003
    PORRITT, Kerry Anne Abigail
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    পরিচালক
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Secretary166987180001
    SENIOR, Paul Michael
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    পরিচালক
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director120413260001
    TYLER, Gerard Peter
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    পরিচালক
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant40481670003

    CITY ANALYTICAL SERVICES LTD এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Severn Trent Services Holdings Limited
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    2 St John’S Street
    CV1 2LZ Coventry
    Severn Trent Centre
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House (England And Wales)
    নিবন্ধন নম্বর4395572
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    CITY ANALYTICAL SERVICES LTD এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Fixed charge supplemental to a debenture dated 24/1/95 issued by the company
    তৈরি করা হয়েছে ১০ ফেব, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the aforesaid debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge over all rights,title and interest in or arising out of a factoring,invoice discounting or sales ledger financing agreement dated 13/4/93 with all book/other debts thereon. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ মে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ ফেব, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ ফেব, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ মে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ এপ্রি, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ এপ্রি, ১৯৯৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge on book and other debts as are not sold to and bought by the chargee under the terms of an agreement dated 13/4/93. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Alex. Lawrie Receivables Financing Limited
    ব্যবসায়
    • ১৪ এপ্রি, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মে, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ মে, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £4.840 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Equipment comprising kjeltec system bottle shaker and accessories for atomic absorbtion spectrophotometer, accessories for gas chromatograph contrifuge heatind rack, water bath hot plate microwave acid digestion system and miscellanious glassware, undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Council of the City of Coventry
    ব্যবসায়
    • ৩১ মে, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৯ এপ্রি, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জানু, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ফেব, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ ফেব, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৫ সেপ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0