COSATTO PRODUCTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCOSATTO PRODUCTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02054221
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    COSATTO PRODUCTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (5147) /

    COSATTO PRODUCTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Bentinck Mill
    Bentinck Street Farnworth
    BL4 7EP Bolton
    Lancashire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    COSATTO PRODUCTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    COSATTO LIMITED২০ মার্চ, ২০০৯২০ মার্চ, ২০০৯
    COSATTO (SALES) LIMITED০৬ মে, ১৯৮৭০৬ মে, ১৯৮৭
    TOSHCLOSE LIMITED১১ সেপ, ১৯৮৬১১ সেপ, ১৯৮৬

    COSATTO PRODUCTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ আগ, ২০০৯

    COSATTO PRODUCTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    5 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    5 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১০ ডিসে, ২০১০

    ১০ ডিসে, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed cosatto LIMITED\certificate issued on 27/04/10
    3 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name২৭ এপ্রি, ২০১০

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    CONNOT

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ০১ এপ্রি, ২০১০

    RES15

    legacy

    7 পৃষ্ঠাMG01

    মাঝারি কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ আগ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩০ সেপ, ২০০৯ থেকে ৩১ আগ, ২০০৯ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    ০১ ডিসে, ২০০৯ তারিখে Mr Andrew Stuart Kluge-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ ডিসে, ২০০৯ তারিখে Mr James Brandon Phillips-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    মাঝারি কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    5 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    5 পৃষ্ঠা395

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed cosatto (sales) LIMITED\certificate issued on 20/03/09
    3 পৃষ্ঠাCERTNM

    legacy

    4 পৃষ্ঠা395

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    COSATTO PRODUCTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    KLUGE, Andrew Stuart
    Bentinck Mill
    Bentinck Street Farnworth
    BL4 7EP Bolton
    Lancashire
    পরিচালক
    Bentinck Mill
    Bentinck Street Farnworth
    BL4 7EP Bolton
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director25269740001
    PHILLIPS, James Brandon
    Bentinck Mill
    Bentinck Street Farnworth
    BL4 7EP Bolton
    Lancashire
    পরিচালক
    Bentinck Mill
    Bentinck Street Farnworth
    BL4 7EP Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director61440450003
    HELM, Carol Ann
    Willowtree Avenue
    Broughton
    PR3 5DH Preston
    17
    Lancashire
    সচিব
    Willowtree Avenue
    Broughton
    PR3 5DH Preston
    17
    Lancashire
    BritishFinancial Controller131976100001
    HOBBS, Steven John
    1 Coppice End
    Highwoods
    CO4 9RQ Colchester
    Essex
    সচিব
    1 Coppice End
    Highwoods
    CO4 9RQ Colchester
    Essex
    BritishAccountant77807180001
    MADILL, Simon Hugh
    Birch House
    Carr Lane, Much Hoole
    PR4 4TH Preston
    Lancashire
    সচিব
    Birch House
    Carr Lane, Much Hoole
    PR4 4TH Preston
    Lancashire
    British79561370001
    ROBERTS, Wyn Eyton
    Manor Farm
    Main Street, Old Ravenfield
    S65 4NA Rotherham
    সচিব
    Manor Farm
    Main Street, Old Ravenfield
    S65 4NA Rotherham
    BritishCommercial Director7909920003
    ROBINSON, Michael John
    Holly Tree House
    Skipwith Road Escrick
    YO19 6JT York
    North Yorkshire
    সচিব
    Holly Tree House
    Skipwith Road Escrick
    YO19 6JT York
    North Yorkshire
    British115823780001
    SALTER, Clifford Thomas
    Mountside House
    Avenue Road
    CM4 9HB Ingatestone
    Essex
    সচিব
    Mountside House
    Avenue Road
    CM4 9HB Ingatestone
    Essex
    British4905970001
    SCOTT, John Edward
    11 North Lane
    Marks Tey
    CO6 1EG Colchester
    Essex
    সচিব
    11 North Lane
    Marks Tey
    CO6 1EG Colchester
    Essex
    British4906000001
    THEMIS, Sam
    Eyotts Farm
    White Tree Court
    CM3 7AL South Woodham Ferrers
    Essex
    সচিব
    Eyotts Farm
    White Tree Court
    CM3 7AL South Woodham Ferrers
    Essex
    BritishSolicitor89904180001
    NEMO SECRETARIES LIMITED
    80/83 Long Lane
    EC1A 9RL London
    কর্পোরেট সচিব
    80/83 Long Lane
    EC1A 9RL London
    19502000001
    BACON, Roger Frank
    Westfield House
    Witham Road, Tolleshunt Major
    CM9 8JU Maldon
    Essex
    পরিচালক
    Westfield House
    Witham Road, Tolleshunt Major
    CM9 8JU Maldon
    Essex
    BritishCompany Director65801060002
    DANIEL, Peter William
    103 The Avenue
    W13 8JT London
    পরিচালক
    103 The Avenue
    W13 8JT London
    BritishDraper4905990001
    HAINES, Michael
    49 Corinne Road
    N19 5EZ London
    পরিচালক
    49 Corinne Road
    N19 5EZ London
    BritishDesign Engineer45382740001
    HOBBS, Steven John
    1 Coppice End
    Highwoods
    CO4 9RQ Colchester
    Essex
    পরিচালক
    1 Coppice End
    Highwoods
    CO4 9RQ Colchester
    Essex
    EnglandBritishAccountant77807180001
    ROBERTS, Alistair Mark Stafford
    Lainston 2 Hogarth Road
    LE4 2SA Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    Lainston 2 Hogarth Road
    LE4 2SA Leicester
    Leicestershire
    BritishDirector55088360001
    ROBERTS, Wyn Eyton
    Manor Farm
    Main Street, Old Ravenfield
    S65 4NA Rotherham
    পরিচালক
    Manor Farm
    Main Street, Old Ravenfield
    S65 4NA Rotherham
    United KingdomBritishCommercial Director7909920003
    ROBINSON, Michael John
    Holly Tree House
    Skipwith Road Escrick
    YO19 6JT York
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Holly Tree House
    Skipwith Road Escrick
    YO19 6JT York
    North Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director115823780001
    SALTER, Clifford Thomas
    Mountside House
    Avenue Road
    CM4 9HB Ingatestone
    Essex
    পরিচালক
    Mountside House
    Avenue Road
    CM4 9HB Ingatestone
    Essex
    EnglandBritishDirector4905970001
    SALTER, Mark Clifford
    East Hanningfield Hall
    East Hanningfield
    CM3 8BQ Chelmsford
    Essex
    পরিচালক
    East Hanningfield Hall
    East Hanningfield
    CM3 8BQ Chelmsford
    Essex
    BritishDirector40827080001
    SCOTT, John Edward
    11 North Lane
    Marks Tey
    CO6 1EG Colchester
    Essex
    পরিচালক
    11 North Lane
    Marks Tey
    CO6 1EG Colchester
    Essex
    EnglandBritishAccountant4906000001
    TUCKER, Andrew Martin
    36 Oakdene Avenue
    BR7 6EA Chislehurst
    Kent
    পরিচালক
    36 Oakdene Avenue
    BR7 6EA Chislehurst
    Kent
    BritishTechnical Developer69728850001
    WHITTLEY, Stephen Scott
    48 Osprey Way
    CM2 8XU Chelmsford
    Essex
    পরিচালক
    48 Osprey Way
    CM2 8XU Chelmsford
    Essex
    BritishSales Director47275140001

    COSATTO PRODUCTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ এপ্রি, ২০১০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company or any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge the undertaking and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, all contracts, all computers see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Centric Spv 1 Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ এপ্রি, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Charge of trademarks
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company formerly known as cosatto (sales) limited to the chargee or its present or future holding company or its subsidiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed charge all trade marks being; cosatto reg no. 1483614 classes 20, go safe reg no. 1484089 classes 12, go safe start reg no. 2145185 (expired) classes 12 (for further details of trade marks charged please refer to the form 395); all other trade marks, benefit of all licences, the goodwill of the business of the company. See image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ge Commercial Finance (No.2) Limited
    ব্যবসায়
    • ২৫ মার্চ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ ডিসে, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Charge of trademarks
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মার্চ, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company formerly known as cosatto (sales) limited to the chargee or its present of future holding company or its subsidiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed charge, trade mark baby gogo, reg no: E6462295 all other trade marks or trade names, see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ge Commercial Finance (No.2) Limited (the Security Holder)
    ব্যবসায়
    • ১৭ মার্চ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ ডিসে, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Fixed & qualifying floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Five Arrows Commercial Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ১৫ এপ্রি, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ ডিসে, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ সেপ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৯ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ ডিসে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ আগ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ সেপ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৫ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ ডিসে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ আগ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ সেপ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ আগ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ এপ্রি, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ এপ্রি, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ ফেব, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ১৯৭৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জুল, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ জুল, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১২ ফেব, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0