THE MIDLAND PROPERTY COMPANY LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTHE MIDLAND PROPERTY COMPANY LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02072621
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    THE MIDLAND PROPERTY COMPANY LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    THE MIDLAND PROPERTY COMPANY LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Suite 64 Waterhouse Business Park
    2 Cromar Way
    CM1 2QE Chelmsford
    Essex
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    THE MIDLAND PROPERTY COMPANY LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    YIELDSTAKE LIMITED১১ নভে, ১৯৮৬১১ নভে, ১৯৮৬

    THE MIDLAND PROPERTY COMPANY LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৪

    THE MIDLAND PROPERTY COMPANY LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    THE MIDLAND PROPERTY COMPANY LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    ০৭ ডিসে, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE থেকে Suite 64 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QEপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ২৮ সেপ, ২০১৪ তারিখে Sally Ann Coughlan-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৯ সেপ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৬ অক্টো, ২০১৪

    ০৬ অক্টো, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    ২৯ সেপ, ২০১৪ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Queens Court, 9-17 Eastern Road Romford Essex RM1 3NG থেকে 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QEপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    পরিচালক হিসাবে Martin Quinn-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Matthew Rosenberg এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৯ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৯ নভে, ২০১৩

    ১৯ নভে, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    পরিচালক হিসাবে Erwin Rieck এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে W2001 Two Cv এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে W2001 Britannia Llc এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৯ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৯ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAR01

    ১২ সেপ, ২০১১ তারিখে Erwin Joseph Rieck-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৯ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে W2001 Britannia Llc-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP02

    পরিচালক হিসাবে W2001 Two Cv-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP02

    পরিচালক হিসাবে Veronique Menard এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    THE MIDLAND PROPERTY COMPANY LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    COUGHLAN, Sally Ann
    Waterhouse Business Park
    2 Cromar Way
    CM1 2QE Chelmsford
    Suite 64
    Essex
    England
    সচিব
    Waterhouse Business Park
    2 Cromar Way
    CM1 2QE Chelmsford
    Suite 64
    Essex
    England
    British107832420001
    QUINN, Martin Joseph
    34 Francis Grove
    Wimbledon
    SW19 4DT London
    Westmont Management Limited
    England
    পরিচালক
    34 Francis Grove
    Wimbledon
    SW19 4DT London
    Westmont Management Limited
    England
    EnglandIrishAsset Manager186571310001
    BURGESS, Keith John
    3 Queen Annes Gate
    White House Walk
    GU9 9AN Farnham
    Surrey
    সচিব
    3 Queen Annes Gate
    White House Walk
    GU9 9AN Farnham
    Surrey
    British7009790002
    CHRISTIAN, Tracy Joanne
    19 Lovell Walk
    RM13 7ND Rainham
    Essex
    সচিব
    19 Lovell Walk
    RM13 7ND Rainham
    Essex
    British102667300001
    JONES, Vanessa
    Stables House
    Castle Hill
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    সচিব
    Stables House
    Castle Hill
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    British72146200001
    PURVIS, Martin Terence Alan
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    সচিব
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    British7901050001
    STADEN, Paul Sidney
    Swallows Barn
    New College Court
    MK18 5JP Chackmore
    Buckingham
    সচিব
    Swallows Barn
    New College Court
    MK18 5JP Chackmore
    Buckingham
    British35453800001
    WATERS, Jonathan Roy
    Maldon Road
    CO3 3BQ Colchester
    237
    Essex
    সচিব
    Maldon Road
    CO3 3BQ Colchester
    237
    Essex
    British129848360001
    ALLSOP, Heather Louise
    62 Prebend Street
    N1 8PS London
    পরিচালক
    62 Prebend Street
    N1 8PS London
    BritishInvestment Banker101912850001
    ASHFORD, Martin John
    The Elms
    Chessetts Wood Road
    B94 6EL Lapworth
    Solihull
    পরিচালক
    The Elms
    Chessetts Wood Road
    B94 6EL Lapworth
    Solihull
    BritishEngineer1450190001
    COLES, Alan Clifford
    The Knoll
    Grendon
    NN7 1JG Northampton
    Beeches, 5
    Northamptonshire
    পরিচালক
    The Knoll
    Grendon
    NN7 1JG Northampton
    Beeches, 5
    Northamptonshire
    EnglandBritishChartered Accountant101144900002
    COLLYER, Brian Charles
    49 Route De Croissy
    78110 Le Vesinet
    France
    পরিচালক
    49 Route De Croissy
    78110 Le Vesinet
    France
    CanadianInvestment Banker101144260001
    COPPEL, Andrew Maxwell
    Orchard House
    8 Claremont Park Road
    KT10 9LT Esher
    Surrey
    পরিচালক
    Orchard House
    8 Claremont Park Road
    KT10 9LT Esher
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director14330100002
    CUTTS, John Charles
    Tudor Gables Old Warwick Road
    Lapworth
    B94 6AY Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    Tudor Gables Old Warwick Road
    Lapworth
    B94 6AY Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishChartered Surveyor56651680001
    GOIN, Russell Todd
    4 Rue Jadin
    75017
    FOREIGN Paris
    France
    পরিচালক
    4 Rue Jadin
    75017
    FOREIGN Paris
    France
    AmericanBanker108675490001
    KABALAN, Fadi
    Keyes House
    Dolphin Square
    SW1V 3NA London
    Suite 311
    পরিচালক
    Keyes House
    Dolphin Square
    SW1V 3NA London
    Suite 311
    EnglandBritishChartered Accountant133846470001
    KRAIS, Ashley Simon
    74 Marsh Lane
    NW7 4NT London
    পরিচালক
    74 Marsh Lane
    NW7 4NT London
    United KingdomBritishCompany Director105921220001
    LE POIDEVIN, Andrew Daryl
    Kinneil
    34 Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Kinneil
    34 Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director4958800007
    MENARD, Veronique Pascale Dominique
    Messina Avenue
    NW6 4LD London
    8
    পরিচালক
    Messina Avenue
    NW6 4LD London
    8
    United KingdomFrenchBanker141156250001
    METCALFE, Michael Stuart
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director40294180002
    MOORE, Richard John
    2 Maple Wood
    Bedhampton
    PO9 3JB Havant
    Hampshire
    পরিচালক
    2 Maple Wood
    Bedhampton
    PO9 3JB Havant
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director101144680001
    MULAHASANI, Heather Louise
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    পরিচালক
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    EnglandBritishBanker136994090001
    OGDEN, Kathryn
    14 Arundel Court
    43-47 Arundel Gardens
    W11 2LP London
    পরিচালক
    14 Arundel Court
    43-47 Arundel Gardens
    W11 2LP London
    AmericanAnalyst114248790002
    RIECK, Erwin Joseph
    Queens Court
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    পরিচালক
    Queens Court
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    GermanChief Executive Officer108675520002
    ROSENBERG, Matthew Alexander
    Coppice Walk
    Totteridge
    N20 8BZ London
    12
    পরিচালক
    Coppice Walk
    Totteridge
    N20 8BZ London
    12
    EnglandBritishAsset Manager134723670001
    SCOBLE, Timothy James
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    পরিচালক
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector83743120001
    STADEN, Paul Sidney
    Swallows Barn
    New College Court
    MK18 5JP Chackmore
    Buckingham
    পরিচালক
    Swallows Barn
    New College Court
    MK18 5JP Chackmore
    Buckingham
    BritishFinance Director35453800001
    W2001 BRITANNIA LLC
    The Corporation Trust Company
    1209 Orange Street
    Wilmington
    The Corporation Trust Company
    County Of Newcastle
    Usa
    কর্পোরেট পরিচালক
    The Corporation Trust Company
    1209 Orange Street
    Wilmington
    The Corporation Trust Company
    County Of Newcastle
    Usa
    আইনি ফর্মLIMITED LIABILITY COMPANY
    পরিচয়পত্রের ধরননন ইইএ
    আইনি কর্তৃপক্ষDELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY ACT
    152068480001
    W2001 TWO CV
    Strawinskylaan 1207
    1077 Xx Amsterdam
    Strawinskylaan 1207
    Netherlands
    কর্পোরেট পরিচালক
    Strawinskylaan 1207
    1077 Xx Amsterdam
    Strawinskylaan 1207
    Netherlands
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর34207195
    152068240001

    THE MIDLAND PROPERTY COMPANY LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ মার্চ, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    ব্যবসায়
    • ০৪ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ নভে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ ডিসে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage all estates or interests in the f/h, l/h and other immovable property. By way of fixed charge all estates or interests in any f/h, l/h and other immovable property, all stocks shares debentures bonds notes and loan capital, the goodwill, all copyrights and patents. By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    ব্যবসায়
    • ১৪ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ জুন, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Trust Coproration PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ জুন, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ ফেব, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental deed to the composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জুন, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুন, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Security Trustee for the Junior Term Lenders Defined in Theterm Facility Agreement)
    ব্যবসায়
    • ১১ জুন, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Security Trustee for the Junior Term Lenders)
    ব্যবসায়
    • ২৬ মার্চ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ মে, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জুন, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or ashford construction limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land on the north west of newport pagnell road,hardingstone, northampton,northamptonshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ জুন, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ মে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জুন, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or ashford construction limited to the chargee on any account whatsover.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land on north west of newport pagnell road hardingstone, northampton northamptonshire title no:- nn 133053.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ জুন, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৯ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ আগ, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ আগ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or m j ashford & co. Limited to the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1.3 acres of f/h land at london road, northampton, northamptonshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ আগ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৯ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0