FOX'S BURTON'S COMPANIES (FBC) UK LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামFOX'S BURTON'S COMPANIES (FBC) UK LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিসক্রিয়
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02086754
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    FOX'S BURTON'S COMPANIES (FBC) UK LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • রস্ক এবং বিস্কুট উৎপাদন; সংরক্ষিত পেস্ট্রি পণ্য এবং কেক উৎপাদন (10720) / উৎপাদন
    • কোকো এবং চকোলেট মিষ্টান্ন উৎপাদন (10821) / উৎপাদন

    FOX'S BURTON'S COMPANIES (FBC) UK LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    74-78 Victoria Street
    St Albans
    AL1 3XH Herts
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    FOX'S BURTON'S COMPANIES (FBC) UK LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    BURTON'S FOODS LIMITED০৩ সেপ, ২০০১০৩ সেপ, ২০০১
    THE HORIZON BISCUIT COMPANY LIMITED২৫ এপ্রি, ১৯৯৭২৫ এপ্রি, ১৯৯৭
    PREMIER LABORATORY SERVICES LIMITED০১ ডিসে, ১৯৯৫০১ ডিসে, ১৯৯৫
    CANTABRIAN PROPERTIES LIMITED৩০ নভে, ১৯৯৩৩০ নভে, ১৯৯৩
    CHIVERS HARTLEY LIMITED০২ জানু, ১৯৮৭০২ জানু, ১৯৮৭

    FOX'S BURTON'S COMPANIES (FBC) UK LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণনা
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ আগ, ২০২৪
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩১ মে, ২০২৫
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে২৬ আগ, ২০২৩

    FOX'S BURTON'S COMPANIES (FBC) UK LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে১৮ এপ্রি, ২০২৫
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে০২ মে, ২০২৫
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে১৮ এপ্রি, ২০২৪
    মেয়াদোত্তীর্ণনা

    FOX'S BURTON'S COMPANIES (FBC) UK LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    ২৫ জুল, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Sarah Ann Spittle এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৫ জুল, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Emanuele Mazzoni-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ২৬ আগ, ২০২৩ পর্যন্ত তৈরি

    50 পৃষ্ঠাAA

    ১৮ এপ্রি, ২০২৪ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed burton's foods LIMITED\certificate issued on 28/03/24
    3 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name২৮ মার্চ, ২০২৪

    রেজোলিউশন দ্বারা নাম পরিবর্তন

    NM01
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ২১ মার্চ, ২০২৪

    RES15

    ২৬ জানু, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Thomas David Riley এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৭ অক্টো, ২০২৩ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Burton's Foods (Holdings) Limited এর বন্ধ

    1 পৃষ্ঠাPSC07

    ২৭ অক্টো, ২০২৩ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Fox's Burton's Company (Fbc) Uk Limited এর বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাPSC02

    Mr Alberto Cavalleris কে পরিচালক হিসাবে নিয়োগের জন্য দ্বিতীয় দাখিল

    3 পৃষ্ঠাRP04AP01

    পূর্ণ হিসাব ২৭ আগ, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি

    51 পৃষ্ঠাAA

    ১৮ এপ্রি, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ২৭ মার্চ, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Alberto Cavelleris-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ০৫ অক্টো, ২০২৩Clarification A second filed AP01 was registered on 05/10/2023.

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি

    50 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ আগ, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Andrea Racca এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩১ ডিসে, ২০২২ থেকে ৩১ আগ, ২০২২ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ২৩ জুন, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Nicholas Peter Field এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১০ মে, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Thomas David Riley-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৮ এপ্রি, ২০২২ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    ১০ ডিসে, ২০২১ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণের দ্বিতীয় দাখিল

    • মূলধন: GBP 1,002.10
    4 পৃষ্ঠাRP04SH01

    ০২ ফেব, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Christophe Neumann-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০২ ফেব, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Andrea Racca-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১০ ডিসে, ২০২১ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,002.1
    4 পৃষ্ঠাSH01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ২৫ ফেব, ২০২২Clarification A second filed SH01 was registered on 25/02/2022.

    পূর্ণ হিসাব ২৬ ডিসে, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    49 পৃষ্ঠাAA

    ২১ জুন, ২০২১ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Burton's Foods (Holdings) Limited এর বিজ্ঞপ্তি

    4 পৃষ্ঠাPSC02

    ২১ জুন, ২০২১ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Giovanni Ferrero এর বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাPSC01

    FOX'S BURTON'S COMPANIES (FBC) UK LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    ABRAHAMS, Natalie
    74-78 Victoria Street
    St Albans
    AL1 3XH Herts
    সচিব
    74-78 Victoria Street
    St Albans
    AL1 3XH Herts
    267431790001
    BROWNE, Simon Leon
    Victoria Street
    AL1 3XH St Albans
    Charter Court 74-78
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Victoria Street
    AL1 3XH St Albans
    Charter Court 74-78
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector200654960001
    CAVALLERIS, Alberto
    Route De Treves
    L2633 Senningerberg
    16
    Luxembourg
    পরিচালক
    Route De Treves
    L2633 Senningerberg
    16
    Luxembourg
    LuxembourgItalianIndustrail Investment Control & Planing Officer307451930001
    MAZZONI, Emanuele
    74-78 Victoria Street
    St Albans
    AL1 3XH Herts
    পরিচালক
    74-78 Victoria Street
    St Albans
    AL1 3XH Herts
    EnglandItalianChief Financial Officer325688660001
    NEUMANN, Christophe
    Rue Guy Moquet
    75017 Paris
    15
    France
    পরিচালক
    Rue Guy Moquet
    75017 Paris
    15
    France
    FranceFrenchChief Legal And Compliance Director284316180001
    CHADA, Jaspal Singh
    9 Kiln Close
    Calvert
    MK18 2FD Buckingham
    Buckinghamshire
    সচিব
    9 Kiln Close
    Calvert
    MK18 2FD Buckingham
    Buckinghamshire
    British100093770001
    ELLINOR, Graham Mark
    16 Ridgewood Drive
    AL5 3LE Harpenden
    Hertfordshire
    সচিব
    16 Ridgewood Drive
    AL5 3LE Harpenden
    Hertfordshire
    British102575170001
    GREEN, James Alexander
    94 Churchway
    Haddenham
    HP17 8DT Aylesbury
    Buckinghamshire
    সচিব
    94 Churchway
    Haddenham
    HP17 8DT Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director127488000001
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    সচিব
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    MARTIN, Richard William Thomas
    Church Barn
    NN17 3AX Laxton
    Northamptonshire
    সচিব
    Church Barn
    NN17 3AX Laxton
    Northamptonshire
    British37115510005
    SHEWARD, Philip Charles
    Pippins 23 Twatling Road
    Barnt Green
    B45 8HY Birmingham
    West Midlands
    সচিব
    Pippins 23 Twatling Road
    Barnt Green
    B45 8HY Birmingham
    West Midlands
    British49813130001
    SPITTLE, Sarah Ann
    74-78 Victoria Street
    AL1 3XH St. Albans
    Charter Court
    Hertfordshire
    England
    সচিব
    74-78 Victoria Street
    AL1 3XH St. Albans
    Charter Court
    Hertfordshire
    England
    British186941980001
    ALEXANDER, Stephen Harold
    40 Thurleigh Road
    SW12 8UD London
    পরিচালক
    40 Thurleigh Road
    SW12 8UD London
    BritishDirector9796990001
    BAKER, Andrew Stanley
    49 Rue Burgaud-Desmarets
    Saintes
    17100
    France
    পরিচালক
    49 Rue Burgaud-Desmarets
    Saintes
    17100
    France
    FranceBritishDirector45411300002
    BEATY, James Edward
    Victoria Street
    AL1 3XH St Albans
    Charter Court 74-78
    Herts
    Uk
    পরিচালক
    Victoria Street
    AL1 3XH St Albans
    Charter Court 74-78
    Herts
    Uk
    EnglandBritishDirector197723980001
    BELFER, Simon Leo
    1505 No 1 West India Quay
    26 Hertsmere Road
    E14 4EF London
    পরিচালক
    1505 No 1 West India Quay
    26 Hertsmere Road
    E14 4EF London
    BritishFinance Director94520040002
    BOASE, Benjamin
    74-78 Victoria Street
    AL1 3XH St. Albans
    Charter Court
    Hertfordshire
    England
    পরিচালক
    74-78 Victoria Street
    AL1 3XH St. Albans
    Charter Court
    Hertfordshire
    England
    United KingdomAustrian/BritishDirector186941860001
    BROWN, Joseph Arthur
    15 Hayward Road
    OX2 8LN Oxford
    Oxfordshire
    পরিচালক
    15 Hayward Road
    OX2 8LN Oxford
    Oxfordshire
    BritishDirector27217550001
    CAMP, Anthony Mark
    2 Ashton Barns Ashton Hall Estate
    Ashton With Stodday
    LA2 0AJ Lancaster
    Lancashire
    পরিচালক
    2 Ashton Barns Ashton Hall Estate
    Ashton With Stodday
    LA2 0AJ Lancaster
    Lancashire
    EnglandBritishMarketing Director104226000001
    CAMPBELL, Rosalind Ilona
    6 Hawthorn Close
    WD17 4SB Watford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    6 Hawthorn Close
    WD17 4SB Watford
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant58191970001
    CARSON, Stephen
    74-78 Victoria Street
    AL1 3XH St Albans
    Charter Court
    Hertfordshire
    England
    পরিচালক
    74-78 Victoria Street
    AL1 3XH St Albans
    Charter Court
    Hertfordshire
    England
    United KingdomSouth AfricanDirector189560580001
    CHADA, Jaspal Singh
    9 Kiln Close
    Calvert
    MK18 2FD Buckingham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    9 Kiln Close
    Calvert
    MK18 2FD Buckingham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishMarketing Director100093770001
    CLARKE, Bendict Robert
    74-78 Victoria Street
    AL1 3XH St. Albans
    Charter Court
    Hertfordshire
    পরিচালক
    74-78 Victoria Street
    AL1 3XH St. Albans
    Charter Court
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector146695760001
    CONSTANDSE, Bart Jan
    Schimmelpennincklaan 2
    Eindhoven
    FOREIGN Netherlands 5631 An
    পরিচালক
    Schimmelpennincklaan 2
    Eindhoven
    FOREIGN Netherlands 5631 An
    DutchDirector65256850003
    CRABTREE, Richard Charles
    Victoria Street
    AL1 3XH St. Albans
    Charter Court 74-78
    Hertfordshire
    England
    পরিচালক
    Victoria Street
    AL1 3XH St. Albans
    Charter Court 74-78
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritishSales Director162988270001
    DARWENT, Robert
    52 Hasker Street
    SW3 2LQ London
    পরিচালক
    52 Hasker Street
    SW3 2LQ London
    BritishInvestor72764480004
    DESTE, Ian Howard
    74-78 Victoria Street
    AL1 3XH St Albans
    Charter Court
    Hertfordshire
    Uk
    পরিচালক
    74-78 Victoria Street
    AL1 3XH St Albans
    Charter Court
    Hertfordshire
    Uk
    United KingdomBritishDirector119811540001
    DICKINSON, Thomas Alfred
    Waters Edge Shore Road
    Caldy
    CH48 2JL Wirral
    Merseyside
    পরিচালক
    Waters Edge Shore Road
    Caldy
    CH48 2JL Wirral
    Merseyside
    BritishDirector59410590001
    DUBERY, Marc
    Alvington Cottage
    61 Wray Park Road
    RH2 0EQ Reigate
    Surrey
    পরিচালক
    Alvington Cottage
    61 Wray Park Road
    RH2 0EQ Reigate
    Surrey
    BritishSales Director110304580001
    EDMANS, James
    Belgravia House 27 Devonshire Park
    RG2 7DX Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    Belgravia House 27 Devonshire Park
    RG2 7DX Reading
    Berkshire
    BritishDirector56567560002
    EDWARDS, Gareth William James
    1 The Paddock
    Little Heath Road Christleton
    CH3 7AJ Chester
    পরিচালক
    1 The Paddock
    Little Heath Road Christleton
    CH3 7AJ Chester
    United KingdomBritishDirector48936990001
    FIELD, Nicholas Peter
    Victoria Street
    AL1 3XH St. Albans
    Charter Court 74-78
    Hertfordshire
    England
    পরিচালক
    Victoria Street
    AL1 3XH St. Albans
    Charter Court 74-78
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishCeo186940600002
    FIELD, Nick
    74-78 Victoria Street
    AL1 3XH St Albans
    Charter Court
    Hertfordshire
    England
    পরিচালক
    74-78 Victoria Street
    AL1 3XH St Albans
    Charter Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishCompany Director162723120001
    GATFIELD, Jonathan Edward
    2 Bovingdon Heights
    SL7 2JS Marlow
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    2 Bovingdon Heights
    SL7 2JS Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritishOperations Director200797110002
    GREEN, James Alexander
    94 Churchway
    Haddenham
    HP17 8DT Aylesbury
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    94 Churchway
    Haddenham
    HP17 8DT Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director127488000001

    FOX'S BURTON'S COMPANIES (FBC) UK LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Fox's Burton's Company (Fbc) Uk Limited
    Victoria Street
    AL1 3XH St. Albans
    74-78
    England
    ২৭ অক্টো, ২০২৩
    Victoria Street
    AL1 3XH St. Albans
    74-78
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Company Limited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানEngland And Wales
    নিবন্ধন নম্বর08772230
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    Burton's Foods (Holdings) Limited
    Victoria Street
    AL1 3XH St. Albans
    74-78
    Herts
    United Kingdom
    ২১ জুন, ২০২১
    Victoria Street
    AL1 3XH St. Albans
    74-78
    Herts
    United Kingdom
    হ্যাঁ
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    আইনি কর্তৃপক্ষEngland & Wales
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    Giovanni Ferrero
    Chaussee De La Hulpe
    Watermael-Boltsfort
    187
    1170
    Belgium
    ২১ জুন, ২০২১
    Chaussee De La Hulpe
    Watermael-Boltsfort
    187
    1170
    Belgium
    না
    জাতীয়তা: Italian
    বাসস্থানের দেশ: Belgium
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তি একটি প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ ব্যায় করার অধিকার রাখেন বা কার্যত ব্যায় করেন, যেটি আইন অনুযায়ী একটি আইনগত ব্যক্তি নয়; এবং সেই প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ (তাদের এধারনের অধিকারবলে) কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    Ontario Teachers Pension Plan Board
    Yonge Street
    Toronto
    12th Floor 5650
    Canada
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Yonge Street
    Toronto
    12th Floor 5650
    Canada
    হ্যাঁ
    আইনি ফর্মPension Scheme
    আইনি কর্তৃপক্ষTeachers Pension Act
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    FOX'S BURTON'S COMPANIES (FBC) UK LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ মে, ২০২০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জুন, ২০২০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ জুন, ২০২০একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১৪ জুল, ২০২১একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ২০১৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ফেব, ২০১৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Burton's Foods Pension Scheme Trustees Limited as Trustee of the Burton's Foods Pension Scheme
    ব্যবসায়
    • ০৮ ফেব, ২০১৯একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১৪ জুল, ২০২১একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ২০১৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ফেব, ২০১৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The subjects at bankhead crossway south, edinburgh registered in the land register of scotland under title number MID9327.
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited (as Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০৮ ফেব, ২০১৭একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১৪ জুল, ২০২১একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০১৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ২০১৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ২৩ ডিসে, ২০১৬একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১৪ জুল, ২০২১একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ নভে, ২০১৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ নভে, ২০১৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land – see clause 3.1(a) of the charge, which creates a fixed charge by way of legal mortgage over each property set out in schedule 2 to the charge:. Property description nature of title title number. Land and buildings on the north east side of devonshire road, blackpool, lancashire FY3 7AN. Freehold LA756251. Land and buildings at llantarnam road, llantarnam, cwmbran NP44 3YL. Freehold CYM12966 and. WA2863. Property at charter court, 74-78 victoria street, st albans AL1 3XH. Leasehold HD475103. And clause 3.1(b) of the charge, which creates a fixed charge in any right, title or interest over real property (as defined in the charge) which the company subsequently acquires.. Intellectual property – see clause 3.8 of the charge, which creates a fixed charge over all intellectual property rights (as defined in the charge). Including the specified intellectual property set out in schedule 6 to the charge:. Category proprietor country class(es) status filing date app. No. Reg. No. File no.. Words and colour device burton’s foods limited african intellectual property organization (oapi) 30 registered 12 april 2012 3201201049 70943 121765.oa.01. Word and device burton’s foods limited australia 30 registered 12 december 1972 264304 264304 84114. words burton’s foods limited australia 30 registered-wo 06 march 2012 1110885 1110885 121767.au.01. , for more details please refer to the charge.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ১৫ নভে, ২০১৬একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১২ ডিসে, ২০১৮সম্পত্তির একটি অংশ বা উদ্যোগ মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং আর চার্জের অংশ নয় (MR05)
    • ১৪ জুল, ২০২১একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ ফেব, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    34 bankhead place, edinburgh t/no MID9327. Notification of addition to or amendment of charge.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bnp Paribas London Branch
    ব্যবসায়
    • ০৭ ফেব, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১১ নভে, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ জানু, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জানু, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a land and buildings on the north east side of devonshire road, blackpool, lancashire t/no LA756251. F/h property k/a land and buildings at llantarnum road, llantarnum, cwmbran t/no's CYM12966 and WA2863. F/h property k/a factory premises at pasture road, moreton, wirral, merseyside t/no's MS440456 and MS468307. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.. Notification of addition to or amendment of charge.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bnp Paribas London Branch (In Its Capacity as Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ২৪ জানু, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১১ নভে, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Confirmatory debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ অক্টো, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Burtons foods limited f/h land and buildings on the north east side od devonshire road blackpool t/no LA756251 burtons foods limited f/h factory premises at pasture road moreton wirral merseyside t/no MS440456 and MS468307 burton foods limited f/h land and buildings at llantarnam road llantarnam cwmbran t/no WA2863 and CYM12966 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Canadian Imperial Bank of Commerce London Branch
    ব্যবসায়
    • ২০ অক্টো, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৩ জানু, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Standard security
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ আগ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ অক্টো, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The area of ground lying to the south of bankhead crossway south edinburgh extending to 5.17 hectares t/no. MID9327.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch as Security Agent
    ব্যবসায়
    • ২১ অক্টো, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৮ জানু, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ নভে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ নভে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsbbp re burtons foods LTD and numbered 0490933 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ নভে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ ফেব, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 30 april 2007 and
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ এপ্রি, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and whole the area of ground lying to the south of bankhead crossway south edinburgh extending to 5.17 hectares or thereby t/no MID9327.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch as Security Agent
    ব্যবসায়
    • ১৭ মে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ জানু, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ এপ্রি, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ এপ্রি, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    For details of property charged please refer to form 395 and all land, investments, plant and machinery, credit balances, book debts etc., insurances, other contracts, intellectual property, goodwill and floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch (The Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ২৬ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ জানু, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A trade marks and patents charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The burton's foods patents, the burton's foods trade marks, the burton's foods trade mark applications, the burton's foods registered design and any goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credit Suisse as Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ২১ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental legal mortgage supplemental to a legal mortgage dated 31 august 2001 and
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জানু, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings at pasture road moreton wirral merseyside CH46 8SE part t/no MS398671. Assigns all of its right title and interest to in and under all present and future agreements, contracts, deeds,licences, undertakings etc. rental income, disposal proceeds and insurance policies.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credit Suisse First Boston
    ব্যবসায়
    • ০৬ জানু, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ আগ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ সেপ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All obligations and liabilities due or to become due from the company (formerly known as the horizon biscuit company limited) to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to the senior financing documents and the mezzanine financing documents (both terms as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (I) vicarage lane,lancashire; t/nos la 36921,la 829001,la 55881,la 425728,la 883229; (ii) land at leacroft rd,risley, washington,cheshire; ch 317034 and (iii) land at newport rd,llantarnam,cwmbran,wales; wa 2863; the proceeds of sale thereof and all buildings,trade/other fixtures thereon. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credit Suisse First Boston
    ব্যবসায়
    • ১৩ সেপ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ সেপ, ২০০৬বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২০ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security created by the company (formerly known as the horizon biscuit company) to the chargee presented for registration in scotland on 20TH september 2001
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ আগ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ সেপ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All "secured obligations" from the company to the chargee as defined in a guarantee and debenture dated 29TH january 2001
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Area extending to 12 acres and 86 decimal or 100TH parts of an acre lying to the south of bankhead crossway south edinburgh. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credit Suisse First Boston
    ব্যবসায়
    • ২৬ সেপ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জানু, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to the senior financing documents and the mezzanine financing documents (both as defined) (including the charge)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credit Suisse First Boston
    ব্যবসায়
    • ০৭ ফেব, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ সেপ, ২০০৬বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২০ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Trade marks and patents charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জানু, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to the senior financing documents and the mezzanine financing documents (both as defined) (including the charge)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company with full guarantee charged by way of first fixed charge in favour or the security trustee all the charged property (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credit Suisse First Boston as Agent and Trustee for the Secured Parties (SE Curity Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০৭ ফেব, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ সেপ, ২০০৬বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২০ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১০ আগ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company and/or each obligor company (as defined) to the chargee and/or the finance parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chase Manhattan International Limited Acting as Security Agent for the Finance Parties Pursuantto the Facilities Agreement
    ব্যবসায়
    • ২৬ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ ডিসে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0