JACKSON CONSTRUCTION LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামJACKSON CONSTRUCTION LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02094054
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    JACKSON CONSTRUCTION LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    JACKSON CONSTRUCTION LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Eighty Six
    86 Sandyhill Lane
    IP3 0NA Ipswich
    Suffolk
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    JACKSON CONSTRUCTION LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    JACKSON GROUP PROPERTIES 11 LIMITED০৪ ডিসে, ১৯৮৭০৪ ডিসে, ১৯৮৭
    CAPITAL AIR POWER LIMITED২৫ মার্চ, ১৯৮৭২৫ মার্চ, ১৯৮৭
    FORGEDENE LIMITED২৮ জানু, ১৯৮৭২৮ জানু, ১৯৮৭

    JACKSON CONSTRUCTION LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০১৫

    JACKSON CONSTRUCTION LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ৩১ আগ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Helen Gaye Cowing এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৬ জুন, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Paul Martin Cossell-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২০ মে, ২০১৬ তারিখে Mr Mark Stockton-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ মে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৪ মে, ২০১৬

    ২৪ মে, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    ২৯ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Samuel David Lawther এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২০ মে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Mark Stockton-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩০ জুন, ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ০১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে Mrs Helen Gaye Cowing-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Helen Gaye Cowing-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jonathan Charles Bennett Houlton এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ মে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৫ মে, ২০১৫

    ০৫ মে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ মে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৬ মে, ২০১৪

    ০৬ মে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ মে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD04

    ০৩ এপ্রি, ২০১৩ তারিখে Mr Jonathan Charles Bennett Houlton-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৩ এপ্রি, ২০১৩ তারিখে Jared Stephen Philip Cranney-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH03

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা C/O C/O Interior Services Group Plc Aldgate House 33 Aldgate High Street London EC3N 1AG United Kingdom থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ জুন, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    JACKSON CONSTRUCTION LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CRANNEY, Jared Stephen Philip
    c/o Isg Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    England
    সচিব
    c/o Isg Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    England
    British74806700006
    COSSELL, Paul Martin
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    England
    পরিচালক
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    England
    EnglandBritishDirector64007780003
    STOCKTON, Mark
    Aldgate House
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    C/O Isg Plc
    United Kingdom
    পরিচালক
    Aldgate House
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    C/O Isg Plc
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant152719980001
    PAYNE, Lorraine Grace
    2 Huntington Crescent
    Headingley
    LS16 5RT Leeds
    সচিব
    2 Huntington Crescent
    Headingley
    LS16 5RT Leeds
    British52221890003
    PRATT, Cyril Harry
    33 Briar Hill
    Woolpit
    IP30 9SD Bury St Edmunds
    Suffolk
    সচিব
    33 Briar Hill
    Woolpit
    IP30 9SD Bury St Edmunds
    Suffolk
    British8832470001
    ANDREWS, Peter John
    Church Farm Church Lane
    Earl Soham
    IP13 7SD Woodbridge
    Suffolk
    পরিচালক
    Church Farm Church Lane
    Earl Soham
    IP13 7SD Woodbridge
    Suffolk
    BritishDirector10441500003
    BEST, David Martin
    34 Vicarage Meadows
    WF14 9JL Mirfield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    34 Vicarage Meadows
    WF14 9JL Mirfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishAccountant47892490001
    BLAKE, Martin Graham
    23 Winston Avenue
    IP4 3LS Ipswich
    Suffolk
    পরিচালক
    23 Winston Avenue
    IP4 3LS Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritishDirector85938450002
    BRAMWELL, David Matthew
    Woodlands 2a Woodland Rise
    WF2 9DL Wakefield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Woodlands 2a Woodland Rise
    WF2 9DL Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector4250980001
    BRIERLEY, Philip
    Warren House The Ridge
    Linton
    LS22 4HJ Wetherby
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Warren House The Ridge
    Linton
    LS22 4HJ Wetherby
    West Yorkshire
    BritishDirector54808010001
    CHILTON, Albert Edmund
    1 Garfield Close
    IP11 7PX Felixstowe
    Suffolk
    পরিচালক
    1 Garfield Close
    IP11 7PX Felixstowe
    Suffolk
    BritishDirector6236180002
    CLARKE, Bernard Francis
    Jackson House
    86 Sandyhill Lane
    IP3 0NA Ipswich
    Suffolk
    পরিচালক
    Jackson House
    86 Sandyhill Lane
    IP3 0NA Ipswich
    Suffolk
    United KingdomBritishDirector69383800001
    COWING, Helen Gaye
    Aldgate House
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    C/O Isg Plc
    United Kingdom
    পরিচালক
    Aldgate House
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    C/O Isg Plc
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector180279040001
    CRAGG, Graham Stephen
    19 Leconfield Garth
    Follifoot
    HG3 1NF Harrogate
    North Yorkshire
    পরিচালক
    19 Leconfield Garth
    Follifoot
    HG3 1NF Harrogate
    North Yorkshire
    BritishChartered Surveyor63770050002
    FRYER, Peter Kenneth
    4 Hope Crescent
    Melton
    IP12 1SJ Woodbridge
    Suffolk
    পরিচালক
    4 Hope Crescent
    Melton
    IP12 1SJ Woodbridge
    Suffolk
    OtherCompany Director79955580001
    HOULTON, Jonathan Charles Bennett
    c/o Isg Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    England
    পরিচালক
    c/o Isg Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    England
    United KingdomBritishCompany Director70905760002
    JACKSON, Frank
    Orchard House
    IP12 1AS Woodbridge
    Suffolk
    পরিচালক
    Orchard House
    IP12 1AS Woodbridge
    Suffolk
    BritishDirector10015550001
    JONES, Richard James
    Stonegarth
    Beech Lane
    HG3 1AN Spofforth
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Stonegarth
    Beech Lane
    HG3 1AN Spofforth
    West Yorkshire
    BritishDirector78917370001
    LAWTHER, Samuel David
    c/o Isg Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    United Kingdom
    পরিচালক
    c/o Isg Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector154579210001

    JACKSON CONSTRUCTION LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ সেপ, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ অক্টো, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the funders on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১১ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ অক্টো, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জানু, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জানু, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a st george's house ipswich which is described as land and buildings at the junction of st matthew's street,berners st and st george's street ipswich t/n SK86826. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৫ জানু, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ নভে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জানু, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জানু, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All money and liabilities in any manner whatsoever due or to become due from the company to the senior lenders,mezzanine lenders,investor lenders and working capital bank under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ১০ জানু, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ নভে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and trust debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ অক্টো, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ অক্টো, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company or any of them to the trustee and or the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Agent and Trustee for Thebeneficiaries (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ০৯ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ নভে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ মে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৫ মে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ মে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ মে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/Hold property known as taber place crittall rd,witham; t/no EX419178. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৪ মে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ মে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ মে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/Hold property known as land/blds at the junctions of st mathew's st,berners street and st george's st,ipswich; t/no SK86826. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৪ মে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ মে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ মে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/Hold property known as land/blds lying to the north of queensdale close ipswich; t/no SK27843. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৪ মে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of assignment of rental income
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ নভে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ডিসে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a legal charge dated 28 november 1996
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rents and other payments due at any time under the leases of st georges house st georges street ipswich and/or taber place critall road witham essex and or land and buildings lying to the north of queensdale close ipswich suffolk.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Kredietbank N V
    ব্যবসায়
    • ১৭ ডিসে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ নভে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and buildings at the junctions of st matthew street berners street and st georges street ipswich (otherwise k/a st georges house) t/n: SK86826; f/h property situate at and k/a taber place crittall road witham essex t/n: EX419178; f/h property situate at and k/a land and buildings lying to the north of queensdale close ipswich suffolk t/n: SK27843. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Kreditbank Nv
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১১ সেপ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ সেপ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    13 bedford street, ipswich together with all buildings fixtures fixed plant and machinery thereon. Fixed charge all present and future book debts and other debts. And the goodwill of the business (if any).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ সেপ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ নভে, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জানু, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Inc heritable property & assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ জানু, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ নভে, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0