DIXON MOTORS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামDIXON MOTORS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02097071
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    DIXON MOTORS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7415) /

    DIXON MOTORS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Bdo Stoy Hayward Llp
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    DIXON MOTORS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    DIXON MOTORS PLC.২৬ মে, ১৯৯৩২৬ মে, ১৯৯৩
    PLATEAU MINING PLC২১ সেপ, ১৯৮৯২১ সেপ, ১৯৮৯
    PLATEAU MINING FINANCE LIMITED৩০ জানু, ১৯৮৯৩০ জানু, ১৯৮৯
    ROBERTSON MINING FINANCE LIMITED২৬ ফেব, ১৯৮৭২৬ ফেব, ১৯৮৭
    TOMAGOLD LIMITED০৫ ফেব, ১৯৮৭০৫ ফেব, ১৯৮৭

    DIXON MOTORS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৫

    DIXON MOTORS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ১৯ জানু, ২০১১ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    8 পৃষ্ঠা2.24B

    ১৯ জানু, ২০১১ তারিখে প্রশাসন থেকে দ্রবণে স্থানান্তরের নোটিশ

    8 পৃষ্ঠা2.35B

    ২৫ জুল, ২০১০ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    10 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠা2.31B

    ২৫ জানু, ২০১০ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    8 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    2 পৃষ্ঠা2.31B

    ২৫ জুল, ২০০৯ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    7 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা2.31B

    ২৫ জুল, ২০০৮ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    7 পৃষ্ঠা2.24B

    দেউলিয়া আদালতের আদেশ

    Court order insolvency:1. It is ordered the Administration be extended until midnight on 26 July 2009 pursuant to paragraph 76(2)(a) of Schedule B1 of the Insolvency Act 1986. 2. the costs of the Application be treated as an expense of the Administration.
    1 পৃষ্ঠাLIQ MISC OC

    ২৬ জানু, ২০০৯ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    6 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    7 পৃষ্ঠা2.31B

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা2.31B

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    7 পৃষ্ঠা2.31B

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 2.14B

    4 পৃষ্ঠা2.16B

    ২৫ জুল, ২০০৮ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    5 পৃষ্ঠা2.24B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    24 পৃষ্ঠা2.17B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    DIXON MOTORS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CULLEN, Stephen Bernard
    14 Haweswater Drive
    Middleton
    M24 5GX Manchester
    Lancashire
    পরিচালক
    14 Haweswater Drive
    Middleton
    M24 5GX Manchester
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director112339610001
    HAINES, John Edward
    Green Hill
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Hampshire
    পরিচালক
    Green Hill
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Hampshire
    BritishCompany Director106170840001
    HOBSON, Garry
    Four Winds
    Sugar Lane
    HP1 2RT Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Four Winds
    Sugar Lane
    HP1 2RT Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector96262330001
    BIRD, Colin
    1 Larchwood Glade
    GU15 3UW Camberley
    Surrey
    সচিব
    1 Larchwood Glade
    GU15 3UW Camberley
    Surrey
    British4358240001
    CARROLL, Richard John Trew
    5 The Court
    Loxwood
    RH14 0QP
    West Yorkshire
    সচিব
    5 The Court
    Loxwood
    RH14 0QP
    West Yorkshire
    British26648720001
    CUNNINGHAM, Angela Mary
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    সচিব
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    British62801910001
    CUTHBERTSON, Garry
    8 Croft Park
    HU14 3JX North Ferriby
    North Humberside
    সচিব
    8 Croft Park
    HU14 3JX North Ferriby
    North Humberside
    BritishCompany Director54577250002
    DIXON, Paul William Henry
    Mill Estate Hotham
    YO43 4UG Hotham
    Yorkshire
    সচিব
    Mill Estate Hotham
    YO43 4UG Hotham
    Yorkshire
    BritishDirector153357310001
    FRANKS, Ian Charles
    89 Swanland Road
    HU13 0NS Hessle
    North Humberside
    সচিব
    89 Swanland Road
    HU13 0NS Hessle
    North Humberside
    British71584820001
    KENT, Christopher Kenneth
    Stable Cottage
    Upton Road Clevelode
    WR13 6PB Malvern
    Worcestershire
    সচিব
    Stable Cottage
    Upton Road Clevelode
    WR13 6PB Malvern
    Worcestershire
    BritishCompany Director109770840004
    LEWIS, Derek John
    48 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    সচিব
    48 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    British34423910002
    BAILEY, Robert Andrew
    103 Wootton Road
    Kempson
    MK43 9BJ Bedford
    Bedfordshire
    পরিচালক
    103 Wootton Road
    Kempson
    MK43 9BJ Bedford
    Bedfordshire
    BritishBanker104106520001
    BAKER, Richard
    1 Parish Ghyll Road
    LS29 9NG Ilkley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    1 Parish Ghyll Road
    LS29 9NG Ilkley
    West Yorkshire
    BritishDirector79420360001
    BEDFORD, Paul
    9 Preston Lane
    Great Preston
    LS26 8AT Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    9 Preston Lane
    Great Preston
    LS26 8AT Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director110773690001
    BIRD, Colin
    1 Larchwood Glade
    GU15 3UW Camberley
    Surrey
    পরিচালক
    1 Larchwood Glade
    GU15 3UW Camberley
    Surrey
    United KingdomBritishMining Engineer4358240001
    BOOTH, Thomas John
    Rose Farmhouse
    Seaton Ross
    YO42 4LZ York
    পরিচালক
    Rose Farmhouse
    Seaton Ross
    YO42 4LZ York
    BritishManaging Director104299390001
    CARNELL, Martyn Dennis
    The Old Vicarage Church Street
    Everton
    DN10 5BB Doncaster
    South Yorkshire
    পরিচালক
    The Old Vicarage Church Street
    Everton
    DN10 5BB Doncaster
    South Yorkshire
    BritishDirector11237330001
    CIULLO, Salvatore
    Oakwood
    Birhwood Dell
    BN4 6SY Doncaster
    South Yorkshire
    পরিচালক
    Oakwood
    Birhwood Dell
    BN4 6SY Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritishManaging Director126363580001
    CLIBBENS, Nigel Timothy John
    40a Pennington Road
    Southborough
    TN4 0SL Tunbridge Wells
    Kent
    পরিচালক
    40a Pennington Road
    Southborough
    TN4 0SL Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant49141230004
    CUTHBERTSON, Garry
    8 Croft Park
    HU14 3JX North Ferriby
    North Humberside
    পরিচালক
    8 Croft Park
    HU14 3JX North Ferriby
    North Humberside
    EnglandBritishCompany Director54577250002
    DICKINSON, Alan Peter
    Brock's Ghyll Best Beech Hill
    TN5 6JR Wadhurst
    East Sussex
    পরিচালক
    Brock's Ghyll Best Beech Hill
    TN5 6JR Wadhurst
    East Sussex
    EnglandBritishBank Official190869750001
    DIXON, Paul William Henry
    Mill Estate Hotham
    YO43 4UG Hotham
    Yorkshire
    পরিচালক
    Mill Estate Hotham
    YO43 4UG Hotham
    Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director153357310001
    DIXON, Simon Timothy
    Main Street
    Hotham
    YO43 4UF York
    St Oswaleds House
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Main Street
    Hotham
    YO43 4UF York
    St Oswaleds House
    North Yorkshire
    United KingdomBritishOperations Director101291990002
    DRIVER, James Donald
    Littlefield Dedswell Drive
    West Clandon
    GU4 7TQ Guildford
    Surrey
    পরিচালক
    Littlefield Dedswell Drive
    West Clandon
    GU4 7TQ Guildford
    Surrey
    BritishManagement Consultant1896670001
    ELTON, Christopher Peter
    70b High Street
    Hook
    DN14 5NY Goole
    East Yorkshire
    পরিচালক
    70b High Street
    Hook
    DN14 5NY Goole
    East Yorkshire
    EnglandBritishAccounting47237180002
    FLINT, Eion Arthur Mcmorran
    Manor Farm
    Main Street Levisham
    YO18 7NL Pickering
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Manor Farm
    Main Street Levisham
    YO18 7NL Pickering
    North Yorkshire
    BritishCompany Director56760630003
    GIFFIN, David Ronald
    21 Barnton Gardens
    EH4 6AE Edinburgh
    Midlothian
    পরিচালক
    21 Barnton Gardens
    EH4 6AE Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishBank Official65377070001
    HICKEY, David Martin James
    Cambridge Road
    Wimbledon
    SW20 0SH London
    4
    পরিচালক
    Cambridge Road
    Wimbledon
    SW20 0SH London
    4
    EnglandBritishMerchant Banker70653790001
    KENT, Christopher Kenneth
    Stable Cottage
    Upton Road Clevelode
    WR13 6PB Malvern
    Worcestershire
    পরিচালক
    Stable Cottage
    Upton Road Clevelode
    WR13 6PB Malvern
    Worcestershire
    BritishCompany Director109770840004
    LONG, Martin Paul
    Chartwell Farm
    Mapleton Road
    TN16 1PS Westerham
    Kent
    পরিচালক
    Chartwell Farm
    Mapleton Road
    TN16 1PS Westerham
    Kent
    EnglandBritishInsurance Executive111427490001
    LYNDE, David
    Alder House Laburnum Farm Close
    Hessay
    YO26 8LG York
    পরিচালক
    Alder House Laburnum Farm Close
    Hessay
    YO26 8LG York
    GbrBritishCompany Director112339870001
    MARROW, Paul
    The Shutters 2 Nightjar Close
    Ewshot
    GU10 5TQ Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    The Shutters 2 Nightjar Close
    Ewshot
    GU10 5TQ Farnham
    Surrey
    United KingdomBritishBanker85771600001
    PARKINSON, Alan Donald
    8 Pinchwell View
    Wickersley
    S66 1FP Rotherham
    South Yorkshire
    পরিচালক
    8 Pinchwell View
    Wickersley
    S66 1FP Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritishBanker104435050001
    PEPPARD, Anthony Edward
    63 Green Lane
    Paddock Wood
    TN12 6BF Tonbridge
    Kent
    পরিচালক
    63 Green Lane
    Paddock Wood
    TN12 6BF Tonbridge
    Kent
    IrishManager76520410001
    RAMANATHAN, Shankar
    Mowson Hollow
    Worrall
    S35 0AD Sheffield
    3
    South Yorkshire
    পরিচালক
    Mowson Hollow
    Worrall
    S35 0AD Sheffield
    3
    South Yorkshire
    EnglandBritishBanker125663610001

    DIXON MOTORS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Fixed and floating security document
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent (As Agent and Trustee for the Secured Parties)
    ব্যবসায়
    • ২২ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Third party charge of securities(UK)
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জুল, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from grimsby malting retails development company limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any stocks shares bonds warrants or securities (certificated or uncertificated) together with all income derived from and rights attaching to the same. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ জুল, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental debenture between the company certain of the company's subsidiaries and the royal bank of scotland PLC as security agent and trustee for the lenders (as defined)
    তৈরি করা হয়েছে ০১ ফেব, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ ফেব, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under each designated finance document (as defined) and on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and buildings on the south side of market street grimsby t/no: HS199863; f/h land k/a 271-291 bury new road and 8, 10 and 12 hilton street salford t/no: GM118716; f/h land k/a 206-206(a) great clowes street salford t/no: LA70372. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ ফেব, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ নভে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ নভে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee on any account whatsoever and under each designated finance document (as therein defined) except for any obligayion which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Agent and Trustee for the Lenders)
    ব্যবসায়
    • ২১ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture (as supplemented by a supplemental debenture dated 3RD november 1997)
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুল, ১৯৯৭
    অর্জিত হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ জানু, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee and/or each lender (as defined) under each designated finance document (as defined in the debenture)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    100 ordinary shares of £1 each in dixon vehicle management limited; 100 ordinary shares of £1 each in carnell motorcycles limited; 9,000 ordinary shares of 10P each in contract distribution services limited. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent and Trustee for the Lenders
    ব্যবসায়
    • ১৪ জানু, ১৯৯৮অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ০৬ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুল, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ আগ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee as security agent and trustee for the lenders (as therein defined) on any account whatsoever and under each designated finance document (as therein defined) except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first legal mortgage: f/h land and buildings on the south west side of bradford road birstall t/n WYK421359; f/h land on the south west side of courtney street kingston upon hull t/n HS171081; f/h land k/a imperial garage clarence street kingston upon hull t/n HS230527, for details of further property charged please refer to form M395. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ আগ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ আগ, ১৯৯৮বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৯ মার্চ, ১৯৯৯বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ০৬ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ মার্চ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The l/h property k/a premises at westgate lancashire t/n LA679164 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ মার্চ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ আগ, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জানু, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ ফেব, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a land at junction of market street and king edward street grimsby t/n HS28741,f/h land west of station road dewsbury t/n WYK442071,land south of rawcliffe road goole f/H. T/n HS169035 and/or the proceeds of sale thereof and various other properties as listed on schedule to form 395. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ ফেব, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ আগ, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ নভে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ নভে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H- land and buildings on the south west side of bradford road birstall batley west yorkshire t/n-WYK421359 and/or the proceeds of sale thereof and assigns the goodwill of the business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ নভে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ আগ, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ নভে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ নভে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ নভে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ আগ, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ এপ্রি, ১৯৯১
    অর্জিত হয়েছে ২৩ নভে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £46,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings on the north and south sides of south street,retford.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Esso Petroleum Company Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ১৯৯৫অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ৩০ আগ, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুন, ১৯৮৭
    অর্জিত হয়েছে ২৩ নভে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £68,772.18 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings on the north side and south side of south street,retford.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Esso Petroleum Company Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ১৯৯৫অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ৩০ আগ, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    DIXON MOTORS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৯ জানু, ২০১১প্রশাসন শেষ
    ২৬ জুল, ২০০৭প্রশাসন শুরু
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Francis Graham Newton
    Bdo Stoy Hayward Llp
    1 City Square
    LS1 2DP Leeds
    অভ্যাসকারী
    Bdo Stoy Hayward Llp
    1 City Square
    LS1 2DP Leeds
    James Joseph Bannon
    Bdo Stoy Hayward Llp
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    অভ্যাসকারী
    Bdo Stoy Hayward Llp
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Toby Scott Underwood
    Bdo Stoy Hayward Llp
    1 City Square
    LS1 2DP Leeds
    অভ্যাসকারী
    Bdo Stoy Hayward Llp
    1 City Square
    LS1 2DP Leeds

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0