CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02110320
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য ব্যবসা সহায়তা পরিষেবা কার্যক্রম ন.এ.সি. (82990) / প্রশাসনিক এবং সহায়ক পরিষেবা কার্যক্রম

    CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    RENTCO INTERNATIONAL LIMITED২৫ সেপ, ১৯৮৭২৫ সেপ, ১৯৮৭
    VISORHEAD LIMITED১৩ মার্চ, ১৯৮৭১৩ মার্চ, ১৯৮৭

    CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩০ জুন, ২০১৫
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩১ মার্চ, ২০১৬
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০১৪

    CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    8 পৃষ্ঠা4.71

    Neil Smith কে পরিচালক হিসাবে নিয়োগের জন্য দ্বিতীয় দাখিল

    6 পৃষ্ঠাRP04AP01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থান 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD02

    ২৫ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT থেকে 1 More London Place London SE1 2AFপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ৩১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে

    LRESSP

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    ০৫ ফেব, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে T I P Europe Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ ফেব, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে David Cakebread এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৫ ফেব, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Neil Campbell Smith-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ০৬ অক্টো, ২০১৬Clarification A second filed AP01 was registered on 06/10/2016

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ অক্টো, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৪ নভে, ২০১৫

    ০৪ নভে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP .1
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    শেয়ারের সাথে সংযুক্ত অধিকারের পরিবর্তনের বিবরণ

    2 পৃষ্ঠাSH10

    শেয়ার শ্রেণীর নাম বা পদবী পরিবর্তন

    2 পৃষ্ঠাSH08

    ০১ ডিসে, ২০১৪ তারিখে শেয়ার উপবিভাজন

    8 পৃষ্ঠাSH02

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01
    capital

    শেয়ারের অধিকার বা নাম পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES12
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    11,000,000 issued cumulative redeemable preference shares of £1 be sub-divided into 110,000,000 cumulative redeemable preference shares of £0.10 each 01/12/2014
    RES13

    legacy

    2 পৃষ্ঠাSH20

    ০৯ ডিসে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 0.10
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    2 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Reduction of share premium account to nil 01/12/2014
    RES13

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ অক্টো, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০১ ডিসে, ২০১৪

    ০১ ডিসে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 356,027,000
    SH01

    বিবিধ

    Section 519
    3 পৃষ্ঠাMISC

    অডিটরের পদত্যাগ

    3 পৃষ্ঠাAUD

    CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর7038430
    146358090001
    SMITH, Neil Campbell
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    পরিচালক
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director183029170001
    SWITHENBANK, Joseph Preston
    Rue Pillet Will
    75009 Paris
    2-4
    France
    পরিচালক
    Rue Pillet Will
    75009 Paris
    2-4
    France
    FranceUs CitizenFinance/Controllership183236480001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    সচিব
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    British61314280001
    PRICE, Philip Ian
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    সচিব
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    British75578650002
    SMITH, Nicholas Handran
    Flat 2
    19 Netherhall Gardens
    NW3 5RL Hampstead
    London
    সচিব
    Flat 2
    19 Netherhall Gardens
    NW3 5RL Hampstead
    London
    Australian50914130001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    কর্পোরেট সচিব
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    কর্পোরেট সচিব
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580002
    TRAF SHELF (NOMINEES) LIMITED
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    কর্পোরেট সচিব
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    50087010001
    BEADLE, Paul Laurence
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    পরিচালক
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United KingdomBritishEuropean Operations Director100238650001
    CAKEBREAD, David
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    পরিচালক
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    United KingdomBritishNone183172770001
    CAMFIELD, Ronald Frederick
    Nicholas House
    14 Creekview Road
    CM3 5GU South Woodham Ferrers
    Essex
    পরিচালক
    Nicholas House
    14 Creekview Road
    CM3 5GU South Woodham Ferrers
    Essex
    BritishCompany Director81395090001
    CHANDLER, Andrew Philip
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    পরিচালক
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    BritishFinance Director53832740001
    CITRON, Zachary Joseph
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    পরিচালক
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    BritishSolicitor91783950001
    CLARK, Roy Graham
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    পরিচালক
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    BritishTax Adviser65257100001
    CLUBB, Ian Mcmaster
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    BritishDirector3485960001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    পরিচালক
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    EnglandBritishSec/Sol61314280001
    FOSTER, Roy Garvin
    16 Thameside
    RG9 1BH Henley On Thames
    Oxfordshire
    পরিচালক
    16 Thameside
    RG9 1BH Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishDirector37099790001
    GOODWIN, Eric
    Brewers Wood Pondfield Lane
    Shorne
    DA12 3LD Gravesend
    Kent
    পরিচালক
    Brewers Wood Pondfield Lane
    Shorne
    DA12 3LD Gravesend
    Kent
    EnglandBritishCompany Director45623310001
    GOODWIN, Stephen Keith
    Tumblewood Cottage 23 Beacon Way
    SM7 1DZ Banstead
    Surrey
    পরিচালক
    Tumblewood Cottage 23 Beacon Way
    SM7 1DZ Banstead
    Surrey
    BritishAccountant5343520001
    GREEN, Pamela Anne
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    British38435990009
    HOWELL, David
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    পরিচালক
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant109591300001
    IRVING, Ian Richard
    3 Warrington Crescent
    Little Venice
    W9 1ED London
    পরিচালক
    3 Warrington Crescent
    Little Venice
    W9 1ED London
    EnglandBritishCompany Director41228040001
    MATTHEWS, Terence
    Flat 6
    Fleming House 20 Danvers Street Chel
    SW3 London
    পরিচালক
    Flat 6
    Fleming House 20 Danvers Street Chel
    SW3 London
    BritishSales & Marketing Director31419450002
    MONTAGUE, Robert Joel
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    BritishCompany Director65130630002
    OSBORNE, Richard Wallace Gollin Osborne
    5 Northfield Wall
    59 North Road Highgate
    N6 London
    পরিচালক
    5 Northfield Wall
    59 North Road Highgate
    N6 London
    AustralianDirector17452320001
    PALMER, Christopher Antony
    Church Farm
    East Woodhay
    RG20 0AL Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    Church Farm
    East Woodhay
    RG20 0AL Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Director4764800001
    RAINE, Richard Denby
    1 Acris Street
    SW18 2QT London
    পরিচালক
    1 Acris Street
    SW18 2QT London
    BritishAccountant50519950001
    RIEDIJK, Hans Arie
    Trompenburo Straat 10m
    1079 TX Amsterdam
    The Netherlands
    পরিচালক
    Trompenburo Straat 10m
    1079 TX Amsterdam
    The Netherlands
    DutchDirector57483360001
    SMITS, Robert Anthony
    Heemraadschapslaan 2
    1181 Vb
    Amstelveen
    পরিচালক
    Heemraadschapslaan 2
    1181 Vb
    Amstelveen
    DutchDirector54592350001
    STONE, Richard
    6 Birchways
    WA4 5DQ Appleton
    Cheshire
    পরিচালক
    6 Birchways
    WA4 5DQ Appleton
    Cheshire
    BritishAccountant75179060001
    THRASHER III, Barrie Holt
    Flat 10
    25 Queensgate Gardens
    SW7 5RR London
    পরিচালক
    Flat 10
    25 Queensgate Gardens
    SW7 5RR London
    AmericanCompany Director65472750001
    WILSON, Peter Samuel
    5 Thorn Close
    RG11 4SQ Wokingham
    Berkshire
    পরিচালক
    5 Thorn Close
    RG11 4SQ Wokingham
    Berkshire
    BritishDirector59565220001
    T I P EUROPE LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    কর্পোরেট পরিচালক
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    65164760003

    CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুল, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ জুল, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under, or pursuant to the credit agreement, the indenture, the notes, the company's bank guarantee, the company's noteholder guarantee, the new asset financing guarantees and the other secured documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.as Security Trustee for the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ৩০ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ মে, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Account charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মার্চ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ মার্চ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to an indemnity contained in a sale agreement dated 14TH december 1989 and this deed (as defined therein)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title and interest of the company in and to both of the company's accounts no: 76653161 and 7943407. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC Barclays Mercantile Limited and Barclays Mercantile Business Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ২৩ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ জুল, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মার্চ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a credit agreement dated 13TH february 1994 as amended on 15TH february 1994 and an agreement dated 15TH march 1994 (as defined) and any other related security documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.("the Security Trustee")as Security Trustee for Itself and for the Secured Parties (As Defined in the Debenture)
    ব্যবসায়
    • ২১ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ জুল, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ মে, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মে, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as agent and trustee for the banks and/ohe overdraft bank as defined in the deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Bank and Overdraft Bank
    ব্যবসায়
    • ২৬ মে, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ ডিসে, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ মে, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মে, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever agent and turstee for the banks and/or the overdroft bank as defired in the deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Banks and the Overdraft Bank
    ব্যবসায়
    • ২৬ মে, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ ডিসে, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ৩১ মার্চ, ২০১৬ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১৬ এপ্রি, ২০১৭ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    অভ্যাসকারী
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    অভ্যাসকারী
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0