LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামLE PAIN CROUSTILLANT LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02116902
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • পাউরুটি এবং তাজা পেস্ট্রি পণ্য এবং কেক উৎপাদন (10710) / উৎপাদন

    LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    PINGATE CATERING LIMITED৩০ মার্চ, ১৯৮৭৩০ মার্চ, ১৯৮৭

    LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১১

    LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৬ সেপ, ২০১২

    ২৬ সেপ, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,248
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ২০ এপ্রি, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Emmett Mcevoy-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২০ এপ্রি, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Antony David Smith এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৫ নভে, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Andrew Mcdonald-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৫ নভে, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Suzanne Elizabeth Wise এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    34 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01
    capital

    সিকিউরিটিজ বরাদ্দের রেজুলেশন

    RES10

    কোম্পানির উদ্দেশ্যের বিবৃতি

    2 পৃষ্ঠাCC04

    কোম্পানির আর্টিকেলগুলিতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCC02

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ জুল, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    ০১ জুল, ২০১১ তারিখে Ms Suzanne Elizabeth Wise-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ জুল, ২০১১ তারিখে Mr Simon Nicholas Wilbraham-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ০১ জুল, ২০১১ তারিখে Mr Andrew Michael Peeler-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Mr Antony David Smith-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Andrew Peeler এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ অক্টো, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Mr Simon Nicholas Wilbraham-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১২ নভে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    11 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Robert Lawson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    সচিব
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    MCDONALD, Andrew John
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    EnglandBritish164670820001
    MCEVOY, Emmett
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrish168590540001
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish125719290002
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    সচিব
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570002
    HARTREY, Patrick Mark
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    সচিব
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    British50340730004
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    সচিব
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    HOLLOWAY, David John
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    সচিব
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    British66183100001
    VANBERGEN, Charles Albert
    The White Cottage Childsbridge Lane
    Seal
    TN15 0BS Sevenoaks
    Kent
    সচিব
    The White Cottage Childsbridge Lane
    Seal
    TN15 0BS Sevenoaks
    Kent
    British7384900001
    WATERS, Paul Christopher
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    সচিব
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    British126327110002
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    সচিব
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British125719290002
    WOODMORE, Michael Brian
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    সচিব
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    British37177620001
    ALLNER, Andrew James
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    পরিচালক
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    British73003300001
    BARRY, Peter Nigel George
    Hall Farmhouse
    The Street
    NR16 1EZ Ashwellthorpe
    Norfolk
    পরিচালক
    Hall Farmhouse
    The Street
    NR16 1EZ Ashwellthorpe
    Norfolk
    EnglandBritish84886660001
    CARTER, Ian Paul
    2 Hedley Gardens
    Hedge End
    SO30 2WT Southampton
    Hampshire
    পরিচালক
    2 Hedley Gardens
    Hedge End
    SO30 2WT Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritish79314210001
    CHARTERIS, Derek William
    Belswains Lane
    HP3 9PT Hemel Hempstead
    111
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Belswains Lane
    HP3 9PT Hemel Hempstead
    111
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish136986090001
    CLARKE, Jonathan Michael Rushton
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    পরিচালক
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritish98818450001
    CROSSLEY, Nigel
    HP9
    পরিচালক
    HP9
    EnglandBritish145901880001
    DARA, Alireza
    23 Lynwood Road
    W5 1JQ London
    পরিচালক
    23 Lynwood Road
    W5 1JQ London
    United KingdomBritish22461240001
    DAVIES, Lyn Theodore
    Cheridene
    65 Bowham Avenue
    CF31 3PA Bridgend
    Mid Glamorgan
    পরিচালক
    Cheridene
    65 Bowham Avenue
    CF31 3PA Bridgend
    Mid Glamorgan
    British34304310003
    DUNCAN, Ian Alexander
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    পরিচালক
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    United KingdomBritish27300002
    FORREST, Keith Robert Mckenzie
    18 St Andrews Close
    Moreton On Lugg
    HR4 8DD Hereford
    Hereford & Worcester
    পরিচালক
    18 St Andrews Close
    Moreton On Lugg
    HR4 8DD Hereford
    Hereford & Worcester
    British45838740001
    HARRIS, Gareth Addison
    18 Painters Pightle
    Hook
    RG27 9SS Basingstoke
    Hampshire
    পরিচালক
    18 Painters Pightle
    Hook
    RG27 9SS Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritish152131210001
    HOLLOWAY, David John
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    পরিচালক
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish66183100001
    HOLROYD, Dean
    51 Grove Road
    SL4 1JD Windsor
    Berkshire
    পরিচালক
    51 Grove Road
    SL4 1JD Windsor
    Berkshire
    British64875220002
    HYDE, Trevor John
    158 Jerounds
    CM19 4HH Harlow
    Essex
    পরিচালক
    158 Jerounds
    CM19 4HH Harlow
    Essex
    British71827110001
    JONES, Martin William
    Rose Cottage
    Eathorpe
    CV33 9DE Leamington Spa
    Warwickshire
    পরিচালক
    Rose Cottage
    Eathorpe
    CV33 9DE Leamington Spa
    Warwickshire
    British26034610001
    LAWSON, Robert
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    পরিচালক
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    EnglandBritish99991140001
    MALPUS, John James
    Armitage House
    Armitage Road
    WS15 4AZ Armitage
    Staffordshire
    পরিচালক
    Armitage House
    Armitage Road
    WS15 4AZ Armitage
    Staffordshire
    British6799180003
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    পরিচালক
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    MURPHY, Thomas Jerome Peter
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British76945730001
    PANTER, Alan James, Mr.
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    পরিচালক
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    British114414690002
    PEELER, Andrew Michael
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish87359710001
    RELF, Russell Alan
    113 The Chase
    SS6 8QP Rayleigh
    Essex
    পরিচালক
    113 The Chase
    SS6 8QP Rayleigh
    Essex
    British59133030001
    RUDDICK, Ian William
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish98350001

    LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Borrower deed of charge between the chargors, the issuer, the working capital facility provider, the obligor account banks and the borrower security trustee (each as defined)
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    An amount equal to the borrower secured liabilities defined as all present and future obligations and liabilities (whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the borrower secured creditors (or any of them) under the transaction documents (or any of them) in connection with the protection preservation or enforcement of it's respective rights under the transaction documents for which any obligor is liable under the transaction documents on a full indemnity basis.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All property assets and other rights the subject of the security interests created in favour of the borrower security trustee pursuant to the borrower security documents. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Chase Manhattan Bank (As Borrower Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২০ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ সেপ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined)
    তৈরি করা হয়েছে ১১ সেপ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ সেপ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York (As "Security Agent")
    ব্যবসায়
    • ২৩ সেপ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ সেপ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ নভে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ নভে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £1,620,000 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1 x gouet automatic production line comprising 3 x make-up limited, 3 x sogen transfer conveyors, 3 x resting chambers and various other items and goods as listed on the form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lombard North Central PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ জুল, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ নভে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ নভে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £1,475,118.98 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Various chattels as specified in agreement no. 355-970448-14 dated 14TH november 1997 between the company and the chargee. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lombard North Central PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ জুল, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ মার্চ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £708,265 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First fixed charge over:- 1 x jackstone manufacturing line, including 3 spiral coolers, 3 spiral freezers with full interconnecting conveyor system, insulation and controls serial no: A193/14.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ২০ মার্চ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ জুল, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ মার্চ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £311,802 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1 x abb power factor corrector serial no.C861407/1-5, 32 x artofex stainless steel equipment, 4 x chilled water fan coil units. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ মার্চ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ জুল, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £1,460,285.64 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The items as set out on the schedule attached to form 395 together with all books manuals handbooks technical data drawings schedules and other documentation (or any amendments to them). Some of the items are one GA18-7.5 Air compressor, 2 40' dry van containers stainless steel, one ADV20-60 and one ADV16-66 condenser and one ADS2-26 and one ADS1-26 dry air cooler. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ জুল, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জুল, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £444,520.70 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Various chattels as specified in form 395. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lombard North Central PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule attached to form 395 being:- one new deltamatic DV50 water meter serial number 6497, one new sprint 300 ri mixer serial number 24999, one new generator serial number CO62137/01. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Forward Trust Limited
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ মে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ মে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £936,432 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the mortgage
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Various goods comprising 1 x new gouet product line (line number 3). see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lombard North Central PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ মে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০২ অক্টো, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ অক্টো, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £518,495.13 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this chattel mortgage
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1 x microsearch metal detect sys serial number-73734A. 1 x microsearch metal detect sys serial number 73734B. 2 x caseweighers with cintex serial number 2509A.. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lombard North Central PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ আগ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £312,406 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Various items of plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bowmaker Limited
    ব্যবসায়
    • ০২ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ জুল, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Credit agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ আগ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ সেপ, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £40486.30 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title & interest in & to all sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Close Brothers Limited
    ব্যবসায়
    • ০৭ সেপ, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Collateral debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ নভে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ নভে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the london superstores limited on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I Group PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ নভে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ অক্টো, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ নভে, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ নভে, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১১ আগ, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0