AURORA PROPCO 1 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামAURORA PROPCO 1 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02140182
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    AURORA PROPCO 1 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • হাসপাতালের কার্যক্রম (86101) / মানব স্বাস্থ্য এবং সামাজিক কাজ কার্যক্রম

    AURORA PROPCO 1 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    AURORA PROPCO 1 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ASPEN HEALTHCARE LIMITED১১ মে, ১৯৯৮১১ মে, ১৯৯৮
    PARACELSUS U.K. LIMITED২৯ সেপ, ১৯৮৭২৯ সেপ, ১৯৮৭
    IRONMARSH FINANCE LIMITED১১ জুন, ১৯৮৭১১ জুন, ১৯৮৭

    AURORA PROPCO 1 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৪

    AURORA PROPCO 1 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    12 পৃষ্ঠাLIQ13

    ১১ জুল, ২০১৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    12 পৃষ্ঠাLIQ03

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থান 11 2nd Floor 11 Old Jewry London EC2R 8DU এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা 11 2nd Floor 11 Old Jewry London EC2R 8DU এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD02

    ২৬ জুল, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 2nd Floor 11 Old Jewry London EC2R 8DU থেকে Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TRপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    5 পৃষ্ঠাLIQ01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১২ জুল, ২০১৭ তারিখে

    LRESSP

    ০১ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    ০১ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Timothy Luke Trott-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০১ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Roland Mark Deller এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৫ নভে, ২০১৬ তারিখে Bedell Trust Uk Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH04

    চার্জ 021401820018 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 021401820017 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩১ ডিসে, ২০১৫ থেকে ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Keith Russell Crockett এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ এপ্রি, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৩ এপ্রি, ২০১৬

    ১৩ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 15,474,015
    SH01

    ০১ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে Mr Roland Mark Deller-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    28 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ এপ্রি, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    22 পৃষ্ঠাAR01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ০৮ ডিসে, ২০১৫Replacement This document Replaces the AR01 registered on 27/05/2015 as it was not properly delivered

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 2nd Floor 11 Old Jewry London EC2R 8DU এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD04

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা Squire Sanders (Uk) Llp (Ref: Csu) Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR England থেকে C/O Bedell Trust Uk Limited 11 Old Jewry London EC2R 8DU এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ এপ্রি, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৭ মে, ২০১৫

    ২৭ মে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 15,474,015
    SH01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ০৮ ডিসে, ২০১৫Replaced A Replacement AR01 is registered on 08/12/2015

    ৩০ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Bedell Trust Uk Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP04

    AURORA PROPCO 1 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    OCORIAN (UK) LIMITED
    11 Old Jewry
    EC2R 8DU London
    2nd Floor
    England
    কর্পোরেট সচিব
    11 Old Jewry
    EC2R 8DU London
    2nd Floor
    England
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর5534412
    113583560003
    GOODEY, John Anthony
    London Wall
    EC2Y 5AL London
    125
    England
    পরিচালক
    London Wall
    EC2Y 5AL London
    125
    England
    LondonBritishCompany Director141633880001
    TROTT, Timothy Luke
    Old Jewry
    Second Floor
    EC2R 8DU London
    11
    England
    পরিচালক
    Old Jewry
    Second Floor
    EC2R 8DU London
    11
    England
    United KingdomBritishDirector169607470002
    SHIELS, Desmond Anthony
    2 Phillimore Gardens
    NW10 3LH London
    সচিব
    2 Phillimore Gardens
    NW10 3LH London
    Irish81743210001
    WHITEHAND, Neil William
    8 Victoria Road
    BR7 6DF Chislehurst
    Kent
    সচিব
    8 Victoria Road
    BR7 6DF Chislehurst
    Kent
    British57971500001
    WOTHERSPOON, John Mcmurdo
    8 Kinsella Gardens
    Camp Road
    SW19 4UB London
    সচিব
    8 Kinsella Gardens
    Camp Road
    SW19 4UB London
    British117396590001
    EPS SECRETARIES LIMITED
    London Wall
    EC2Y 5AL London
    125
    England
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    London Wall
    EC2Y 5AL London
    125
    England
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর2231995
    900023740001
    CROCKETT, Keith Russell
    London Wall
    EC2Y 5AL London
    125
    England
    পরিচালক
    London Wall
    EC2Y 5AL London
    125
    England
    United KingdomCanadianCompany Director179532870001
    DELLER, Roland Mark
    11 Old Jewry
    EC2R 8DU London
    2nd Floor
    পরিচালক
    11 Old Jewry
    EC2R 8DU London
    2nd Floor
    United KingdomBritishCompany Director189231770001
    HOFMANN, Richard Dieter
    Kings Ride House Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    Kings Ride House Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Berkshire
    GermanFinance46020770001
    KOPSER, Mark Anthony
    5308 Tennington Park
    Dallas
    Texas 75287
    Usa
    পরিচালক
    5308 Tennington Park
    Dallas
    Texas 75287
    Usa
    United StatesAmericanChief Fncl Officer45716290006
    KRUKEMEYER, Hartmut, Professor Dr
    Bergstrasse 49
    D4500 Osnabruck
    Germany
    পরিচালক
    Bergstrasse 49
    D4500 Osnabruck
    Germany
    GermanMedical Practitioner34964860001
    KRUKEMEYER, Manfred Georg, Dr
    9 Physic Place
    Royal Hospital Road
    SW3 4HQ London
    পরিচালক
    9 Physic Place
    Royal Hospital Road
    SW3 4HQ London
    GermanMedical Practitioner35196780002
    LEWSEY, David
    Church Meadows
    Bocking
    CM7 5SL Braintree
    20
    Essex
    পরিচালক
    Church Meadows
    Bocking
    CM7 5SL Braintree
    20
    Essex
    United KingdomBritishFinance Director128950040001
    MASFURRULL, Gabriel
    Trestorres 28
    Barcelona
    08017
    Spain
    পরিচালক
    Trestorres 28
    Barcelona
    08017
    Spain
    SpanishCeo73967600001
    MCCANN, Patricia
    Gabriel House
    26 Islington Green
    N1 8DU London
    Apartment 6
    United Kingdom
    পরিচালক
    Gabriel House
    26 Islington Green
    N1 8DU London
    Apartment 6
    United Kingdom
    BritishCheif Exec81819010002
    MCNEILLY, Robert Henry, Dr
    Forge House
    Coleshill
    HP7 0LR Amersham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Forge House
    Coleshill
    HP7 0LR Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish Northern IrelandCompany Director10813190001
    MURRAY, Alan Adams
    3 Otterburn Park
    EH14 1JX Edinburgh
    Midlothian
    পরিচালক
    3 Otterburn Park
    EH14 1JX Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishBanker559270001
    PEREZ, Jose
    White Gables Hay Green Lane
    Hook End
    CM15 0NT Brentwood
    Essex
    পরিচালক
    White Gables Hay Green Lane
    Hook End
    CM15 0NT Brentwood
    Essex
    United KingdomSpanishDirector Of Operations3847600001
    SCHLEWING, Ulrich, Dr
    Bergstrasse 49
    D4500 Osnabruck
    Germany
    পরিচালক
    Bergstrasse 49
    D4500 Osnabruck
    Germany
    GermanManaging Director12645080001
    SHIELS, Desmond Anthony
    2 Phillimore Gardens
    NW10 3LH London
    পরিচালক
    2 Phillimore Gardens
    NW10 3LH London
    United KingdomIrishChief Executive81743210001
    STEEN, Donald Ellsworth
    5715 Thames Ct
    Dallas
    Texas
    75252
    Usa
    পরিচালক
    5715 Thames Ct
    Dallas
    Texas
    75252
    Usa
    UsaAmericanChairman69513430001
    TOBIN, Julian Jacob
    18 Eton Villas
    Hampstead
    NW3 4SG London
    পরিচালক
    18 Eton Villas
    Hampstead
    NW3 4SG London
    BritishSolicitor2071150001
    WOTHERSPOON, John Mcmurdo
    8 Kinsella Gardens
    Camp Road
    SW19 4UB London
    পরিচালক
    8 Kinsella Gardens
    Camp Road
    SW19 4UB London
    BritishManaging Director117396590001

    AURORA PROPCO 1 LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Welltower Inc
    Dorr Street
    Toledo
    4500
    Ohio 43615-4040
    United States
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Dorr Street
    Toledo
    4500
    Ohio 43615-4040
    United States
    না
    আইনি ফর্মCompany
    নিবন্ধিত দেশUsa
    আইনি কর্তৃপক্ষUs
    নিবন্ধিত স্থানNyse
    নিবন্ধন নম্বর766704
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    AURORA PROPCO 1 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ অক্টো, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ অক্টো, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and whole that plot of ground shown edged red on the plan annexex to the instrument, situated at 42 colinton road, edinburgh and which forms part and portion of the subjects under t/no MID85883.
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent
    ব্যবসায়
    • ২৩ অক্টো, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১৬ জানু, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ অক্টো, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    None.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent
    ব্যবসায়
    • ১৭ অক্টো, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১৬ জানু, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ এপ্রি, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land being 53 parkside wimbledon common t/no SY135685, f/h land being 13 seymour road london t/no SY118149, f/h land being the land lying to the east of parkside wimbldon t/no TGL111982 for details of further property charged please refer to form MG01 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ এপ্রি, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১১ সেপ, ২০১৩সম্পত্তির একটি অংশ বা উদ্যোগ চার্জ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে (MR05)
    • ১১ মার্চ, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ মার্চ, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ এপ্রি, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a buckhurst hill ambulance station knighton lane buckhurst hill t/n EX578732 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ এপ্রি, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ এপ্রি, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ এপ্রি, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ মে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০১ মে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ এপ্রি, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ নভে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ নভে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    As continuing security, first fixed charge the interest in the registered land being f/h land k/a 13 seymour road, wimbledon, london t/no SY118149. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৮ নভে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ এপ্রি, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ এপ্রি, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ এপ্রি, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined) including the guarantee and debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    For property details see schedule to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ এপ্রি, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ এপ্রি, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ নভে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ নভে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to any of the financing documents (including for the avoidance of doubt the guarantee and debenture (the secured obligations))
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৬ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ এপ্রি, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ মার্চ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from aspen healthcare holdings limited as the issuer of £15 million subordinated secured stepped coupon loan notes due 2008 to the holders of those notes (the noteholders) and all liabilities of the company to the chargee as agent and trustee of the noteholders (the agent) under the guarantee and debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land k/a holly house hospital high road buckhurst hill t/no EX193541 25 high road buckhurst hill t/no EX508759 land lying to the east of parkside wimbledon t/no TGL111982 and 53 parkside wimbledon t/no SY135685. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Electra Fleming Limited
    ব্যবসায়
    • ১১ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ এপ্রি, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ মার্চ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any of the "financing documents" (as defined) and the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1). holly house hospital high road buckhurst hill t/no;-EX193541 2). f/h land k/a 25 high road buckhurst hill t/no;-EX508759 3). f/h land lying to the east of parkside wimbledon t/no;-TGL111982 4).f/h 53 parkside wimbledon t/no;-SY135685 together with all buildings fixtures and proceeds of sale thereof fixed charge in any immovable property belonging to the company proceeds od sale and building and fixtires thereof all plant machinery and other equipment of the chargor all credit balances stock in trade goodwill share income and all intellectual property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The British Linen Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ১২ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ এপ্রি, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of assignment
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জুন, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জুন, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the loan agreement (as therein defined) and under or pursuant to the assignment
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title benefit and interest in and to the deed dated 13/6/97 (as defined on form M395) and all sums payable thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The British Linen Bank Limitedas Agent and Trustee for the Secured Parties (As Therein Defined)
    ব্যবসায়
    • ১৭ জুন, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ মে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ অক্টো, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ নভে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the secured parties (as defined therein) on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a land lying to the east of parkside, wimbledon t/no. TGL111982 and any proceeds of any insurance thereof and all buildings and fixtures thereon. A fixed charge on the benefit of all licences held in connection with any business carried on at the property. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The British Linen Bank Limited (The Agent)
    ব্যবসায়
    • ০৩ নভে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ মে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ মার্চ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific charge over its goodwill and the benefit of any licences and all patents patent applications inventions trde-marks trade names registered designs copyrights know-how and any other intellectual property rights. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of a loan agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The British Linen Bank as Agent and Trustee for Itself and the Banks (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ১৪ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ মে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ মার্চ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H westfield 53 parkside wimbledon common merton london t/n sy 135685 and/or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ মার্চ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H holly house hospital high road buckhurst hill essex t/n ex 193541 and/or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ নভে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from thecompany to the chargees under the terms of a loan agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See 395 17 l 5/12 for full details. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The British Linen Bank Limited as Agent and Trustee for Itself and Thebanks (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ০৪ ডিসে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ এপ্রি, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Lewit agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ আগ, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ সেপ, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under there us of a loan agreement datedthe companys whole right title and inter
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Est present & future in and to I) the orginal securities etc (for full details please see form 395 ref: M93/9 see/ln).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Tue Royal Bank of Canada
    ব্যবসায়
    • ০৮ সেপ, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১২ জানু, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    AURORA PROPCO 1 LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১২ জুল, ২০১৭ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১৮ মে, ২০১৯ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    অভ্যাসকারী
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Ian Harvey Dean
    Athene Place,66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    অভ্যাসকারী
    Athene Place,66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0