JOMED IMAGING LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামJOMED IMAGING LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02144826
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    JOMED IMAGING LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7487) /

    JOMED IMAGING LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Southbank House
    Black Prince Road
    SE1 7SJ London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    JOMED IMAGING LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    INTRAVASCULAR RESEARCH LIMITED১৪ মার্চ, ১৯৯০১৪ মার্চ, ১৯৯০
    CIRCULATION RESEARCH LIMITED০৩ জুল, ১৯৮৭০৩ জুল, ১৯৮৭

    JOMED IMAGING LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৬

    JOMED IMAGING LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    8 পৃষ্ঠা363s

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৪ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    8 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    1 পৃষ্ঠা244

    legacy

    8 পৃষ্ঠা363s

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৩ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা244

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০১ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০২ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    6 পৃষ্ঠা363s

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০০ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    47 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের স্মারকলিপি এবং/অথবা নিবন্ধের রেজুলেশন

    RES01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    47 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের স্মারকলিপি এবং/অথবা নিবন্ধের রেজুলেশন

    RES01

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা403b

    JOMED IMAGING LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    LUSSIER, Michel Edgar
    14 Place Morichar 1060
    FOREIGN Brussels
    Belgium
    সচিব
    14 Place Morichar 1060
    FOREIGN Brussels
    Belgium
    CanadianBiomedical Engineer94852200001
    JANSEN, Willem Gerard
    60 Vuurdoornstraat
    Vaassen
    8171 Xj
    Holland
    পরিচালক
    60 Vuurdoornstraat
    Vaassen
    8171 Xj
    Holland
    DutchFinance Director83229810001
    LUSSIER, Michel Edgar
    14 Place Morichar 1060
    FOREIGN Brussels
    Belgium
    পরিচালক
    14 Place Morichar 1060
    FOREIGN Brussels
    Belgium
    CanadianBiomedical Engineer94852200001
    BOUCHER, Charles Andre
    52 Dartmouth Road
    NW2 4EX London
    সচিব
    52 Dartmouth Road
    NW2 4EX London
    British2323080001
    DICKINSON, Robert Julian, Dr
    51 West Hill Road
    SW18 1LE London
    সচিব
    51 West Hill Road
    SW18 1LE London
    BritishTechnical Director39409840002
    HUTCHINS, Elizabeth Catherine
    Berries 35 Chalfont Road
    Seer Green
    HP9 2QP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    সচিব
    Berries 35 Chalfont Road
    Seer Green
    HP9 2QP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishAccountant99986130001
    JANSEN, Willem Gerard
    60 Vuurdoornstraat
    Vaassen
    8171 Xj
    Holland
    সচিব
    60 Vuurdoornstraat
    Vaassen
    8171 Xj
    Holland
    DutchFinance Director83229810001
    JONES, Roger John
    12 Ebborn Square
    Lower Earley
    RG6 4JT Reading
    সচিব
    12 Ebborn Square
    Lower Earley
    RG6 4JT Reading
    British62469800001
    MCDONALD, Alastair Hugh, Doctor
    16 Woodway Crescent
    HA1 2NQ Harrow
    Middlesex
    সচিব
    16 Woodway Crescent
    HA1 2NQ Harrow
    Middlesex
    British25887090001
    PETERSSON, Curt Jurgen Per
    Apelrydsgatan 5
    FOREIGN Malmo
    216 23
    Sweden
    সচিব
    Apelrydsgatan 5
    FOREIGN Malmo
    216 23
    Sweden
    SwedishCeo90931190001
    ASHDOWN, Peter William
    29 Menelik Road
    NW2 3RJ London
    পরিচালক
    29 Menelik Road
    NW2 3RJ London
    BritishConsultant4914620001
    BEALE, Christopher Ronald
    Pingasson
    Weston Patrick
    RG25 2NX Basingstoke
    Hampshire
    পরিচালক
    Pingasson
    Weston Patrick
    RG25 2NX Basingstoke
    Hampshire
    BritishManagement & Executive Consult39628760001
    BOND, Paul Graham
    Amon Ikedayama East B
    5-6-23 Higashi Gotanda
    FOREIGN Shinagowa-Ku
    Tokyo
    পরিচালক
    Amon Ikedayama East B
    5-6-23 Higashi Gotanda
    FOREIGN Shinagowa-Ku
    Tokyo
    BritishDirector50839540001
    BOUCHER, Charles Andre
    52 Dartmouth Road
    NW2 4EX London
    পরিচালক
    52 Dartmouth Road
    NW2 4EX London
    United KingdomBritishConsultant2323080001
    BRYANT, Greyham
    18 Wimborne Avenue
    UB2 4HB Norwood Green
    Middlesex
    পরিচালক
    18 Wimborne Avenue
    UB2 4HB Norwood Green
    Middlesex
    BritishUniversity Professor11540540001
    CHEESMAN, David
    The Pines Plantation Road
    LU7 3HU Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    পরিচালক
    The Pines Plantation Road
    LU7 3HU Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    EnglandBritishInvestment Management3182720001
    DICKINSON, Robert Julian, Dr
    51 West Hill Road
    SW18 1LE London
    পরিচালক
    51 West Hill Road
    SW18 1LE London
    United KingdomBritishTechnical Director39409840002
    FALESCHINI, Richard J
    9520 Nw 42nd Court
    Coral Springs 33065
    Florida
    Us
    পরিচালক
    9520 Nw 42nd Court
    Coral Springs 33065
    Florida
    Us
    AmericanVice President25887130002
    HARPER, Paul Bernard
    Nugent Road
    Surrey Research Park
    GU2 7AF Guildford
    10
    Surrey
    পরিচালক
    Nugent Road
    Surrey Research Park
    GU2 7AF Guildford
    10
    Surrey
    United KingdomBritishGeneral Manager107653400001
    KITNEY, Richard Ian, Professor
    78 Waldemar Avenue
    SW6 5LU London
    পরিচালক
    78 Waldemar Avenue
    SW6 5LU London
    EnglandBritishScientist11540510002
    MARDON, John Gale
    2 The Briars
    SW15 6UB London
    পরিচালক
    2 The Briars
    SW15 6UB London
    BritishCompany Director & Consultant1451100001
    MCDONALD, Alastair Hugh, Doctor
    16 Woodway Crescent
    HA1 2NQ Harrow
    Middlesex
    পরিচালক
    16 Woodway Crescent
    HA1 2NQ Harrow
    Middlesex
    BritishMedical Practitioner25887090001
    MCFARLANE, George Macdonald
    65 High Street
    Standlake
    OX8 7RH Witney
    Oxfordshire
    পরিচালক
    65 High Street
    Standlake
    OX8 7RH Witney
    Oxfordshire
    BritishFinance Director49673260001
    MONKS, Philip John
    Vickersmedical
    Manor Way
    GU22 9JX Old Woking
    Surrey
    পরিচালক
    Vickersmedical
    Manor Way
    GU22 9JX Old Woking
    Surrey
    BritishCeo60220150001
    MONKS, Philip John
    Sint Pauluslaan 111
    B-1981 Vossem-Tervuren
    Belgium
    পরিচালক
    Sint Pauluslaan 111
    B-1981 Vossem-Tervuren
    Belgium
    BritishVice President Europe32286210001
    MORRISON, William Stuart
    29 Prospect Place
    Ashton-On-Ribble
    PR2 1DL Preston
    Lancashire
    পরিচালক
    29 Prospect Place
    Ashton-On-Ribble
    PR2 1DL Preston
    Lancashire
    BritishCompany Director37064540001
    PERCIVAL, Philip Charles
    10 Holland Park Court
    Holland Park Gardens
    W11 3TH London
    পরিচালক
    10 Holland Park Court
    Holland Park Gardens
    W11 3TH London
    EnglandBritishVenture Capital Invester121804230001
    PETERS, Tor Leif
    Rheinhalde-Strabe 80
    Schaffhausen
    8200
    Switzerland
    পরিচালক
    Rheinhalde-Strabe 80
    Schaffhausen
    8200
    Switzerland
    SwedishChief Executive Officer68612150002
    PETERSSON, Curt Jurgen Per
    Apelrydsgatan 5
    FOREIGN Malmo
    216 23
    Sweden
    পরিচালক
    Apelrydsgatan 5
    FOREIGN Malmo
    216 23
    Sweden
    SwedishCeo90931190001
    PRENTICE, Hamish Murray
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    পরিচালক
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    BritishCompany Executive23060180001
    RATERING, Egbert
    Isvogellaan 11
    B-1640 Rhode St Genese
    Belgium
    পরিচালক
    Isvogellaan 11
    B-1640 Rhode St Genese
    Belgium
    DutchVice President-Europe32286200001
    ROTHMAN, Martin Terry, Professor
    81 Anchorage Point
    42 Cuba Street
    E14 8NF London
    পরিচালক
    81 Anchorage Point
    42 Cuba Street
    E14 8NF London
    BritishCardiologist65449260001
    SIMKINS, Raymond
    5 17 4 Higashi Gotanda
    Shinagawa Ku Tokyo 141
    Japan
    পরিচালক
    5 17 4 Higashi Gotanda
    Shinagawa Ku Tokyo 141
    Japan
    BritishExecutive49673450001
    STRAUGHAN, Keith, Doctor
    29 Chiltern Park Avenue
    HP4 1EU Berkhamsted
    Hertfordshire
    পরিচালক
    29 Chiltern Park Avenue
    HP4 1EU Berkhamsted
    Hertfordshire
    BritishUniversity Lecturer11540530001
    WALSH, Julia Maria, Dr
    Wind In The Willows
    Moorhouse Farm Lane Lower Road
    UB8 5EN Higher Denham
    Bucks
    পরিচালক
    Wind In The Willows
    Moorhouse Farm Lane Lower Road
    UB8 5EN Higher Denham
    Bucks
    UkBritishCorporate Recovery Specialist47545490001

    JOMED IMAGING LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ জুন, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জুন, ১৯৯৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee at 9TH june 1999 or at any time or times after 9TH june 1999 pursuant to the further investment agreement dated 25TH november 1998,the letter dated 23RD march 1998 and the further investment agreement dated 9TH june 1999
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ ডিসে, ২০০৩বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    Deed of trust and agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ অক্টো, ১৯৯৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee , cordis europa nv and getz bros co limited pursuant to a subscription, loan and option agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All moneys resulting from the enforcement of a deed of assignment of intellectual property rights dated 30TH june 1993. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I PLC (For Itself and as Trustee for 3I Group PLC, Cordis Europa Nv and Getz Bros Co Limited)
    ব্যবসায়
    • ০৩ অক্টো, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Deed of trust and agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ অক্টো, ১৯৯৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee , cordis europa nv and getz bros co limited pursuant to a subscription, loan and option agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All moneys resulting from the enforcement of a debenture dated 30TH june 1993. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I PLC (For Itself and as Trustee for 3I Group PLC, Cordis Europa Nv and Getz Bros Co Limited)
    ব্যবসায়
    • ০৩ অক্টো, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জানু, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Cordis Europa Nv
    ব্যবসায়
    • ১০ জানু, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ নভে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of trust and agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জানু, ১৯৯৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to 3I group PLC pursuant to an investment offer dated 13TH december 1995
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All moneys resulting from the enforcement of a deed of assignment of intellectual property rights dated 30TH june 1993. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I PLC for Itself and as Trustee for 3I Group PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ জানু, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জানু, ১৯৯৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I Group PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ জানু, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ ডিসে, ২০০৩বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    Deed of trust and agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জানু, ১৯৯৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an investment offer dated 13TH december 1995
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All moneys resulting from the enforcement of a deed of assignment dated 30/6/93. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I PLC (For Itself and as Trustee for 3I Group PLC)
    ব্যবসায়
    • ০৪ জানু, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ ডিসে, ১৯৯৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I Group PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ ডিসে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ ডিসে, ২০০৩বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    Deed of variation
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under leases dated 1ST february 1991 and 3RD march 1992
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All sums of money from time to time deposited by the company with the chargee as the rent deposit in accordance with the terms of the deed as security for the performance of the company's obligations under a lease dated 1/2/91 in respect of premises k/a unit 12 alice court 116 putney bridge road london SW15 and in respect of the company's obligations under a lease dated 3/3/92 in respect of premises k/a unit 11 alice court 116 putney bridge road london SW15. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Mark Charles Batten and John Francis Soden
    ব্যবসায়
    • ১৭ ফেব, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ নভে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জুল, ১৯৯৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself & as agent & trustee for 3I group PLC, charterhouse second venture fund management limited and cordis europa nv (together the investors) and the investors under an agreement dated 30/6/93
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ ডিসে, ২০০৩বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    Deed of assignment
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জুল, ১৯৯৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself & as agent & trustee for £I group PLC, charterhouse second venture fund management limited and cordis europa nv (together the investors) & the investors under an agreement dated 30/6/93
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title & interest in & to the intellectual property rights including all licences all right title & interest in & to the trade marks. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ ডিসে, ২০০৩বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ মার্চ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ মার্চ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 3RD march 1992
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All sums of money which from time to time are to be deposited by the company with the chargee as the rent deposit.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Mark Charles Batten and John Francis Soden
    ব্যবসায়
    • ০৪ মার্চ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ নভে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of deposit
    তৈরি করা হয়েছে ০১ ফেব, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The tenants obligations under the terms of the lease dated 1/2/91
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Deposit of the sum of £22,250.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Alice Court Limited
    ব্যবসায়
    • ০৬ ফেব, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৬ নভে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0