EUROPEAN BUSINESS NETWORK LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামEUROPEAN BUSINESS NETWORK LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02146363
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    EUROPEAN BUSINESS NETWORK LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    EUROPEAN BUSINESS NETWORK LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Media House
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Hampshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    EUROPEAN BUSINESS NETWORK LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১২

    EUROPEAN BUSINESS NETWORK LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    ২৯ নভে, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Robert Charles Gale এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    legacy

    97 পৃষ্ঠাPARENT_ACC

    legacy

    1 পৃষ্ঠাAGREEMENT1

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাGUARANTEE1

    ১৪ মার্চ, ২০১৩ তারিখে Caroline Bernadette Elizabeth Withers-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ৩১ ডিসে, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Joanne Christine Tillbrook এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩১ ডিসে, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Caroline Bernadette Elizabeth Withers-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ নভে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৬ নভে, ২০১২

    ১৬ নভে, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ নভে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    ১৬ সেপ, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Joanne Christine Tillbrook-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৬ সেপ, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Joanne Christine Tillbrook এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৬ সেপ, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Joanne Christine Tillbrook-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৬ সেপ, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Joanne Christine Tillbrook এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৬ সেপ, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Joanne Christine Tillbrook-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৬ সেপ, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Robert Mario Mackenzie এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ নভে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Virgin Media Secretaries Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Virgin Media Directors Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    EUROPEAN BUSINESS NETWORK LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    সচিব
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    151024970001
    WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    পরিচালক
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish140137570002
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    সচিব
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    LAVER, John Michael
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    সচিব
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    British8207040001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    কর্পোরেট সচিব
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BURDICK, Charles James
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    পরিচালক
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    British-American52311710004
    COOK, Stephen Sands
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    পরিচালক
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    British73000530008
    DELAHUNTY, Joseph John
    6 Thornhill Way
    TW17 0AW Shepperton
    Middlesex
    পরিচালক
    6 Thornhill Way
    TW17 0AW Shepperton
    Middlesex
    British2077360001
    GALE, Robert Charles
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    পরিচালক
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish96956740001
    GALTEAU, Philippe Xavier
    10 Rue De La Cure
    75016 Paris
    France
    পরিচালক
    10 Rue De La Cure
    75016 Paris
    France
    French34577670001
    HULL, Victoria Mary, Sol
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    পরিচালক
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    British77283810001
    ILLSLEY, Anthony Kim
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    পরিচালক
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish43836970001
    JOHNSON, Edward Neil
    Tolcarne
    Stonebridge Fields Shalford
    GU4 8EE Guildford
    Surrey
    পরিচালক
    Tolcarne
    Stonebridge Fields Shalford
    GU4 8EE Guildford
    Surrey
    British37444720001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    পরিচালক
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    MILLER, David John
    1 Asmara Road
    NW2 3SS London
    পরিচালক
    1 Asmara Road
    NW2 3SS London
    United KingdomBritish152304230002
    NEARY, Christopher John
    4 Effingham Place
    KT24 5JT Effingham
    Surrey
    পরিচালক
    4 Effingham Place
    KT24 5JT Effingham
    Surrey
    British47022960003
    SCHAEFFER, Thomas Rebadow
    Mill Run Mill Lane
    White Lilies Island
    SL4 5JH Windsor
    Berkshire
    পরিচালক
    Mill Run Mill Lane
    White Lilies Island
    SL4 5JH Windsor
    Berkshire
    Usa27263600001
    SMITH, Neil Reynolds
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    British79956240002
    STENHAM, Anthony William Paul
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    পরিচালক
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    British8281170001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    পরিচালক
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    পরিচালক
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    পরিচালক
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    VAN VALKENBURG, David Raynor
    Flat 6
    35/37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    পরিচালক
    Flat 6
    35/37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    American53941940001
    VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    কর্পোরেট পরিচালক
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107430002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    কর্পোরেট পরিচালক
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002

    EUROPEAN BUSINESS NETWORK LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জানু, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    Each and every liability which the company may on or after 31ST december 1997 have to the chargee (whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the operative documents (including the debenture) and pay to the chargee when due and payable every sum (of principal interest or otherwise) on or after 31ST december 1997 owing due or incurred by the company to the chargee in respect of any such liabilities (the secured obligations)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed charge the real property being all estates and other interests in freehold leasehold and other immovable property and all buildings trade and other fixtures, the tangible movable property being all headend equipment all switch equipment all wire cable computer software, all goodwill and rights by way of first floating charge the whole of the undertaking and assets (for full details please refer to form 395 and continuation sheets). See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Robert Fleming Leasing (Number 4) Limited
    ব্যবসায়
    • ২০ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জানু, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    Each and every liability which the company may on or after 31ST december 1997 have to the chargee (whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the operative documents (including the debenture) and pay to the chargee when due and payable every sum (of principal interest or otherwise) on or after 31ST december 1997 owing due or incurred by the company to the chargee in respect of any such liabilities (the secured obligations)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed charge the real property being all estates and other interests in freehold leasehold and other immovable property and all buildings trade and other fixtures, the tangible movable property being all headend equipment all switch equipment all wire cable computer software, all goodwill and rights by way of first floating charge the whole of the undertaking and assets (for full details please refer to form 395 and continuation sheets). See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lombard Commercial Limited
    ব্যবসায়
    • ২০ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জানু, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    Each and every liability which the company may on or after 31ST december 1997 have to the chargee (whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the operative documents (including the debenture) and pay to the chargee when due and payable every sum (of principal interest or otherwise) on or after 31ST december 1997 owing due or incurred by the company to the chargee in respect of any such liabilities (the secured obligations)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed charge the real property being all estates and other interests in freehold leasehold and other immovable property and all buildings trade and other fixtures, the tangible movable property being all headend equipment all switch equipment all wire cable computer software, all goodwill and rights by way of first floating charge the whole of the undertaking and assets (for full details please refer to form 395 and continuation sheets). See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Natwest Specialist Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ২০ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জানু, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    Each and every liability which the company may on or after 31ST december 1997 have to the chargee (whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the operative documents (including the debenture) and pay to the chargee when due and payable every sum (of principal interest or otherwise) on or after 31ST december 1997 owing due or incurred by the company to the chargee in respect of any such liabilities (the secured obligations)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed charge the real property being all estates and other interests in freehold leasehold and other immovable property and all buildings trade and other fixtures, the tangible movable property being all headend equipment all switch equipment all wire cable computer software, all goodwill and rights by way of first floating charge the whole of the undertaking and assets (for full details please refer to form 395 and continuation sheets). See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Natwest Specialist Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ২০ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জানু, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for the beneficiaries) on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents (including the debenture)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over all undertaking property and assets present and future including goodwill intellectual property benefit of licences all earnings all debts shares and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0