MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামMVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02157370
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED২৯ ফেব, ১৯৮৮২৯ ফেব, ১৯৮৮
    BURGINHALL 194 LIMITED২৬ আগ, ১৯৮৭২৬ আগ, ১৯৮৭

    MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ এপ্রি, ২০১৮

    MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    6 পৃষ্ঠাLIQ13

    ০৩ মে, ২০১৯ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Herts HP2 4NW থেকে 15 Canada Square London E14 5GLপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ০৩ এপ্রি, ২০১৯ তারিখে

    LRESSP

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    5 পৃষ্ঠাLIQ01

    মাইক্রো এন্ট্রিটি হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩০ এপ্রি, ২০১৯ থেকে ৩১ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ০৬ আগ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ian Michael Noble এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৬ আগ, ২০১৮ তারিখে Mr Stephen James Callaghan-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ৩১ মে, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    মাইক্রো এন্ট্রিটি হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ মে, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ০৬ ডিসে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ian Michael Noble-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৬ ডিসে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Andrew Coll এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১০ অক্টো, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Stephen James Callaghan-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১০ অক্টো, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে David John Meaden এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০১ জুন, ২০১৬

    ০১ জুন, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৯ জুন, ২০১৫

    ২৯ জুন, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ২২ ডিসে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে David John Meaden-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২২ ডিসে, ২০১৪ তারিখে সচিব হিসাবে Pinsent Masons Secretarial Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP04

    ২২ ডিসে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে John Robert Stier এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর2318923
    76579530001
    CALLAGHAN, Stephen James
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish201347710052
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    সচিব
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    সচিব
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    NUNN, Carol Jayne
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    সচিব
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British101872040001
    RICHARDSON, John David
    Peoplebuilding 2 Peoplebuilding
    Estate Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Herts
    সচিব
    Peoplebuilding 2 Peoplebuilding
    Estate Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Herts
    British128558470001
    SCHENCK, Daniel William
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    সচিব
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Usa181204960001
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    সচিব
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    সচিব
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    YOUNG, Victor John
    Willow Bank Willow View Close
    SN16 0BZ Malmesbury
    Wiltshire
    সচিব
    Willow Bank Willow View Close
    SN16 0BZ Malmesbury
    Wiltshire
    British23808250002
    AL-SALEH, Adel Bedry
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican165900220001
    CHESTER, Andrew, Dr
    71 Downs Park East
    Westbury Park
    BS6 7QG Bristol
    Avon
    পরিচালক
    71 Downs Park East
    Westbury Park
    BS6 7QG Bristol
    Avon
    British36723830001
    COLL, Andrew
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish237260100001
    GREENLAND, Martyn Geoffrey
    11 York Road
    GL20 5HX Tewkesbury
    Gloucestershire
    পরিচালক
    11 York Road
    GL20 5HX Tewkesbury
    Gloucestershire
    British45440250001
    MACHIN, Brian Roy
    Drylaw Cottage
    Cote Drive
    BS9 3UP Bristol
    পরিচালক
    Drylaw Cottage
    Cote Drive
    BS9 3UP Bristol
    British8982230003
    MARKHAM, Richard John
    Castle Cote 3 Ivywell Road
    Sneyd Park
    BS9 1NX Bristol
    Avon
    পরিচালক
    Castle Cote 3 Ivywell Road
    Sneyd Park
    BS9 1NX Bristol
    Avon
    United KingdomBritish35544120002
    MEADEN, David John
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish193740420001
    NOBLE, Ian Michael
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish199843940001
    RUDD, Jeremy George Winterton
    Manor Farm
    Lower Lemington
    GL56 9NP Moreton In Marsh
    পরিচালক
    Manor Farm
    Lower Lemington
    GL56 9NP Moreton In Marsh
    United KingdomBritish74891640002
    STIER, John Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish78901530003
    STONE, Christopher Michael Renwick
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish66955690003
    VENN, Jon
    North Hill Cottage East Dundry Lane
    Dundry
    BS41 8NJ Bristol
    পরিচালক
    North Hill Cottage East Dundry Lane
    Dundry
    BS41 8NJ Bristol
    British15778460001

    MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland And Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom (England And Wales)
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর03033447
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ সেপ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ অক্টো, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ অক্টো, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of variation
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ মে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All the obligations undertakings and liabilities of the company to the chargee (as defined in a charge dated 21ST october 1988)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Pursuant to clause 2 if the charge (as amended by the deed of variation) all right title & interest in the local authority agreement & in the settlement agreement but without limitation the benefit of all powers & remedies but excluding all amounts payable thereunder in respect of vat. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental deed (amending the charge dated 20TH july 1988 and the supplemental charge dated 18TH november 1991)
    তৈরি করা হয়েছে ১২ মে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ মে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    And amending the charge dated 20TH july 1988 (the "general clc charge") and the supplemental charge dated 18TH november 1991 (the "supplemental charge")
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (I) first fixed charge all clc's right title and interest in each of the deposits (ii) first fixed charge all clc's right title and interest in the digital agreement (iii) first fixed charge all clc's right title and interest in the csl agreement (iv) floating charge all undertaking property assets and rights....... See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ মে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ মে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ মে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee in connection with the advance (as defined therein) under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title and interest in the local authority agreement including the benefit of all powers and remedies for enforcing the same but excluding all amounts payable to the company thereunder in respect of V.A.T.. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ মে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Specific digital security
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ মে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ মে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the indemnity (as defined therein) and/or this deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed charge all the machinery equipment and other chattels as listed on the form 395 inclusive of clc gateway and one VT320 terminal and keyboard. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Digital Equipment Co. Limited
    ব্যবসায়
    • ২১ মে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জানু, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and in relation to or in connection with the advance (as defined therein) and other monies due in respect thereof
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first fixed charge clc's right title and interest in the local authority agreement for full details see form 395 and schedule attached.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ জানু, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over contract
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ নভে, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ নভে, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that benefit of an agreement dated 10/4/90 between the company and hartlepool borough council.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ নভে, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Specific digital security
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ অক্টো, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the indemnity as defined therein
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First fixed charge all right title and interest of the company in the equipment as detailed on form 395 see form 395 for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Digital Equipment Co. Limited
    ব্যবসায়
    • ২৬ অক্টো, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ অক্টো, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ অক্টো, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of thw charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title and interest in the local authority agreement for full details see form 395.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ অক্টো, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মে, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to or in connection with the advance (as defined) and/or this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's right title and interest in the local authority agreement (as defined) ....(please see doc for full details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মে, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ মার্চ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ মার্চ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC in connection with the advance (as defined) and/or this charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first fixed charge, clc's right, title and interest in the local authority agreement (as defined). (See doc 395 reference M8L for full details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ মার্চ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Specific digital security
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ ফেব, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ মার্চ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the indemnity contained in clause 5 of the clc digital agreement dated 25/7/89
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1 oracle database licence and various items of equipment see form 395 for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Digital Equipment Co. Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ মার্চ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee in connection with the advance (as defined therein) under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first fixed charge clc's right, title and interest in the local authority agreement see form 395 for details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জানু, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    For securing all moneys due or to become due from the company to national westminster bank PLC in relation to the advance applicable to hereford city council under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right, title and interest in the local authority agreement (please see doc M395 reference M247 for full details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ জানু, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ নভে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ নভে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of second fixed charge ,clc's right title and interest in each of the deposits ,the digital agreement,the csl agreement. Floating charge. Undertaking and all property and assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ নভে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ সেপ, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ সেপ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to or in connection with the advance (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's interest in and to the local authority agreement (please see form 395 for details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ সেপ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৬ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জুল, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ আগ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the 'advance' this charge as defined
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Pursuant to clause 2 of the charge clc has as sole absolute and beneficial owner thereof, charged in favour of the bank by way of first fixed charge C.L.c's right title and interest in the local authority agreement. As defined on form 395 M9.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ আগ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৬ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জুল, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ আগ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the "advance" this charge as defined.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Pursuant to clause 2 of the charge clc has as sole, absolute and beneficial owner thereof, charged in favour of the bank by way of first fixed charge clc's right, title and interest in the local authority agreement (as defined on the form 395 M10).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ আগ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৬ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Specific digital security.
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ মে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the indemnity (as defined therein) and this charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title and interest of the company in the equipment specified on form M395 (see form M395 for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Digital Equipment Co. Limited
    ব্যবসায়
    • ২৮ মে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৬ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ মে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to or in connection with the advance and all other moneys due in respect thereof under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First fixed charge clc's right title & interest in the local authority. Agreement (for full details see form 395 & schedule detailed).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ মে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৬ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Specific digital security
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ এপ্রি, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement, the digital payment and the clc/digital agreement and this charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See 395 for details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Digital Equipment Co. Limited.
    ব্যবসায়
    • ২৭ এপ্রি, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৯ ফেব, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Specific digital security
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ এপ্রি, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement, the digital payment and the clc/digital agreement and this charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See 395 for details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Digital Equipment Co. Limited.
    ব্যবসায়
    • ২৭ এপ্রি, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৯ ফেব, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ এপ্রি, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ এপ্রি, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to or in connection with the advance under the terms of the charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Right title & interest in the local authority agreement (for full details see form 395).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ এপ্রি, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৯ ফেব, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ এপ্রি, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ এপ্রি, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to or in connection with the advance under the terms of the charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Right title & interest in the local authority agreement (for full details see form 395).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ এপ্রি, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৯ ফেব, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ জানু, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ জানু, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First fixed charge clc's right title & interest in the local authority agreement (for full details see form 395).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ জানু, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৯ ফেব, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৩ এপ্রি, ২০১৯ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০১ ফেব, ২০২০ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    অভ্যাসকারী
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    অভ্যাসকারী
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0