WEST YORKSHIRE MOTORS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামWEST YORKSHIRE MOTORS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02178889
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    WEST YORKSHIRE MOTORS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7499) /

    WEST YORKSHIRE MOTORS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    WEST YORKSHIRE MOTORS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    12TH MARBICK LIMITED১৫ অক্টো, ১৯৮৭১৫ অক্টো, ১৯৮৭

    WEST YORKSHIRE MOTORS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৯

    WEST YORKSHIRE MOTORS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    8 পৃষ্ঠা4.71

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২৫ আগ, ২০১১ তারিখে

    LRESSP

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    পরিচালক হিসাবে Christopher Hayden এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৯ মে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২১ জুন, ২০১১

    ২১ জুন, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 795,717
    SH01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৯ মে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAR01

    ১৪ জুন, ২০১০ তারিখে Mr Clive Charles Page-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ০৪ জুন, ২০১০ তারিখে Mr Clive Charles Page-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ০৪ জুন, ২০১০ তারিখে Bryan David Myers-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৪ জুন, ২০১০ তারিখে Christopher William Roberts Hayden-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৪ জুন, ২০১০ তারিখে Steven Wyn Williams-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    5 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    5 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    WEST YORKSHIRE MOTORS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PAGE, Clive Charles
    Room 1/447
    Eagle Way, Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1/447
    Essex
    England
    সচিব
    Room 1/447
    Eagle Way, Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1/447
    Essex
    England
    BritishSolicitor20963910001
    MYERS, Bryan David
    Room 1/447
    Eagle Way, Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1/447
    Essex
    England
    পরিচালক
    Room 1/447
    Eagle Way, Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1/447
    Essex
    England
    BritishCompany Director98436230001
    WILLIAMS, Steven Wyn
    Room 1/447
    Eagle Way, Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1/447
    Essex
    England
    পরিচালক
    Room 1/447
    Eagle Way, Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1/447
    Essex
    England
    United KingdomBritishFord Retail Finance Director54580940001
    HUGHES, Graham Paul
    7 Sackville Close
    CM1 2LU Chelmsford
    Essex
    সচিব
    7 Sackville Close
    CM1 2LU Chelmsford
    Essex
    Other52315640002
    PICKERILL, Derek
    The Old Malt Shovel
    Main Street, Hensall
    DN14 0RA Goole
    North Humberside
    সচিব
    The Old Malt Shovel
    Main Street, Hensall
    DN14 0RA Goole
    North Humberside
    British74896330001
    ASTBURY, Trevor
    19 The Green
    Sharlston Common
    WF4 1EE Wakefield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    19 The Green
    Sharlston Common
    WF4 1EE Wakefield
    West Yorkshire
    BritishGeneral Manager25976120001
    BARRATT, Andrew John
    34 Renoir Place
    Springfield
    CM1 5FP Chelmsford
    Essex
    পরিচালক
    34 Renoir Place
    Springfield
    CM1 5FP Chelmsford
    Essex
    BritishDealer Development Manager31152630001
    BRIGGS, John Philip
    Hollybush
    The Street Bradwell Village
    CM7 8EL Braintree
    Essex
    পরিচালক
    Hollybush
    The Street Bradwell Village
    CM7 8EL Braintree
    Essex
    BritishDirector37238960001
    CICUTTI, Ambrose
    19 Connaught Avenue
    E4 7AE London
    পরিচালক
    19 Connaught Avenue
    E4 7AE London
    ItalianInvestment Co Ordinator8987390001
    CROSS, William Thomas
    200 Stock Road
    CM12 0SH Billericay
    Essex
    পরিচালক
    200 Stock Road
    CM12 0SH Billericay
    Essex
    BritishManager Of Ford Motor Company37532620001
    FRASER, Craig
    31 Watermill Road
    Feering
    CO5 9SR Colchester
    Essex
    পরিচালক
    31 Watermill Road
    Feering
    CO5 9SR Colchester
    Essex
    BritishAccountant8987400001
    HAYDEN, Christopher William Roberts
    Room 1/447
    Eagle Way, Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1/447
    Essex
    England
    পরিচালক
    Room 1/447
    Eagle Way, Great Warley
    CM13 3BW Brentwood
    Room 1/447
    Essex
    England
    United KingdomBritishDirector Ford Retail Europe55991230008
    HOLLINS, Philip James
    243 Manor Road
    IG7 6HL Chigwell
    Essex
    পরিচালক
    243 Manor Road
    IG7 6HL Chigwell
    Essex
    BritishManager68894660001
    PARKER, Nigel Martin
    71a Wensleydale Road
    TW12 2LP Hampton
    Middlesex
    পরিচালক
    71a Wensleydale Road
    TW12 2LP Hampton
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Director41112840001
    PROWTING, Roger George
    68 Chignal Road
    CM1 2JB Chelmsford
    Essex
    পরিচালক
    68 Chignal Road
    CM1 2JB Chelmsford
    Essex
    EnglandBritishManager76592730001
    SMITH, Paul Vincent
    Bakers Lodge
    New Road
    WD7 9DZ Shenley
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Bakers Lodge
    New Road
    WD7 9DZ Shenley
    Hertfordshire
    BritishFinance Director144816400001
    THORLEY, David Ian
    14 Triumph Road
    Glenfield
    LE3 8FR Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    14 Triumph Road
    Glenfield
    LE3 8FR Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritishFinance Director97880070001

    WEST YORKSHIRE MOTORS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ আগ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies deposited from time to time by the company with ford credit europe PLC purusnat to the terms of a sale or return agreement dated 31ST may 1989 ("sor") and all other debts and claims falling due to the company by ford credit europe PLC under the dealer agreement or the sor.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ford Credit Europe PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ মার্চ, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ মার্চ, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ford Credit PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ মার্চ, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ মে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ মার্চ, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H & l/h property and all undertaking and other assets of the company both present and future including goodwill and uncalled capital with book and other debts and all stocks and shares and securities owned by the company.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ford Credit PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ মার্চ, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ মে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A bulk deposit mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ মার্চ, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies deposited by the company with the ford credit PLC pursuant to the trems of a sale or return agreement d/ 01/09/92.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ford Credit PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ মার্চ, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ মার্চ, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ সেপ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ সেপ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ford Credit PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ সেপ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ মার্চ, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Bulk deposit mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জুন, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All moneys deposited by the company with fords.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ford Motor Credit Company Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ জুন, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৮ মার্চ, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জুন, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All new & used vehicles and the proceeds of sale.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ford Motor Credit Company Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ জুন, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৯ মে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)

    WEST YORKSHIRE MOTORS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৫ আগ, ২০১১ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০৬ সেপ, ২০১২ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    অভ্যাসকারী
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0