CTC MANAGEMENT LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCTC MANAGEMENT LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02215196
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CTC MANAGEMENT LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    CTC MANAGEMENT LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Standard House
    12-13 Essex Street
    WC2R 3AA London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CTC MANAGEMENT LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    RICHARDS HOGG LINDLEY LIMITED০৯ জানু, ১৯৯৮০৯ জানু, ১৯৯৮
    RICHARDS HOGG LIMITED০৫ মে, ১৯৮৮০৫ মে, ১৯৮৮
    LEGIBUS 1128 LIMITED২৯ জানু, ১৯৮৮২৯ জানু, ১৯৮৮

    CTC MANAGEMENT LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৩

    CTC MANAGEMENT LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    CTC MANAGEMENT LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ১৯ নভে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Reduce share prem a/c 04/11/2014
    RES13

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ অক্টো, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    চার্জ 7 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 8 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ অক্টো, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ অক্টো, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    ০১ অক্টো, ২০১২ তারিখে Mr Thomas Damian Ely-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০১২ তারিখে Mr George William Fitzsimons-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ৩১ অক্টো, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে George William Fitzsimons এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৬ জুল, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Ivan John Keane-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ অক্টো, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Charles Taylor Administration Services Limited-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP04

    সচিব হিসাবে Robert Bird এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ অক্টো, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    CTC MANAGEMENT LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CHARLES TAYLOR ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    Essex Street
    WC2R 3AA London
    Standard House 12-13
    কর্পোরেট সচিব
    Essex Street
    WC2R 3AA London
    Standard House 12-13
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর3413040
    157558200001
    ELY, Thomas Damian
    12-13 Essex Street
    WC2R 3AA London
    Standard House
    England
    পরিচালক
    12-13 Essex Street
    WC2R 3AA London
    Standard House
    England
    EnglandBritish59348270003
    KEANE, Ivan John
    House
    12-13 Essex Street
    WC2R 3AA London
    Standard
    England
    পরিচালক
    House
    12-13 Essex Street
    WC2R 3AA London
    Standard
    England
    EnglandBritish65092840002
    BERRY, John Gordon
    Flat 20b
    20 The Barons
    TW1 2AP Twickenham
    Middlesex
    সচিব
    Flat 20b
    20 The Barons
    TW1 2AP Twickenham
    Middlesex
    British37142130001
    BIRD, Robert Arthur
    14 Coulsdon Rise
    CR5 2SA Coulsdon
    Surrey
    সচিব
    14 Coulsdon Rise
    CR5 2SA Coulsdon
    Surrey
    British23723280001
    BRICKNELL, Sarah Louise
    105b Tranmere Road
    Earlsfield
    SW18 3QP London
    সচিব
    105b Tranmere Road
    Earlsfield
    SW18 3QP London
    British45306460001
    RAYNER, John Henry
    Emperor House 35 Vine Street
    EC3N 2RH London
    সচিব
    Emperor House 35 Vine Street
    EC3N 2RH London
    British1564830001
    AHERN, John Richard
    Comptons Cottage
    55 Brighton Road
    RH13 6EZ Horsham
    West Sussex
    পরিচালক
    Comptons Cottage
    55 Brighton Road
    RH13 6EZ Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish70339340002
    ALLEN, Jeffery Charles
    5 Deben Road
    CO4 3UZ Colchester
    Essex
    পরিচালক
    5 Deben Road
    CO4 3UZ Colchester
    Essex
    British37267240001
    ANDERSEN, Julian Nils
    14 Giles Coppice
    Dulwich
    SE19 1XF London
    পরিচালক
    14 Giles Coppice
    Dulwich
    SE19 1XF London
    British19161380001
    BARSTOW, Christopher John
    Aros Courts Hill Road
    GU27 2PN Haslemere
    Surrey
    পরিচালক
    Aros Courts Hill Road
    GU27 2PN Haslemere
    Surrey
    British17360670001
    BROWNE, Dennis Walter
    71 Steep Hill
    CR0 5QU Croydon
    Surrey
    পরিচালক
    71 Steep Hill
    CR0 5QU Croydon
    Surrey
    British57870460001
    BYCROFT, Geoffrey
    The Grange Church Lane
    London Thorpe
    NG31 9RX Grantham
    Lincolnshire
    পরিচালক
    The Grange Church Lane
    London Thorpe
    NG31 9RX Grantham
    Lincolnshire
    British16664220001
    CLARKE, Stephen Andrew
    6 Esmond Road
    Chiswick
    W4 1JQ London
    পরিচালক
    6 Esmond Road
    Chiswick
    W4 1JQ London
    EnglandBritish42862450003
    COLE, Douglas Andrew
    7 Lake Road
    TN4 8XT Tunbridge Wells
    Kent
    পরিচালক
    7 Lake Road
    TN4 8XT Tunbridge Wells
    Kent
    British38310860002
    CORNAH, Richard Ralph
    12 Kirby Park
    West Kirby
    L48 2HA Wirral
    Merseyside
    পরিচালক
    12 Kirby Park
    West Kirby
    L48 2HA Wirral
    Merseyside
    EnglandBritish30854980001
    CROSS, James Frederick
    72 Rede Court Road
    Strood
    ME2 3TF Rochester
    Kent
    পরিচালক
    72 Rede Court Road
    Strood
    ME2 3TF Rochester
    Kent
    EnglandBritish28507550001
    DUNCAN, Joseph Miles
    Home Farm Landican
    L49 5LJ Birkenhead
    Merseyside
    পরিচালক
    Home Farm Landican
    L49 5LJ Birkenhead
    Merseyside
    EnglandBritish282748720002
    ELLIOT, Gordon Henry
    11 Maltbys
    Selborne
    GU34 3LT Alton
    Hampshire
    পরিচালক
    11 Maltbys
    Selborne
    GU34 3LT Alton
    Hampshire
    British46887780002
    FITZSIMONS, George William
    12-13 Essex Street
    WC2R 3AA London
    Standard House
    England
    পরিচালক
    12-13 Essex Street
    WC2R 3AA London
    Standard House
    England
    United KingdomBritish105693390001
    GROOM, Alistair John
    The Rectory
    East Martin
    SP6 3LJ Fordingbridge
    Hampshire
    পরিচালক
    The Rectory
    East Martin
    SP6 3LJ Fordingbridge
    Hampshire
    EnglandBritish38168820003
    HAWKINS, Neil Richard
    15 Garth Road
    TN13 1RT Sevenoaks
    Kent
    পরিচালক
    15 Garth Road
    TN13 1RT Sevenoaks
    Kent
    British57870640001
    HEBDITCH, Charles Silvius
    The Old Rectory
    Fringford
    OX6 9DX Bicester
    Oxfordshire
    পরিচালক
    The Old Rectory
    Fringford
    OX6 9DX Bicester
    Oxfordshire
    EnglandBritish47877070001
    JONES, Keith
    The Chestnuts Packhorse Road
    Bessels Green
    TN13 2QR Sevenoaks
    Kent
    পরিচালক
    The Chestnuts Packhorse Road
    Bessels Green
    TN13 2QR Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish47481830001
    MACDONALD, John Alan
    Sheephatch House Sheephatch Lane
    Tilford
    GU10 2AQ Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    Sheephatch House Sheephatch Lane
    Tilford
    GU10 2AQ Farnham
    Surrey
    British58593730001
    MAROUNGA PANAYOTOPOULOS, Glykeria Niki
    18 Kosti Palama Str
    Neo Psychiko
    FOREIGN Athens 15451 Greece
    পরিচালক
    18 Kosti Palama Str
    Neo Psychiko
    FOREIGN Athens 15451 Greece
    Greek41138760001
    MARTIN, Keith James
    23 Chemin Du Parterre
    78630 Morainvilliers
    France
    পরিচালক
    23 Chemin Du Parterre
    78630 Morainvilliers
    France
    British27025260002
    MATTHEWS, John Stephen
    79 Hillfield Avenue
    N8 7DS London
    পরিচালক
    79 Hillfield Avenue
    N8 7DS London
    EnglandBritish45883160003
    MITCHELL, Michael Egley
    8 Inglis Road
    CO3 3HU Colchester
    Essex
    পরিচালক
    8 Inglis Road
    CO3 3HU Colchester
    Essex
    British34473380001
    PATON, Andrew Mark
    Bramley Hyrst
    Oldfield Road
    BR1 2LF Bickley
    Kent
    পরিচালক
    Bramley Hyrst
    Oldfield Road
    BR1 2LF Bickley
    Kent
    British16664230002
    ROGERS, Nigel John Crispin
    1st/2nd Floor
    70 Eaton Place
    SW1X 8AT London
    পরিচালক
    1st/2nd Floor
    70 Eaton Place
    SW1X 8AT London
    British16664180004
    ROWE, John Stephen Martin
    Ixworth Abbey
    Ixworth
    IP31 2HQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    পরিচালক
    Ixworth Abbey
    Ixworth
    IP31 2HQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    United KingdomBritish35883210001
    ROWLAND, Paul Oliver
    4 Beddington Road
    Seven Kings
    IG3 8PD Ilford
    Essex
    পরিচালক
    4 Beddington Road
    Seven Kings
    IG3 8PD Ilford
    Essex
    EnglandBritish50953380001
    SHEPLEY CUTHBERT, David Charles
    Moors House
    Hook Norton
    OX15 5LS Banbury
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Moors House
    Hook Norton
    OX15 5LS Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritish49556220001
    SILVER, Paul Philip
    47 Brittains Lane
    TN13 2JP Sevenoaks
    Kent
    পরিচালক
    47 Brittains Lane
    TN13 2JP Sevenoaks
    Kent
    British30745170006

    CTC MANAGEMENT LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ ডিসে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ ডিসে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০৬ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ আগ, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deed
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জানু, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জানু, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC (Acting Through Its Agent, the Royal Bank of Scotland PLC)
    ব্যবসায়
    • ২৭ জানু, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ আগ, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ফেব, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ ফেব, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ জানু, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২০ মে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুন, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hongkongbank of Australia Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ জানু, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ এপ্রি, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ মে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ মে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ জানু, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ জানু, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ জানু, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over goodwill,bookdebts and patents. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ জানু, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ অক্টো, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জুল, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ আগ, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Coutts & Company
    ব্যবসায়
    • ০২ আগ, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৩ জানু, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ জুন, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জুন, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ জুন, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৭ অক্টো, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0