CSC PROPERTIES 2021 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCSC PROPERTIES 2021 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02218116
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CSC PROPERTIES 2021 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (4521) /

    CSC PROPERTIES 2021 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    40 Broadway
    London
    Sw1h 0bu
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CSC PROPERTIES 2021 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    C&C PROPERTIES 2021 LIMITED১১ ডিসে, ২০০১১১ ডিসে, ২০০১
    BROADWAY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT (BROMLEY) LIMITED৩১ মার্চ, ১৯৮৮৩১ মার্চ, ১৯৮৮
    MODERNTWIN LIMITED০৫ ফেব, ১৯৮৮০৫ ফেব, ১৯৮৮

    CSC PROPERTIES 2021 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৯

    CSC PROPERTIES 2021 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ০৪ জুন, ২০১১ তারিখে Susan Folger-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    legacy

    4 পৃষ্ঠাMG02

    পরিচালক হিসাবে Mark Kildea এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ মে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৪ মে, ২০১১

    ২৪ মে, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 250
    SH01

    ১৩ আগ, ২০১০ তারিখে Kay Elizabeth Chaldecott-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Edward Matthew Giles Roberts-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Kay Elizabeth Chaldecott-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Mark Kildea-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Gary Richard Hoskins-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ মে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Caroline Kirby-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Gary Yardley এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Balbinder Tattar এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Ian Hawksworth এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed c&c properties 2021 LIMITED\certificate issued on 21/05/10
    2 পৃষ্ঠাCERTNM
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ১১ মে, ২০১০

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Gary James Yardley-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Balbinder Singh Tattar-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Ian David Hawksworth-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে David Andrew Fischel-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Susan Folger-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    CSC PROPERTIES 2021 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MARSDEN, Susan
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    সচিব
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    British68599110004
    CHALDECOTT, Kay Elizabeth
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    পরিচালক
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    EnglandBritishChartered Surveyor68694110002
    FISCHEL, David Andrew
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    পরিচালক
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    United KingdomBritishChartered Accountant8845220002
    HOSKINS, Gary Richard
    Broadway
    SW1H 0BT London
    40
    পরিচালক
    Broadway
    SW1H 0BT London
    40
    United KingdomBritishChartered Accountant153902440001
    KIRBY, Caroline
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    পরিচালক
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    EnglandBritishChartered Surveyor108375400001
    ROBERTS, Edward Matthew Giles, Dr
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    পরিচালক
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    United KingdomBritishChartered Accountant/Finance Director154029500001
    BOTTLE, Jeremy Stephen
    39 Farnaby Road
    Shortlands
    BR1 4BL Bromley
    Kent
    সচিব
    39 Farnaby Road
    Shortlands
    BR1 4BL Bromley
    Kent
    British14465210001
    ABEL, John George
    9 Hutton Gate
    Hutton Mount
    CM13 2XA Brentwood
    Essex
    পরিচালক
    9 Hutton Gate
    Hutton Mount
    CM13 2XA Brentwood
    Essex
    UkBritishChartered Surveyor14465220002
    BLACK, William Reginald
    Marley Side Marley Heights
    Kingsley Green
    GU27 3LU Haslemere
    Surrey
    পরিচালক
    Marley Side Marley Heights
    Kingsley Green
    GU27 3LU Haslemere
    Surrey
    EnglandBritishChartered Surveyor41017610002
    HAWKSWORTH, Ian David
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    পরিচালক
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    United KingdomBritishChartered Surveyor115713550001
    JOLLY, Brian Anthony
    14 Links Road
    KT17 3PS Epsom
    Surrey
    পরিচালক
    14 Links Road
    KT17 3PS Epsom
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Surveyor14465250001
    KILDEA, Mark
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    পরিচালক
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    United KingdomBritishGroup Treasurer89161850003
    MARCUCCILLI, Gary John
    29 Manor Wood Road
    CR8 4LG Purley
    Surrey
    পরিচালক
    29 Manor Wood Road
    CR8 4LG Purley
    Surrey
    United KingdomBritishDirector65438590002
    SAGGERS, John Ian
    Galleon House
    Martlesham Road Little Bealings
    IP13 6LX Woodbridge
    Suffolk
    পরিচালক
    Galleon House
    Martlesham Road Little Bealings
    IP13 6LX Woodbridge
    Suffolk
    BritishChartered Surveyor35538650002
    SMITH, Aidan Christopher
    50 Wavendon Avenue
    Chiswick
    W4 4NS London
    পরিচালক
    50 Wavendon Avenue
    Chiswick
    W4 4NS London
    United KingdomBritishChartered Accountant31140320001
    TATTAR, Balbinder Singh
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    পরিচালক
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    United KingdomBritishAccountant105287960002
    YARDLEY, Gary James
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    পরিচালক
    Broadway
    SW1H 0BU London
    40
    United KingdomBritishChartered Surveyor55671660002

    CSC PROPERTIES 2021 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Trust deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ অক্টো, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The principal of and interest on the £354,876,000 5.562 per cent. First mortgage debenture stock 2027 of capital & counties debenture PLC and all other moneys under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H queensville retail park (also k/a queens retail park) queensville stafford t/n sf 358502 l/h marland house 26-29 sloane street and 43-47 (odd numbers) pavillion road kensington london t/n LN216478 * for details of further property charged please refer to form 395 *. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    ব্যবসায়
    • ০৬ অক্টো, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ ডিসে, ২০০৬বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২১ জুন, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Deed of release and substitution
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ফেব, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The principal of and interest on £80,000,000 11 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the deed of release and substitution and the trust deed dated 14TH march 1991 and deeds supplemental thereto
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a queensville retail park (also k/a queens retail park) queensville stafford t/n SF358502. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ ফেব, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ অক্টো, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    First supplemental trust deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The principal of £80,000,000 11 1/4 per cent.first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other monies due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies payable by virtue of any insurances on the mortgaged premises,as defined in the principal deed,pursuant to clauses 17(m) and 17(n) of the principal trust deed.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    ব্যবসায়
    • ০৪ সেপ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ ফেব, ২০০৬বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    Deed of release and substitution
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ অক্টো, ২০০১
    অর্জিত হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold property being dudley house,169 piccadilly,london W1; ngl 804655.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    ব্যবসায়
    • ২৪ সেপ, ২০০২অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ০৬ অক্টো, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of release and substitution
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ মে, ২০০০
    অর্জিত হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/Hold property being 32 and 33 long acre,london WC2; NGL775393.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    ব্যবসায়
    • ২৪ সেপ, ২০০২অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ০৬ অক্টো, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of release and substitution
    তৈরি করা হয়েছে ২১ মে, ১৯৯৮
    অর্জিত হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold property being 12 and 14 new fetter lane,london EC4; NGL573821.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    ব্যবসায়
    • ২৪ সেপ, ২০০২অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ০৬ অক্টো, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of release and substitution
    তৈরি করা হয়েছে ২১ মে, ১৯৯৮
    অর্জিত হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold property being carrington house,126,128 and 130 regent st,4 regent place and 36,38 and 40 warwick st,london W1; ngl 530323.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    ব্যবসায়
    • ২৪ সেপ, ২০০২অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ০৬ অক্টো, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of release and substitution
    তৈরি করা হয়েছে ০২ জুন, ১৯৯৭
    অর্জিত হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জানু, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The principal of and interest on £80,000,000 11 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the deed of release and substitution and the trust deed dated 14TH march 1991 and deeds supplemental thereto
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H commonwealth house hammersmith london t/no NGL385177.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ জানু, ২০০৩অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ০৬ অক্টো, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of assurance and release
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ১৯৯৪
    অর্জিত হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/Hold property being capital place,bath rd,harlington; agl 443.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    ব্যবসায়
    • ২৪ সেপ, ২০০২অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ০৬ অক্টো, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of assurance and release
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ১৯৯৪
    অর্জিত হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold property being walmar house,288-300 (even) regent st,15-16 great castle st,45-46 margaret st,london W1; t/no ngl 440302.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    ব্যবসায়
    • ২৪ সেপ, ২০০২অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ০৬ অক্টো, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Trust deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ১৯৯১
    অর্জিত হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold property being 190 strand,194 strand,2-8 maltravers st,canberra house,10-16 maltravers st,18-24 maltravers st,1 maltravers street and 7 arundel st,strand,london WC2; t/no NGL32297.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    ব্যবসায়
    • ২৪ সেপ, ২০০২অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    Trust deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ১৯৯১
    অর্জিত হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold property being marland house,26-29 sloane street and 43-47 (odd nos) pavillion rd,london SW1; t/no LN216478.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    ব্যবসায়
    • ২৪ সেপ, ২০০২অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ০৬ অক্টো, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0