CSC PROPERTIES 2021 LIMITED
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
কোম্পানির নাম | CSC PROPERTIES 2021 LIMITED |
---|---|
কোম্পানির স্থিতি | বাতিল |
আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
কোম্পানি নম্বর | 02218116 |
এখতিয়ার | ইংল্যান্ড/ওয়েলস |
সৃষ্টির তারিখ | |
বন্ধের তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
---|---|
চার্জ রয়েছে | হ্যাঁ |
দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
CSC PROPERTIES 2021 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?
- (4521) /
CSC PROPERTIES 2021 LIMITED কোথায় অবস্থিত?
নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | 40 Broadway London Sw1h 0bu |
---|---|
ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
CSC PROPERTIES 2021 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?
কোম্পানির নাম | থেকে | পর্যন্ত |
---|---|---|
C&C PROPERTIES 2021 LIMITED | ১১ ডিসে, ২০০১ | ১১ ডিসে, ২০০১ |
BROADWAY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT (BROMLEY) LIMITED | ৩১ মার্চ, ১৯৮৮ | ৩১ মার্চ, ১৯৮৮ |
MODERNTWIN LIMITED | ০৫ ফেব, ১৯৮৮ | ০৫ ফেব, ১৯৮৮ |
CSC PROPERTIES 2021 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
শেষ হিসাব | |
---|---|
শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩১ ডিসে, ২০০৯ |
CSC PROPERTIES 2021 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | GAZ2(A) | ||||||||||
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি | 1 পৃষ্ঠা | GAZ1(A) | ||||||||||
কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন | 3 পৃষ্ঠা | DS01 | ||||||||||
০৪ জুন, ২০১১ তারিখে Susan Folger-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | CH03 | ||||||||||
legacy | 4 পৃষ্ঠা | MG02 | ||||||||||
পরিচালক হিসাবে Mark Kildea এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ০৮ মে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 8 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
১৩ আগ, ২০১০ তারি খে Kay Elizabeth Chaldecott-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||||||||||
পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি | 11 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
পরিচালক হিসাবে Edward Matthew Giles Roberts-এর নিয়োগ | 3 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||
পরিচালক হিসাবে Kay Elizabeth Chaldecott-এর নিয়োগ | 3 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||
পরিচালক হিসাবে Mark Kildea-এর নিয়োগ | 3 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||
পরিচালক হিসাবে Gary Richard Hoskins-এর নিয়োগ | 3 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ০৮ মে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 5 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
পরিচালক হিসাবে Caroline Kirby-এর নিয়োগ | 3 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||
পরিচালক হিসাবে Gary Yardley এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||
পরিচালক হিসাবে Balbinder Tattar এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||
পরিচালক হিসাবে Ian Hawksworth এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||
নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র Company name changed c&c properties 2021 LIMITED\certificate issued on 21/05/10 | 2 পৃষ্ঠা | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি | 2 পৃষ্ঠা | CONNOT | ||||||||||
০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Gary James Yardley-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||||||||||
০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Balbinder Singh Tattar-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||||||||||
০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Ian David Hawksworth-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||||||||||
০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে David Andrew Fischel-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||||||||||
০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Susan Folger-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | CH03 | ||||||||||
CSC PROPERTIES 2021 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?
নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARSDEN, Susan | সচিব | Broadway SW1H 0BU London 40 | British | 68599110004 | ||||||
CHALDECOTT, Kay Elizabeth | পরিচালক | Broadway SW1H 0BU London 40 | England | British | Chartered Surveyor | 68694110002 | ||||
FISCHEL, David Andrew | পরিচালক | Broadway SW1H 0BU London 40 | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 8845220002 | ||||
HOSKINS, Gary Richard | পরিচালক | Broadway SW1H 0BT London 40 | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 153902440001 | ||||
KIRBY, Caroline | পরিচালক | Broadway SW1H 0BU London 40 | England | British | Chartered Surveyor | 108375400001 | ||||
ROBERTS, Edward Matthew Giles, Dr | পরিচালক | Broadway SW1H 0BU London 40 | United Kingdom | British | Chartered Accountant/Finance Director | 154029500001 | ||||
BOTTLE, Jeremy Stephen | সচিব | 39 Farnaby Road Shortlands BR1 4BL Bromley Kent | British | 14465210001 | ||||||
ABEL, John George | পরিচালক | 9 Hutton Gate Hutton Mount CM13 2XA Brentwood Essex | Uk | British | Chartered Surveyor | 14465220002 | ||||
BLACK, William Reginald | পরিচালক | Marley Side Marley Heights Kingsley Green GU27 3LU Haslemere Surrey | England | British | Chartered Surveyor | 41017610002 | ||||
HAWKSWORTH, Ian David | পরিচালক | Broadway SW1H 0BU London 40 | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 115713550001 | ||||
JOLLY, Brian Anthony | পরিচালক | 14 Links Road KT17 3PS Epsom Surrey | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 14465250001 | ||||
KILDEA, Mark | পরিচালক | Broadway SW1H 0BU London 40 | United Kingdom | British | Group Treasurer | 89161850003 | ||||
MARCUCCILLI, Gary John | পরিচালক | 29 Manor Wood Road CR8 4LG Purley Surrey | United Kingdom | British | Director | 65438590002 | ||||
SAGGERS, John Ian | পরিচালক | Galleon House Martlesham Road Little Bealings IP13 6LX Woodbridge Suffolk | British | Chartered Surveyor | 35538650002 | |||||
SMITH, Aidan Christopher | পরিচালক | 50 Wavendon Avenue Chiswick W4 4NS London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 31140320001 | ||||
TATTAR, Balbinder Singh | পরিচালক | Broadway SW1H 0BU London 40 | United Kingdom | British | Accountant | 105287960002 | ||||
YARDLEY, Gary James | পরিচালক | Broadway SW1H 0BU London 40 | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 55671660002 |
CSC PROPERTIES 2021 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?
শ্রেণীবিন্যাস | তারিখ | স্থিতি | বিস্তারিত | |
---|---|---|---|---|
Trust deed | তৈরি করা হয়েছে ০৫ অক্টো, ২০০৬ ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ২০০৬ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ The principal of and interest on the £354,876,000 5.562 per cent. First mortgage debenture stock 2027 of capital & counties debenture PLC and all other moneys under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ F/H queensville retail park (also k/a queens retail park) queensville stafford t/n sf 358502 l/h marland house 26-29 sloane street and 43-47 (odd numbers) pavillion road kensington london t/n LN216478 * for details of further property charged please refer to form 395 *. see the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Deed of release and substitution | তৈরি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ২০০৬ ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ফেব, ২০০৬ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ The principal of and interest on £80,000,000 11 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the deed of release and substitution and the trust deed dated 14TH march 1991 and deeds supplemental thereto | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ F/H property k/a queensville retail park (also k/a queens retail park) queensville stafford t/n SF358502. See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
First supplemental trust deed | তৈরি করা হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০২ ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ২০০২ | বকেয়া | সুরক্ষিত পরিমাণ The principal of £80,000,000 11 1/4 per cent.first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other monies due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ All monies payable by virtue of any insurances on the mortgaged premises,as defined in the principal deed,pursuant to clauses 17(m) and 17(n) of the principal trust deed. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Deed of release and substitution | তৈরি করা হয়েছে ১৫ অক্টো, ২০০১ অর্জিত হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০২ ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০২ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ L/Hold property being dudley house,169 piccadilly,london W1; ngl 804655. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Deed of release and substitution | তৈরি করা হয়েছে ০৪ মে, ২০০০ অর্জিত হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০২ ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০২ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ F/Hold property being 32 and 33 long acre,london WC2; NGL775393. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Deed of release and substitution | তৈরি করা হয়েছে ২১ মে, ১৯৯৮ অর্জিত হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০২ ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০২ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ L/Hold property being 12 and 14 new fetter lane,london EC4; NGL573821. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Deed of release and substitution | তৈরি করা হয়েছে ২১ মে, ১৯৯৮ অর্জিত হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০২ ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০২ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ L/Hold property being carrington house,126,128 and 130 regent st,4 regent place and 36,38 and 40 warwick st,london W1; ngl 530323. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Deed of release and substitution | তৈরি করা হয়েছে ০২ জুন, ১৯৯৭ অর্জিত হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০২ ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জানু, ২০০৩ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ The principal of and interest on £80,000,000 11 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the deed of release and substitution and the trust deed dated 14TH march 1991 and deeds supplemental thereto | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ L/H commonwealth house hammersmith london t/no NGL385177. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Deed of assurance and release | তৈরি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ১৯৯৪ অর্জিত হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০২ ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০২ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ F/Hold property being capital place,bath rd,harlington; agl 443. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Deed of assurance and release | তৈরি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ১৯৯৪ অর্জিত হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০২ ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০২ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ L/Hold property being walmar house,288-300 (even) regent st,15-16 great castle st,45-46 margaret st,london W1; t/no ngl 440302. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Trust deed | তৈরি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ১৯৯১ অর্জিত হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০২ ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০২ | বকেয়া | সুরক্ষিত পরিমাণ The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ L/Hold property being 190 strand,194 strand,2-8 maltravers st,canberra house,10-16 maltravers st,18-24 maltravers st,1 maltravers street and 7 arundel st,strand,london WC2; t/no NGL32297. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Trust deed | তৈ রি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ১৯৯১ অর্জিত হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০২ ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০২ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ The principal of and interest on £80,000,000 11 <% first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed dated 14 march 1991 and the deeds supplemental thereto | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ L/Hold property being marland house,26-29 sloane street and 43-47 (odd nos) pavillion rd,london SW1; t/no LN216478. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
|