GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামGEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02220656
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    The Phoenix Building Central Boulevard
    Blythe Valley Park Shirley
    B90 8BG Solihull
    West Midlands
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    JBA SOFTWARE PRODUCTS LIMITED২৯ জুল, ১৯৯১২৯ জুল, ১৯৯১
    OLYMPIC SOFTWARE LIMITED১১ ফেব, ১৯৮৮১১ ফেব, ১৯৮৮

    GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মে, ২০১১

    GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ৩১ মে, ২০১২ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    2 পৃষ্ঠা4.68

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    2 পৃষ্ঠা4.71

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২৬ মার্চ, ২০১২ তারিখে

    LRESSP

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    ২০ ফেব, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে George Bisnought এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১১ জানু, ২০১২

    ১১ জানু, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    সংশোধিত পূর্ণ হিসাব ৩১ মে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAAMD

    হিসাব ৩১ মে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    1 পৃষ্ঠা190

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353

    হিসাব ৩১ মে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    OLDROYD, Andrew
    The Street
    Ewhurst
    GU6 7QD Cranleigh
    Corner House
    Surrey
    United Kingdom
    পরিচালক
    The Street
    Ewhurst
    GU6 7QD Cranleigh
    Corner House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish136724940001
    BISNOUGHT, George
    Surley Row
    Emmer Green
    RG4 8ND Caversham
    Flower Hill
    Berks.
    United Kingdom
    সচিব
    Surley Row
    Emmer Green
    RG4 8ND Caversham
    Flower Hill
    Berks.
    United Kingdom
    British140313340001
    DANIELS, Pascale Isabelle Denise Louise Marie Ghuislaine
    2 Rue Van Winghen
    Anderlecht 1070
    Belgium
    সচিব
    2 Rue Van Winghen
    Anderlecht 1070
    Belgium
    British86539580001
    DEANE, Keith
    34 Mill Lane
    SL9 8BA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    সচিব
    34 Mill Lane
    SL9 8BA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British113569550001
    GIANGIORDANO, Gregory Michael, Mr.
    440 Edenbrooke Way
    FOREIGN Roswell
    Georgia 30075-7154
    Usa
    সচিব
    440 Edenbrooke Way
    FOREIGN Roswell
    Georgia 30075-7154
    Usa
    American112513570001
    GIANGIORDANO, Gregory Michael, Mr.
    440 Edenbrooke Way
    FOREIGN Roswell
    Georgia 30075-7154
    Usa
    সচিব
    440 Edenbrooke Way
    FOREIGN Roswell
    Georgia 30075-7154
    Usa
    American112513570001
    JETHWA, Amritlal
    117 Passage Road
    Westbury On Trym
    BS9 3LF Bristol
    সচিব
    117 Passage Road
    Westbury On Trym
    BS9 3LF Bristol
    British33776800004
    SUTTON, Matthew Jeremy
    15 Newfield Road
    DY9 0JP Hagley
    West Midlands
    সচিব
    15 Newfield Road
    DY9 0JP Hagley
    West Midlands
    British92738100001
    TOWERS, Antony John
    The Hayloft Manor Farm Barns
    Stratford Road
    WR11 7PP Honeybourne
    Worcestershire
    সচিব
    The Hayloft Manor Farm Barns
    Stratford Road
    WR11 7PP Honeybourne
    Worcestershire
    British91463240002
    WILLIAMS, David
    Tong Lodge
    Ruckley
    TF11 8PQ Shifnal
    Salop
    সচিব
    Tong Lodge
    Ruckley
    TF11 8PQ Shifnal
    Salop
    British4180840002
    WRAGG, Peter Thomas Currie
    Bank House
    Main Street Church Lench
    WR11 4UE Evesham
    Worcestershire
    সচিব
    Bank House
    Main Street Church Lench
    WR11 4UE Evesham
    Worcestershire
    British101526370002
    WRAGG, Peter Thomas Currie
    Bank House
    Main Street Church Lench
    WR11 4UE Evesham
    Worcestershire
    সচিব
    Bank House
    Main Street Church Lench
    WR11 4UE Evesham
    Worcestershire
    British101526370002
    BISNOUGHT, George
    Surley Row
    Emmer Green
    RG4 8ND Caversham
    Flower Hill
    Berks.
    United Kingdom
    পরিচালক
    Surley Row
    Emmer Green
    RG4 8ND Caversham
    Flower Hill
    Berks.
    United Kingdom
    United KingdomBritish140313340001
    BRIDDON, Kenneth Carl
    Rose Farmhouse
    Village Road Waverton
    CH3 7QN Chester
    Cheshire
    পরিচালক
    Rose Farmhouse
    Village Road Waverton
    CH3 7QN Chester
    Cheshire
    British76868400001
    CULLENS, Alan Russell
    Newfields
    Chandlers Lane
    GU46 7SP Yateley
    Hampshire
    পরিচালক
    Newfields
    Chandlers Lane
    GU46 7SP Yateley
    Hampshire
    British99247410001
    FLEISCHER, Russell Lawrence
    1504 Thomas Pl
    Forw Worth
    Texas 75252
    U.S.A.
    পরিচালক
    1504 Thomas Pl
    Forw Worth
    Texas 75252
    U.S.A.
    United StatesAmerican154096470001
    GIANGIORDANO, Gregory Michael, Mr.
    440 Edenbrooke Way
    FOREIGN Roswell
    Georgia 30075-7154
    Usa
    পরিচালক
    440 Edenbrooke Way
    FOREIGN Roswell
    Georgia 30075-7154
    Usa
    United StatesAmerican112513570001
    JETHWA, Amritlal
    117 Passage Road
    Westbury On Trym
    BS9 3LF Bristol
    পরিচালক
    117 Passage Road
    Westbury On Trym
    BS9 3LF Bristol
    British33776800004
    JONES, John Kevin
    Southlands 1 Bearnett Drive
    WV4 5NN Wolverhampton
    West Midlands
    পরিচালক
    Southlands 1 Bearnett Drive
    WV4 5NN Wolverhampton
    West Midlands
    British68103800001
    JORDAN, Philip
    18 Cheyne Court
    Flood Street
    SW3 5TP London
    পরিচালক
    18 Cheyne Court
    Flood Street
    SW3 5TP London
    British51718170002
    KASPER, Jochen Berthold
    Taubenstrasse
    66740 Saarlouis
    8
    66740
    Germany
    পরিচালক
    Taubenstrasse
    66740 Saarlouis
    8
    66740
    Germany
    GermanyGerman113569900002
    KLINGWALL, Per Nils Christer
    Forge Cottage
    10 Rosemary Lane
    HP17 8JS Haddenham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Forge Cottage
    10 Rosemary Lane
    HP17 8JS Haddenham
    Buckinghamshire
    Swedish70508330002
    NEEMAN, Ellen
    1 Tahoe Court
    Toronto
    M3b 3m6 Ontario
    পরিচালক
    1 Tahoe Court
    Toronto
    M3b 3m6 Ontario
    Canadian70543520001
    NELSON, William George
    2217 Hidden Creek Court
    Lisle
    Illinois 60532
    Usa
    পরিচালক
    2217 Hidden Creek Court
    Lisle
    Illinois 60532
    Usa
    American50467760007
    ROSE, Malcolm James
    46 Leigh Road
    WS4 2DS Walsall
    West Midlands
    পরিচালক
    46 Leigh Road
    WS4 2DS Walsall
    West Midlands
    British21913860001
    SCIARD, Bertrand Andre Robert
    15 Avenue Sainte Foy
    Neuilly Sur Seine
    92200
    France
    পরিচালক
    15 Avenue Sainte Foy
    Neuilly Sur Seine
    92200
    France
    French70543450001
    VICKERY, Alan Graham
    Greensleeves Talbot Avenue
    B74 3DB Sutton Coldfield
    West Midlands
    পরিচালক
    Greensleeves Talbot Avenue
    B74 3DB Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish4180850001
    WHEELER, Paul Michael
    Squirrel Lodge
    Pinewoods Road Longworth
    OX13 5HH Abingdon
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Squirrel Lodge
    Pinewoods Road Longworth
    OX13 5HH Abingdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritish76692640002
    WILLIAMS, David
    Tong Lodge
    Ruckley
    TF11 8PQ Shifnal
    Salop
    পরিচালক
    Tong Lodge
    Ruckley
    TF11 8PQ Shifnal
    Salop
    EnglandBritish4180840002
    WRIGHT, Timothy John
    55b Hancock Street
    Lexington
    Massachusetts 02420
    Usa
    পরিচালক
    55b Hancock Street
    Lexington
    Massachusetts 02420
    Usa
    British97675480001

    GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A loan,guaranty and security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ সেপ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ সেপ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All loans,advances,debts, and principal due or to become due from the borrowers and duties of any kind due from the loan parties to the lender group under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The amount paid to the company on account of any rights of suborgation the company may eequire under any loan document to which it is party; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Wells Fargo Foothill,Inc. Usa as a Lender and the Collateral Agent
    ব্যবসায়
    • ১৮ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ নভে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    An intercompany subordination agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ সেপ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ সেপ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All indebtedness due or to become due from the borrowers to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any payment of any kind to any of the subordinated creditors on account of the subordinated indebtedness; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Wells Fargo Foothill,Inc. Usa as a Senior Creditor and the Security Agent
    ব্যবসায়
    • ১৮ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ নভে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ অক্টো, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ নভে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies or liabilities due or to become due from the company to the chargee as agent for the lenders (in such capacity the "agent") or any other loan party (as defined) (the "secured party") on any account whatsoever under pursuant to or in connection with the facility agreement (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ableco Finance Llc
    ব্যবসায়
    • ০২ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ জুন, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জানু, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant of the loan documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Toronto Dominion Bank
    ব্যবসায়
    • ০৭ জানু, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ অক্টো, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ নভে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ নভে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or aib finance limited
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    "Eagle house" the slough studley warwickshire and the goodwill and connection of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Allied Irish Banks PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ নভে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ ফেব, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ নভে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ নভে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or aib finance limited
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    "Needles house" birmingham road studley warwickshire and the goodwill and connection of any business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Allied Irish Banks PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ নভে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ ফেব, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ নভে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ নভে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to allied irish banks,P.L.C. In its capacity as trustee for itself and aib finance limited and/or aib finance limited on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Allied Irish Banks PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ নভে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ ফেব, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Single debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ সেপ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ অক্টো, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ অক্টো, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ জুন, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    GEAC ENTERPRISE SOLUTIONS DEVELOPMENT LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৩ অক্টো, ২০১২ভেঙে গেছে
    ২৬ মার্চ, ২০১২ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Robin Arthur Ellis
    R.A.Ellis & Co
    9 The Elms
    KT10 0JT Church Road
    Claygate Surrey.
    অভ্যাসকারী
    R.A.Ellis & Co
    9 The Elms
    KT10 0JT Church Road
    Claygate Surrey.

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0