SHOPPING CENTRES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামSHOPPING CENTRES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02230056
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    SHOPPING CENTRES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ভবন নির্মাণ প্রকল্প উন্নয়ন (41100) / নির্মাণ

    SHOPPING CENTRES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    SHOPPING CENTRES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    SIDEPLOY LIMITED১৪ মার্চ, ১৯৮৮১৪ মার্চ, ১৯৮৮

    SHOPPING CENTRES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০২১

    SHOPPING CENTRES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ১৭ মার্চ, ২০২২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    5 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ১১ মার্চ, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Darren Windsor Richards এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ০৫ জুন, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ০৫ জুন, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    অডিট ছাড় সহায়ক হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    206 পৃষ্ঠাPARENT_ACC

    legacy

    1 পৃষ্ঠাAGREEMENT2

    legacy

    3 পৃষ্ঠাGUARANTEE2

    ০৫ জুন, ২০১৯ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    ৩১ মার্চ, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Charles Sheridan Alexander Maudsley এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২১ মার্চ, ২০১৯ তারিখে Mr Darren Windsor Richards-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    অডিট ছাড় সহায়ক হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    186 পৃষ্ঠাPARENT_ACC

    legacy

    1 পৃষ্ঠাAGREEMENT2

    legacy

    3 পৃষ্ঠাGUARANTEE2

    ০৫ জুন, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    অডিট ছাড় সহায়ক হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    SHOPPING CENTRES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইউকে লিমিটেড কোম্পানি
    নিবন্ধন নম্বর8992198
    187856670001
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United KingdomBritish58016770004
    LEWIS, Bryan
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United KingdomBritish58257940002
    BAILEY, John Anthony
    Games Road
    EN4 9HX Barnet
    Ludgrove Hall 61-65
    Hertfordshire
    সচিব
    Games Road
    EN4 9HX Barnet
    Ludgrove Hall 61-65
    Hertfordshire
    British134568600001
    DERRETT, Sarah
    161a Conway Road
    Southgate
    N14 7BH London
    সচিব
    161a Conway Road
    Southgate
    N14 7BH London
    British50906270001
    DINGLEY, Nigel Albert
    22 Lyon Meadow
    Steeple Bumpstead
    CB9 7BY Haverhill
    Suffolk
    সচিব
    22 Lyon Meadow
    Steeple Bumpstead
    CB9 7BY Haverhill
    Suffolk
    British49198220001
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    সচিব
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    161590760001
    FIELD, Martin John
    1 Hole Farm Cottages
    Albury Hall Park Albury
    SG11 2JE Ware
    Hertfordshire
    সচিব
    1 Hole Farm Cottages
    Albury Hall Park Albury
    SG11 2JE Ware
    Hertfordshire
    British71986450002
    FIELD, Martin John
    6 Jeffries Road
    SG12 7BB Ware
    Hertfordshire
    সচিব
    6 Jeffries Road
    SG12 7BB Ware
    Hertfordshire
    British71986450001
    FIELD, Martin John
    1 Hole Farm Cottages
    Albury Hall Park Albury
    SG11 2JE Ware
    Hertfordshire
    সচিব
    1 Hole Farm Cottages
    Albury Hall Park Albury
    SG11 2JE Ware
    Hertfordshire
    British71986450002
    O'KEEFE, Helen Jane
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    সচিব
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    British96031250001
    SANKAR, Nadine Amanda
    90 Ebury Road
    WD17 2SB Watford
    সচিব
    90 Ebury Road
    WD17 2SB Watford
    British72917320001
    AGER, Rowley Stuart
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritish72555850002
    BENJAMIN, Victor Woolf
    The End House Sandy Lane
    Colemans Hatch
    TN7 4ER Hartfield
    East Sussex
    পরিচালক
    The End House Sandy Lane
    Colemans Hatch
    TN7 4ER Hartfield
    East Sussex
    British35534960001
    BURTON, Nigel
    Farfield Farm
    Farfield Lane Cricklade
    SN6 6HZ Swindon
    Wiltshire
    পরিচালক
    Farfield Farm
    Farfield Lane Cricklade
    SN6 6HZ Swindon
    Wiltshire
    British38714610001
    CAREY, Roger William
    Instow
    Burtons Way
    HP8 4BP Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Instow
    Burtons Way
    HP8 4BP Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish6069370001
    CLARK, Alistair Ewan, Mr.
    Delamare Road
    Cheshunt
    EN8 9SL Waltham Cross
    Tesco House
    Herts.
    United Kingdom
    পরিচালক
    Delamare Road
    Cheshunt
    EN8 9SL Waltham Cross
    Tesco House
    Herts.
    United Kingdom
    United KingdomBritish160520990001
    EADE, Graham Peter
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandNew Zealander160597430001
    EARP, Neil Timothy
    Tesco Plc
    Tesco House, Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Herts.
    পরিচালক
    Tesco Plc
    Tesco House, Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Herts.
    British83045240002
    EGGS, Anthony John
    Beechwood House 15 Royse Grove
    SG8 9EP Royston
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Beechwood House 15 Royse Grove
    SG8 9EP Royston
    Hertfordshire
    British51584220001
    FORSHAW, Christopher Michael John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    EnglandBritish1898090001
    GIBNEY, John
    Kitsbury Terrace
    HP4 3EE Berkhamstead
    9
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Kitsbury Terrace
    HP4 3EE Berkhamstead
    9
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrish194216530001
    HEAWOOD, John Anthony Nicholas
    South View Road
    HA5 3YB Pinner
    Gateway
    Middlesex
    পরিচালক
    South View Road
    HA5 3YB Pinner
    Gateway
    Middlesex
    United KingdomBritish133123780001
    HOWELL, Robert
    30 Beech Drive
    N2 9NY London
    পরিচালক
    30 Beech Drive
    N2 9NY London
    British67469070001
    KINGSTON, Richard David
    4 Rookes
    Little Walden Road
    CB10 2EP Saffron Walden
    Essex
    পরিচালক
    4 Rookes
    Little Walden Road
    CB10 2EP Saffron Walden
    Essex
    British10789160001
    LU, Hongyan Echo
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomChinese171720380001
    MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish58478890003
    MERCER, Paul Vincent
    Clearwater Chapel Road
    Rowledge
    GU10 4AN Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    Clearwater Chapel Road
    Rowledge
    GU10 4AN Farnham
    Surrey
    British50858220001
    MOURANT, Nicholas Claud
    Tesco House
    Delamare Road Cheshunt
    EN8 9SL Waltham Cross
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Tesco House
    Delamare Road Cheshunt
    EN8 9SL Waltham Cross
    Hertfordshire
    United KingdomBritish67463160002
    OSBORN, Gareth John
    2 Orchard Coombe
    RG8 7QL Whitchurch Hill
    Oxfordshire
    পরিচালক
    2 Orchard Coombe
    RG8 7QL Whitchurch Hill
    Oxfordshire
    British91257750001
    PENFOLD, Julia
    33 Gurney Drive
    N2 0DF London
    পরিচালক
    33 Gurney Drive
    N2 0DF London
    British67318640001
    POTTS, Anthony Bernard Joseph
    18 Oaklands Rise
    AL6 0RN Welwyn
    Hertfordshire
    পরিচালক
    18 Oaklands Rise
    AL6 0RN Welwyn
    Hertfordshire
    British13384100001
    REID, David Edward
    Butler House
    Trinity Lane
    EN8 7EQ Waltham Cross
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Butler House
    Trinity Lane
    EN8 7EQ Waltham Cross
    Hertfordshire
    British1485630002
    RICHARDS, Darren Windsor
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    EnglandBritish108462010003
    RIGBY, Steven Andrew
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Waltham Cross
    পরিচালক
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Waltham Cross
    United KingdomBritish161159630001

    SHOPPING CENTRES LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Tbl Properties Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland & Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানEngland & Wales
    নিবন্ধন নম্বর3863190
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    SHOPPING CENTRES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ সেপ, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ সেপ, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale, London Branch (Facility Agent) as Agent and Trustee for the Finance Parties
    ব্যবসায়
    • ১২ সেপ, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ০৭ অক্টো, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ জানু, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ জানু, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee under the finance documents (as defined) and/or any hedging agreement (as defined) except for any obligation which if it were so included would result in a contravention of section 151 of the company act 1985
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Charged by way of a floating charge all its undertaking property (including real property) assets and rights present and future (including uncalled capital) wherever situated. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ জানু, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ সেপ, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Supplemental charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ জানু, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জানু, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the banks (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the loan agreement and/or the debenture both dated 20TH january 1989
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The new property being f/h land and buildings situate on the eastern side of bennion road, leicester k/a the beaumont shopping centre, beaumont leys, leicester. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Kleinwort Benson Limited (As Agent and Trustee for and on Behalf of the Banks)
    ব্যবসায়
    • ১৮ জানু, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Trust deed
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জানু, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ ফেব, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £15,000,000 "a" mortgage debenture stock 2001, £20,000,000 "b" mortgage debenture stock 2001 and £8,000,000 "c"mortgage debenture stock 2001 and all other monies intended to be secured by the trust deed.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H surrey quays shopping redriff road, london SE16. F/h, clifton moor shopping centre, york. L/h, the beaumont centre, beaumont leys, leicester title no lt 153023 (for details see form 395 and continuation sheet relevant to this charge).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Prudential Assurance Company Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ ফেব, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৭ নভে, ১৯৯৭বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৭ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৬ জানু, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জানু, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জানু, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement and mortgage both dated 20/1/89 and this charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed charge, by way of legal mortgage ranking first in order of priority each and every part of the properties indicated on the continuation sheets attached to the form 395 ref: M224 together with all buildings, erections or structures at any time thereon and all landlords fixtures, fittings, fixtures, plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Kleinwort Benson Limited
    ব্যবসায়
    • ২৭ জানু, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৭ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জানু, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জানু, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement and mortgage both dated 20/1/89 and this charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Kleinwort Benson Limited
    ব্যবসায়
    • ২৭ জানু, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৭ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0