ROVARD FACILITIES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামROVARD FACILITIES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02235222
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ROVARD FACILITIES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • কার এবং হালকা মোটর গাড়ি ভাড়া এবং লীজিং (77110) / প্রশাসনিক এবং সহায়ক পরিষেবা কার্যক্রম

    ROVARD FACILITIES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    James House
    55 Welford Road
    LE2 7AR Leicester
    Leicestershire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ROVARD FACILITIES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    DRYWOOD LIMITED২৪ মার্চ, ১৯৮৮২৪ মার্চ, ১৯৮৮

    ROVARD FACILITIES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১১

    ROVARD FACILITIES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ৩০ জুল, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ০২ এপ্রি, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Steven Mark Johnson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ০২ এপ্রি, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Gary Neil Smith-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৭ ফেব, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Jane Colton এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ২৭ ফেব, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Kenneth Stanley Mccall-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Mark Cotterill এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৭ ফেব, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Jane Margaret Colton-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH03

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Steven Mark Johnson-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Mark John Cotterill-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    ROVARD FACILITIES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MCCALL, Kenneth Stanley
    Aldenham Road
    WD23 2QQ Bushey
    77-85
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Aldenham Road
    WD23 2QQ Bushey
    77-85
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector156180730001
    SMITH, Gary Neil
    55 Welford Road
    LE2 7AR Leicester
    James House
    Leicestershire
    পরিচালক
    55 Welford Road
    LE2 7AR Leicester
    James House
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector157695700001
    BARNES, John Charlton
    Pinehurst Felcourt Road
    Felcourt
    RH19 2LA East Grinstead
    West Sussex
    সচিব
    Pinehurst Felcourt Road
    Felcourt
    RH19 2LA East Grinstead
    West Sussex
    British2951340001
    BATCHELOR, Paul William Richard
    32 Hazelton Road
    Marlbrook
    B61 0JE Bromsgrove
    Worcestershire
    সচিব
    32 Hazelton Road
    Marlbrook
    B61 0JE Bromsgrove
    Worcestershire
    BritishGeneral Manager29542990001
    COLTON, Jane Margaret
    55 Welford Road
    LE2 7AR Leicester
    James House
    Leicestershire
    England
    সচিব
    55 Welford Road
    LE2 7AR Leicester
    James House
    Leicestershire
    England
    British35540850004
    EVANS, Margaret Janet
    17 Coniston Way
    RH2 0LN Reigate
    Surrey
    সচিব
    17 Coniston Way
    RH2 0LN Reigate
    Surrey
    British2289880001
    HEWITSON, Anthony James
    149 Maney Hill Road
    B72 1JW Sutton Coldfield
    West Midlands
    সচিব
    149 Maney Hill Road
    B72 1JW Sutton Coldfield
    West Midlands
    British79407560001
    PALMER, Helen Elizabeth
    22 Croftdown Road
    B17 8RB Birmingham
    West Midlands
    সচিব
    22 Croftdown Road
    B17 8RB Birmingham
    West Midlands
    BritishChartered Accountant69052940001
    SAYWARD, Glenn Martin
    32 Waverley Road
    NG18 5AG Mansfield
    Nottinghamshire
    সচিব
    32 Waverley Road
    NG18 5AG Mansfield
    Nottinghamshire
    British41017820001
    MABLAW CORPORATE SERVICES LIMITED
    21 Station Road
    WD17 1HT Watford
    Hertfordshire
    কর্পোরেট সচিব
    21 Station Road
    WD17 1HT Watford
    Hertfordshire
    52303360001
    BARRY, Marie, Mrs.
    Englewood
    7 Bletchley Road
    LU7 0ER Stewkley
    Bucks
    পরিচালক
    Englewood
    7 Bletchley Road
    LU7 0ER Stewkley
    Bucks
    United KingdomIrishManaging Director123866570002
    BATCHELOR, Paul William Richard
    32 Hazelton Road
    Marlbrook
    B61 0JE Bromsgrove
    Worcestershire
    পরিচালক
    32 Hazelton Road
    Marlbrook
    B61 0JE Bromsgrove
    Worcestershire
    BritishGeneral Manager29542990001
    BATCHELOR, Paul William Richard
    32 Hazelton Road
    Marlbrook
    B61 0JE Bromsgrove
    Worcestershire
    পরিচালক
    32 Hazelton Road
    Marlbrook
    B61 0JE Bromsgrove
    Worcestershire
    BritishGeneral Manager29542990001
    BAUNACK, Albert Wilhelm Uwe
    15 Rue Marcel Ballasse
    Margny-Les-Compiegne
    FOREIGN France
    পরিচালক
    15 Rue Marcel Ballasse
    Margny-Les-Compiegne
    FOREIGN France
    GermanDirector48909040001
    COTTERILL, Mark John
    Aldenham Road
    WD23 2QQ Bushey
    Europcar House
    Watford
    England
    পরিচালক
    Aldenham Road
    WD23 2QQ Bushey
    Europcar House
    Watford
    England
    United KingdomBritishDirector126885690001
    DEPOIS, Thierry
    4bis Rue Revert
    95300 Pontoise
    FOREIGN France
    পরিচালক
    4bis Rue Revert
    95300 Pontoise
    FOREIGN France
    FrenchCorp Marketing/ Sales Director54853950001
    DU MONCEAU DE BERGENDAL, John Maurice Gabriel
    9 Rue Victor Hugo
    Jouy-En-Josas
    Les Yvelines 78000
    France
    পরিচালক
    9 Rue Victor Hugo
    Jouy-En-Josas
    Les Yvelines 78000
    France
    FrenchDirector46710400001
    FITCH, John Derek
    Douglas Cottage
    Coombe End
    KT2 7DQ Kingston
    Surrey
    পরিচালক
    Douglas Cottage
    Coombe End
    KT2 7DQ Kingston
    Surrey
    BritishExecutive Manager8461210001
    FLEMING, Paul Scott
    Apartment 244 Royal Drive
    Princess Park Manor
    N11 3FT London
    পরিচালক
    Apartment 244 Royal Drive
    Princess Park Manor
    N11 3FT London
    BritishManaging Director73871570003
    JOHNSON, Steven Mark
    Aldenham Road
    WD23 2QQ Bushey
    Europcar House
    Watford
    England
    পরিচালক
    Aldenham Road
    WD23 2QQ Bushey
    Europcar House
    Watford
    England
    United KingdomBritishDirector137622810001
    KERN, Michael, Dr
    Auestrasse 90
    52382 Niederzier
    Germany
    পরিচালক
    Auestrasse 90
    52382 Niederzier
    Germany
    BritishChief Executive70370910001
    KING SMITH, Terence Peter
    The Field House
    Snowshill
    WR12 7JT Broadway
    Worcestershire
    পরিচালক
    The Field House
    Snowshill
    WR12 7JT Broadway
    Worcestershire
    BritishCompany Director30203050001
    LEIGH, John Simon
    Priory House
    Priory Road
    SL5 9RQ Sunningdale
    Berkshire
    পরিচালক
    Priory House
    Priory Road
    SL5 9RQ Sunningdale
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector119920050001
    MASAI, Pierre Jean Andre
    Avenue De L Opale 73
    FOREIGN Brussels
    1030
    Belgium
    পরিচালক
    Avenue De L Opale 73
    FOREIGN Brussels
    1030
    Belgium
    BelgianCorp It Dir Of Europcar Inter76994760001
    NEVILLE, Robert Stanley
    Borrowell Borrowell Lane
    CV8 1ER Kenilworth
    Warwickshire
    পরিচালক
    Borrowell Borrowell Lane
    CV8 1ER Kenilworth
    Warwickshire
    BritishExecutive8259110001
    NEVILLE, Robert Stanley
    Borrowell Borrowell Lane
    CV8 1ER Kenilworth
    Warwickshire
    পরিচালক
    Borrowell Borrowell Lane
    CV8 1ER Kenilworth
    Warwickshire
    BritishExecutive8259110001
    NOACK, Gerhard
    2 Avenue Octave
    FOREIGN Greard
    75007 Paris
    France
    পরিচালক
    2 Avenue Octave
    FOREIGN Greard
    75007 Paris
    France
    GermanDirector71949080001
    OSTROWSKI, Stefan
    20 Avenue Thery
    92420 Vaucresson
    France
    পরিচালক
    20 Avenue Thery
    92420 Vaucresson
    France
    GermanChief Information Officer85010670001
    PALMER, Helen Elizabeth
    22 Croftdown Road
    B17 8RB Birmingham
    West Midlands
    পরিচালক
    22 Croftdown Road
    B17 8RB Birmingham
    West Midlands
    BritishChartered Accountant69052940001
    RAFAEL, Girona
    8 Rue Roger Bacon
    75017 Paris
    Paris
    France
    পরিচালক
    8 Rue Roger Bacon
    75017 Paris
    Paris
    France
    FranceSpanishCorp Op Dir Of Europcar Inter76995130003
    ROSE, Harry Anthony
    The Old School House
    Old School Lane Lighthorne
    CV35 0AX Warwick
    পরিচালক
    The Old School House
    Old School Lane Lighthorne
    CV35 0AX Warwick
    BritishFinance Director27476440003
    SAYWARD, Glenn Martin
    32 Waverley Road
    NG18 5AG Mansfield
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    32 Waverley Road
    NG18 5AG Mansfield
    Nottinghamshire
    BritishFinance Director41017820001
    SLADE, Arthur Geoffrey
    Field House
    Horsham Road
    BN44 3AE Steyning
    West Sussex
    পরিচালক
    Field House
    Horsham Road
    BN44 3AE Steyning
    West Sussex
    BritishFinance Director72709160001
    SMITH, John Stephen
    The Coach House
    26 Kenilworth Road
    CV32 6JB Leamington Spa
    Warwickshire
    পরিচালক
    The Coach House
    26 Kenilworth Road
    CV32 6JB Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishDirector8259150002
    WOODHOUSE, John Graham
    The Lake House
    Breach Lane
    CV35 8QB Claverdon
    Warwickshire
    পরিচালক
    The Lake House
    Breach Lane
    CV35 8QB Claverdon
    Warwickshire
    BritishDirector4882030002

    ROVARD FACILITIES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ জুন, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ জুন, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 1212 stockport road levenshulme manchester t/n LA266831 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ জুন, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ সেপ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ জুন, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ জুন, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ জুন, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ ফেব, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0