FRIARS HOUSE INVESTMENTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামFRIARS HOUSE INVESTMENTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিসক্রিয়
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02250022
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    FRIARS HOUSE INVESTMENTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিজস্ব রিয়েল এস্টেট কেনাবেচা (68100) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম
    • নিজস্ব বা ভাড়াকৃত রিয়েল এস্টেটের অন্যান্য ভাড়া এবং পরিচালনা (68209) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম

    FRIARS HOUSE INVESTMENTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    50 Marshall Street
    C/O Newcore Capital Management Llp
    W1F 9BQ London
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    FRIARS HOUSE INVESTMENTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    RACESHIELD LIMITED২৯ এপ্রি, ১৯৮৮২৯ এপ্রি, ১৯৮৮

    FRIARS HOUSE INVESTMENTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণনা
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ ডিসে, ২০২৪
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩০ সেপ, ২০২৫
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০২৩

    FRIARS HOUSE INVESTMENTS LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে১৩ জুল, ২০২৫
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে২৭ জুল, ২০২৫
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে১৩ জুল, ২০২৪
    মেয়াদোত্তীর্ণনা

    FRIARS HOUSE INVESTMENTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    ১৩ জুল, ২০২৪ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২৩ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    চার্জ নিবন্ধন 022500220024, ২০ ডিসে, ২০২৩ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    35 পৃষ্ঠাMR01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি

    23 পৃষ্ঠাAA

    সম্পত্তি বা উদ্যোগের একটি অংশ মুক্ত করা হয়েছে এবং আর চার্জ 022500220023 এর অংশ নয়

    2 পৃষ্ঠাMR05

    ১৩ জুল, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ০১ জানু, ২০২৩ তারিখে Newcore Capital Management Llp-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH04

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    ১৩ জুল, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    সমিতির এবং সংবিধির নথি

    13 পৃষ্ঠাMA

    চার্জ 022500220018 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 022500220019 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 022500220017 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 022500220020 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 022500220021 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 022500220022 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ নিবন্ধন 022500220023, ০৬ মে, ২০২২ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    40 পৃষ্ঠাMR01

    ০৫ আগ, ২০২১ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 3 Fitzhardinge Street London W1H 6EF England থেকে 50 Marshall Street C/O Newcore Capital Management Llp London W1F 9BQপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    ১৩ জুল, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ মুক্ত করা হয়েছে এবং আর চার্জ 022500220021 এর অংশ নয়

    1 পৃষ্ঠাMR05

    ০১ জানু, ২০২১ তারিখে Newcore Capital Management Llp-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH04

    ১০ অক্টো, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Hugo William John Llewelyn এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৯ সেপ, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Alexandra Clare Houghton-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    FRIARS HOUSE INVESTMENTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    NEWCORE CAPITAL MANAGEMENT LLP
    Marshall Street
    W1F 9BQ London
    50
    England
    কর্পোরেট সচিব
    Marshall Street
    W1F 9BQ London
    50
    England
    আইনি ফর্মLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    পরিচয়পত্রের ধরনঅন্যান্য কর্পোরেট বডি বা ফার্ম
    আইনি কর্তৃপক্ষLIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS ACT 2000
    নিবন্ধন নম্বরOC368756
    189385590001
    HOUGHTON, Alexandra Clare
    Marshall Street
    C/O Newcore Capital Management Llp
    W1F 9BQ London
    50
    England
    পরিচালক
    Marshall Street
    C/O Newcore Capital Management Llp
    W1F 9BQ London
    50
    England
    EnglandEnglishChartered Surveyor274204580001
    NEWCOMBE, Robert William
    Marshall Street
    C/O Newcore Capital Management Llp
    W1F 9BQ London
    50
    England
    পরিচালক
    Marshall Street
    C/O Newcore Capital Management Llp
    W1F 9BQ London
    50
    England
    EnglandBritishBarrister61763650007
    NOTTINGHAM, Mathew Paul
    Church View Cottage
    8 The Maltings Ashley
    LE16 8HW Market Harborough
    Leicestershire
    সচিব
    Church View Cottage
    8 The Maltings Ashley
    LE16 8HW Market Harborough
    Leicestershire
    BritishAccountant21753020003
    SEDGWICK, John Michael
    2 Curzon Close
    BR6 9NP Orpington
    Kent
    সচিব
    2 Curzon Close
    BR6 9NP Orpington
    Kent
    British14084690001
    LLEWELYN, Hugo William John
    Fitzhardinge Street
    W1H 6EF London
    3
    England
    পরিচালক
    Fitzhardinge Street
    W1H 6EF London
    3
    England
    EnglandBritishFund Manager163647930001
    NEWCOMBE, Edward Mark
    Bakersgate Ash Road
    Pirbright
    GU24 0NA Woking
    Surrey
    পরিচালক
    Bakersgate Ash Road
    Pirbright
    GU24 0NA Woking
    Surrey
    EnglandBritishChartered Surveyor14084700002
    NEWCOMBE, John Langton
    39 Manor Road
    EN5 2JQ Barnet
    Hertfordshire
    পরিচালক
    39 Manor Road
    EN5 2JQ Barnet
    Hertfordshire
    BritishSolicitor14084710001
    NOTTINGHAM, Mathew Paul
    Church View Cottage
    8 The Maltings Ashley
    LE16 8HW Market Harborough
    Leicestershire
    পরিচালক
    Church View Cottage
    8 The Maltings Ashley
    LE16 8HW Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritishChartered Secretary21753020003
    SEDGWICK, John Michael
    2 Curzon Close
    BR6 9NP Orpington
    Kent
    পরিচালক
    2 Curzon Close
    BR6 9NP Orpington
    Kent
    BritishCompany Director14084690001
    SIMON, Timothy John Adams
    GL54 2PN Wyck Rissington
    Maces Cottage
    Gloucestershire
    পরিচালক
    GL54 2PN Wyck Rissington
    Maces Cottage
    Gloucestershire
    United KingdomBritishCompany Director2325840002

    FRIARS HOUSE INVESTMENTS LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Fitzhardinge Street
    W1H 6EF London
    3
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Fitzhardinge Street
    W1H 6EF London
    3
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশUk
    আইনি কর্তৃপক্ষCompany Law
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর86894
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    FRIARS HOUSE INVESTMENTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ২০২৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ২০২৩
    বকেয়া
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The freehold property known as units 1-3 wessex industrial estate, bourne end, buckinghamshire, SL8 5DT registered at hm registry with title number BM117411. The freehold property known as millbrook service station, millbrook road west, southampton, SO15 0JU registered at hm registry with title number HP651779.
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC (As Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ২০ ডিসে, ২০২৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ মে, ২০২২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ মে, ২০২২
    বকেয়া
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The freehold land and buildings known as retail store and petrol filling station, branbridges road, east peckham, tonbridge TN12 5HH as registered at the land registry under title number K868993. The freehold land and buildings on the east side of netham road, st annes, bristol BS5 9PQ as registered at the land registry under title numbers BL54825, BL83015 and BL103480. The freehold property known as 118 blackswarth road, st george, bristol BS5 8AU as registered at the land registry under title numbers AV61758 and AV193568. The lease of the land and buildings known as retail store and petrol filling station, branbridges road, east peckham, tonbridge TN12 5HH as registered at the land registry under title number TT30938. The lease of the land and buildings on the east side of netham road, st annes, bristol BS5 9PQ as registered at the land registry under title number BL140293. The lease of 118 blackswarth road, st george, bristol BS5 8AU as registered at the land registry under title number BL147664. The lease of 118 blackswarth road, st george, bristol BS5 8AU as registered at the land registry under title number BL141363.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC (As Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ১০ মে, ২০২২একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ২৭ জুল, ২০২৩সম্পত্তির একটি অংশ বা উদ্যোগ মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং আর চার্জের অংশ নয় (MR05)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ডিসে, ২০১৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জানু, ২০১৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The freehold property known as units 10-15 petersfield business park, hampshire, GU32 3QA registered at the land registry under title number HP397013. The leasehold property known as 1ST, 2ND and 3RD floors, 11/12 westgate buildings, bath, BA1 1EB registered at the land registry under title number ST297684. For more details of the other land, ship, aircraft and intellectual property charged, please refer to the instrument.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ জানু, ২০১৮একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ০৭ আগ, ২০১৮সম্পত্তির একটি অংশ বা উদ্যোগ মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং আর চার্জের অংশ নয় (MR05)
    • ৩০ মে, ২০২২একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ আগ, ২০১৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ আগ, ২০১৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The freehold land and buildings known as block a, new bond house, bond street, bristol BS2 9AG and registered at the land registry with title numbers AV77524, BL30149, BL28055, BL37276 and BL34368. For more details of the land, ship, aircraft and intellectual property charged, please refer to the instrument.
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ আগ, ২০১৭একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ২৩ জুল, ২০২১সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং আর চার্জের অংশ নয় (MR05)
    • ৩০ মে, ২০২২একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ মার্চ, ২০১৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ মার্চ, ২০১৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The freehold land and buildings known as 11, 11A and 12 westgate street, bath BA1 1EQ and registered at the land registry with title number ST285187. For more details of the land, ship, aircraft and intellectual property charged, please refer to the instrument.
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ মার্চ, ২০১৭একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ৩০ মে, ২০২২একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ২০১৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ অক্টো, ২০১৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The freehold land and buildings known as retail store and petrol filling station, branbridges road, east peckham, tonbridge, TN12 5HH registered at the land registry with title number K868993. For more details of the land, ship, aircraft and intellectual property charged, please refer to the instrument.
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ অক্টো, ২০১৬একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ৩০ মে, ২০২২একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১২ মে, ২০১৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মে, ২০১৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Carbase, netham road, bristol BS5 9PQ and auto centre, 118 blackswarth road, bristol BS5 8AG.
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ মে, ২০১৬একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ৩০ মে, ২০২২একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ জুল, ২০১৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ জুল, ২০১৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land including f/h units 10-15 petersfield business park hampshire t/no HP397013.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ জুল, ২০১৫একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ৩০ মে, ২০২২একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ জুন, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুল, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a land on the north west side of homefield road, haverhill t/no SK322017 all plant and machinery owned by the borrower and its interest in any plant and machinery. All fixtures and fittings all other chattels and all benefits in respect of the insurances including claims and the refund of any premiums.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুল, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০৩ জুল, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১০ নভে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ নভে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land k/a phase 1, homefield road, haverhill, suffolk t/no SK250706, and each and every part thereof and all buildings erections and structures and fixtures and fittings and fixed plant and machinery and with the benefit of all existing and future leases underleaeses tenancies agreements for lease rights covenants undertakings warranties floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixed charge all the benefit of and the right to enforce all contracts and agreements for the sale purchase leasing mortgaging management or other dealing with the mortgaged property all rents and licence fees floating charge all the other property assets and rights of the company. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    ব্যবসায়
    • ২৩ নভে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ জুল, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ অক্টো, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ নভে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The rotunda ware road hertford t/no HD280798 fixtures and fittings all moveable plant and machinery all contacts and agreements all rents the proceeds of all insurances floating charge the property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Svenska Handelsbanken (Publ)
    ব্যবসায়
    • ০২ নভে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জুল, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ অক্টো, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ নভে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings on the north side of parkhouse road newcastle under lyme t/no SF171912 fixtures and fittings all moveable plant and machinery all contacts and agreements all rents the proceeds of all insurances floating charge the property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Svenska Handelsbanken (Publ)
    ব্যবসায়
    • ০২ নভে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জুল, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ অক্টো, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ নভে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings on the north west side of gilcar way and unit b gilcar way valencia park wakefield t/nos WYK664813 and WYK652782 fixtures and fittings all moveable plant and machinery all contacts and agreements all rents the proceeds of all insurances floating charge the property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Svenska Handelsbanken (Publ)
    ব্যবসায়
    • ০২ নভে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জুল, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Memorandum of security over cash deposits
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ অক্টো, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ অক্টো, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First fixed charge the deposit and each and every debt represented by the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    ব্যবসায়
    • ২০ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জুল, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deed of charge over securities
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company (or any person who is a party to any related security document) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the issued share capital of friars house investments (telford) limited, being 1 ordinary share of £1 each, any other shares stocks securities, interest dividends bonus issues.... See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ মে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Supplemental legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land being the rotunda ware road hertford in the county of hertfordshire t/n HD280798 and all buildings fixtures fittings.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ মে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জানু, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h land and buildings on the north west side of gilcar way wakefield title absolute t/n WYK664813, unit b gilcar way valencia park wakefield title absolute t/n WYK652782 (for further details please see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ জানু, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ মে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Memorandum of security
    তৈরি করা হয়েছে ১১ ফেব, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All amounts from time to time standing to the credit of the company with the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Svenska Handelsbanken
    ব্যবসায়
    • ১৪ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment by way of security.
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ ডিসে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ জানু, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 15/11/90.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Agreement dated 13TH december 1990 between friars house investments limited and midland bank PLC in respect of an interest rate cap.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Svenska Handelsbanken
    ব্যবসায়
    • ০৩ জানু, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৭ ডিসে, ২০০১বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৪ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ ডিসে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Liabilities on a full and unlimited indemnity basis. Together in each of the cases mentioned herein with all interest being computed in each such case according to the usual mode of the bank so that interest shall be payable at the same rate as well as before judgement.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Svenska Handlesbanken PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ ডিসে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৭ ডিসে, ২০০১বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১১ ফেব, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ ডিসে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h property situate at and known as friars house warwick road coventry under title number: wm 469509.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Svenska Handelsbanken PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ ডিসে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৭ ডিসে, ২০০১বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৪ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment by way of security
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ ডিসে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £5,750,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a contractural agreement dated 13/12/1990
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    An agreement dated 13 december 1990 between friars house investments limited and midland montagu in respect of an interest rate cap.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Svenska Handelsbanken PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ ডিসে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৭ ডিসে, ২০০১বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৪ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ জুন, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জুন, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the undertaking, property and assets of the company whatsoever and wheresoever present and future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ জুন, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ এপ্রি, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Friars house at the junction of warwick road and ringway point patricks, coventry, west midlands title no wm 469509.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ মে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৪ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0