LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামLANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02258411
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7415) /

    LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    TEATHER & GREENWOOD HOLDINGS PLC০৩ জুন, ১৯৯৯০৩ জুন, ১৯৯৯
    NRP PLC১১ ফেব, ১৯৯৭১১ ফেব, ১৯৯৭
    NATIONWIDE RESIDENTIAL PROPERTIES PLC১১ সেপ, ১৯৯৬১১ সেপ, ১৯৯৬
    NORTHUMBRIAN RESIDENTIAL PROPERTIES PLC০১ সেপ, ১৯৮৮০১ সেপ, ১৯৮৮
    GILTPRICE PUBLIC LIMITED COMPANY১৬ মে, ১৯৮৮১৬ মে, ১৯৮৮

    LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৭

    LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    9 পৃষ্ঠাLIQ13

    ২২ এপ্রি, ২০১৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    9 পৃষ্ঠাLIQ03

    ২২ এপ্রি, ২০১৭ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    11 পৃষ্ঠাLIQ03

    দেউলিয়া আবেদন

    Insolvency:secretary of state's release of liquidator
    1 পৃষ্ঠাLIQ MISC

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠা600

    ২৮ সেপ, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB থেকে 15 Canada Square London E14 5GLপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার

    2 পৃষ্ঠাAC92

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    4 পৃষ্ঠা4.71

    ২২ এপ্রি, ২০১২ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠা4.68

    ২২ এপ্রি, ২০১১ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠা4.68

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন

    LRESSP

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    অডিটরের পদত্যাগ

    2 পৃষ্ঠাAUD

    অডিটরের পদত্যাগ

    2 পৃষ্ঠাAUD

    legacy

    5 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    VALTYSSON, Balvin
    South Parade
    WY 5LH Ealing
    54
    London
    সচিব
    South Parade
    WY 5LH Ealing
    54
    London
    Icelandic140600340001
    HAFSTEINSSON, Arsaell
    Fjardarsel 5
    Reykjavik
    109
    Iceland
    পরিচালক
    Fjardarsel 5
    Reykjavik
    109
    Iceland
    Icelandic137091830001
    VALTYSSON, Balvin
    South Parade
    WY 5LH Ealing
    54
    London
    পরিচালক
    South Parade
    WY 5LH Ealing
    54
    London
    Icelandic140600340001
    DEVLIN, Hugh Gerard
    Locksfield
    Ashes Lane
    TN11 0AN Hadlow
    Kent
    সচিব
    Locksfield
    Ashes Lane
    TN11 0AN Hadlow
    Kent
    British49516630002
    PARKER, Hilary Anne
    3 North Jesmond Avenue
    Jesmond
    NE2 3JX Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    সচিব
    3 North Jesmond Avenue
    Jesmond
    NE2 3JX Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British5986850001
    STOCKS, Timothy Edward
    6 Camlet Way
    AL3 4TL St Albans
    Hertfordshire
    সচিব
    6 Camlet Way
    AL3 4TL St Albans
    Hertfordshire
    British43135190001
    WEIR, Bruce Allan
    Bow Bells House
    1 Bread Street
    EC4M 9BF London
    সচিব
    Bow Bells House
    1 Bread Street
    EC4M 9BF London
    British95838730006
    ARNASON, Sigurjon Thorvaldur
    Bow Bells House
    1 Bread Street
    EC4M 9BF London
    পরিচালক
    Bow Bells House
    1 Bread Street
    EC4M 9BF London
    Icelandic104840900003
    ASHFIELD, Philip John Christopher
    South End House
    Ockham
    GU23 6PF Woking
    Surrey
    পরিচালক
    South End House
    Ockham
    GU23 6PF Woking
    Surrey
    United KingdomBritish47364730001
    BAKER, Kenneth Wilfred, The Rt Hon Lord
    Teather & Greenwood Ltd
    Beaufort House 15 St Botolph Street
    EC3A 7QR London
    পরিচালক
    Teather & Greenwood Ltd
    Beaufort House 15 St Botolph Street
    EC3A 7QR London
    British77976620003
    BARBER, Alan John
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    পরিচালক
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United KingdomBritish101849290001
    BOOTHMAN, Derek Arnold
    Ashworth Dene
    Wilmslow Road Mottram St Andrew
    SK10 4QH Macclesfield
    Cheshire
    পরিচালক
    Ashworth Dene
    Wilmslow Road Mottram St Andrew
    SK10 4QH Macclesfield
    Cheshire
    British5733500001
    CORNISH, Roland David
    38 Speldhurst Road
    Chiswick
    W4 1BU London
    পরিচালক
    38 Speldhurst Road
    Chiswick
    W4 1BU London
    British22086910003
    DELMAR MORGAN, Jeremy Hugh
    Mulberry Cottage 5 Western Terrace
    W6 9TX London
    পরিচালক
    Mulberry Cottage 5 Western Terrace
    W6 9TX London
    United KingdomBritish58211990001
    DERVILLE, Peter Robin Teichman
    24 River Reach
    TW11 9QL Teddington
    Middlesex
    পরিচালক
    24 River Reach
    TW11 9QL Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish24263450001
    FORD, Eric Kenelm
    15 Tenison Avenue
    CB1 2DX Cambridge
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    15 Tenison Avenue
    CB1 2DX Cambridge
    Cambridgeshire
    British125022680001
    GARSTON, Clive Richard
    Sandy Ridge
    Bollinway Hale
    WA15 0NZ Altrincham
    Cheshire
    পরিচালক
    Sandy Ridge
    Bollinway Hale
    WA15 0NZ Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish12179600001
    GRICE, Peter Richard
    68 Lockesfield Place
    Isle Of Dogs
    E14 3AJ London
    পরিচালক
    68 Lockesfield Place
    Isle Of Dogs
    E14 3AJ London
    British34827780003
    KRISTJANSSON, Halldor Jon
    15 St. Botolph Street
    EC3A 7QR London
    পরিচালক
    15 St. Botolph Street
    EC3A 7QR London
    Icelandic72483590002
    MORGAN, Eric
    96 Runnymede Road
    Ponteland
    NE20 9HH Newcastle Upon Tyne
    পরিচালক
    96 Runnymede Road
    Ponteland
    NE20 9HH Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish14152110001
    REEVE, John Frederick
    Copse Close
    Cedar Road Hook Heath
    GU22 0JJ Woking
    Surrey
    পরিচালক
    Copse Close
    Cedar Road Hook Heath
    GU22 0JJ Woking
    Surrey
    British33562950001
    ROWBOTHAM, Brian
    The Cygnets Wantage Road
    RG8 9LB Streatley On Thames
    Berkshire
    পরিচালক
    The Cygnets Wantage Road
    RG8 9LB Streatley On Thames
    Berkshire
    British58304600003
    SCOTT, George
    5 Beechfield Road
    Gosforth
    NE3 4DR Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    পরিচালক
    5 Beechfield Road
    Gosforth
    NE3 4DR Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish39196280004
    STAGG, Nicholas Simon
    Bow Bells House
    1 Bread Street
    EC4M 9BF London
    পরিচালক
    Bow Bells House
    1 Bread Street
    EC4M 9BF London
    British75782650004

    LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Letter of pledge over shares
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ মে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    800,000 a ordinary shares of £1 each and 200,000 b ordinary of £1 each in teather & greenwood limited plus all bonuses dividends and interest due therein.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৫ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over shares
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মার্চ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    996146 ordinary 10P shares of county of kent developments PLC plus all dividends and interest payable on any of the shares and all stocks shares. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৩ মার্চ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ মার্চ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ মার্চ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First legal charge over: 18 the riding,kenton,newcastle upon tyne and 17 other properties as listed on the schedule. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১১ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    23 castledene court, freeman road, newcastle upon tyne, tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    47, ashleigh grove, high west jesmond newcastle upon tyne tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    2 gowanburn, fatfield, washington, tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    25C osborne avenue pavilion mews, jesmond, newcastle upon tyne tyne and wear togegher with all buildings and fixtures thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    10 orchard place baston terrace, jesmond newcastle upon tyne,tyne and wear together with all buildings and fixtures.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    71 deneside court selbourne gardens jesmond newcastle upont tyne, tyne and wear together with all buildings and fixtures.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    16 orchard place, buston terrace jesmond newcastle upon tyne, tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    6 orchard place buston terrace, jesmond newcastle upon tyne. Tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    74 broadash grey stoke gardens sandyford newcastle upon tyne, tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    21 castledene court, freeman road, newcastle upon tyne, tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    18 the riding kenton newcastle upon tyne, tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    2 orchard place, buston terrace jesmond newcastle upon tyne. Tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    33 victoria mews claremont road newcastle-upon-tyne. Tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    25B osborne avenue pavilion mews jesmond newcastle upon tyne. Tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৫ মার্চ, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    29 deneside court selbourne gardens, jesmond newcastle-upon-tyne tyne and wear together with all buildings and fixtures thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    LANDSBANKI SECURITIES (UK) HOLDINGS PLC এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১২ অক্টো, ২০১৮ভেঙে গেছে
    ২৩ এপ্রি, ২০১০ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    John David Thomas Milsom
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    অভ্যাসকারী
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jeremy Simon Spratt
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    অভ্যাসকারী
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    অভ্যাসকারী
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Allan Watson Graham
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    অভ্যাসকারী
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0