OLD GIROVEND LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামOLD GIROVEND LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02277364
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    OLD GIROVEND LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (9999) /

    OLD GIROVEND LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Challenge House
    International Drive
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Gloucestershire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    OLD GIROVEND LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    GIROVEND LIMITED১৭ ডিসে, ২০০৩১৭ ডিসে, ২০০৩
    G2 INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED ২৩ মে, ২০০৩২৩ মে, ২০০৩
    GIROVEND LIMITED০৪ ফেব, ২০০০০৪ ফেব, ২০০০
    GIROVEND CASHLESS SYSTEMS (UK) LIMITED২১ অক্টো, ১৯৯৭২১ অক্টো, ১৯৯৭
    GIROVEND SYSTEMS LIMITED২৯ সেপ, ১৯৮৮২৯ সেপ, ১৯৮৮
    DINGLEMOOR LIMITED১৪ জুল, ১৯৮৮১৪ জুল, ১৯৮৮

    OLD GIROVEND LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৮

    OLD GIROVEND LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    legacy

    1 পৃষ্ঠা652a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    সমিতির এবং সংবিধির নথি

    6 পৃষ্ঠাMA

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed girovend LIMITED\certificate issued on 29/12/08
    2 পৃষ্ঠাCERTNM

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    1 পৃষ্ঠা225

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা225

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    OLD GIROVEND LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    THORINGTON-JONES, Gary, Mr.
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    সচিব
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    British85541780001
    THORINGTON-JONES, Gary, Mr.
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    পরিচালক
    29 Meadowvale Road
    Lickey End
    B60 1JY Bromsgrove
    Worcestershire
    EnglandBritish85541780001
    WHITELOCK, Noel Keith
    154 Cheltenham Road
    WR11 2LW Evesham
    Worcestershire
    পরিচালক
    154 Cheltenham Road
    WR11 2LW Evesham
    Worcestershire
    United KingdomBritish14940620001
    ALLEN, Matthew Charles
    75 Park Road
    W4 3EY London
    সচিব
    75 Park Road
    W4 3EY London
    British37599910001
    BAILEY, John
    Stockton Grange The Village
    Stockton On The Forest
    YO3 9UW York
    North Yorkshire
    সচিব
    Stockton Grange The Village
    Stockton On The Forest
    YO3 9UW York
    North Yorkshire
    British41823950002
    BANYARD, Alec William James
    17 Hampstead Gardens
    SS5 5HN Hockley
    Essex
    সচিব
    17 Hampstead Gardens
    SS5 5HN Hockley
    Essex
    British32189370001
    FIETH, Robin Paul
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    সচিব
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    British49907850002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    সচিব
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    English107835250001
    KATZ, Peter David
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    সচিব
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    British64682050001
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    সচিব
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    British116252510001
    PECK, Martin David
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    সচিব
    30 Crofton Avenue
    Chiswick
    W4 3EW London
    British78149370002
    WELCH, David Michael Geoffrey
    Inigo House
    29 Bedford Street
    WC2E 9ED London
    সচিব
    Inigo House
    29 Bedford Street
    WC2E 9ED London
    British43153490002
    WELCH, David Michael Geoffrey
    7 Southampton Place
    WC1A 2DR London
    সচিব
    7 Southampton Place
    WC1A 2DR London
    British43153490001
    BARNSLEY, Micheal John
    Church Lane
    Marchington
    ST14 8LJ Uttoxeter
    Buttyard Croft
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Church Lane
    Marchington
    ST14 8LJ Uttoxeter
    Buttyard Croft
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish140579250001
    BUTT, Hanz Helmuth
    Schluchtblick 14
    Johannesberg
    63867
    South Africa
    পরিচালক
    Schluchtblick 14
    Johannesberg
    63867
    South Africa
    German68163180001
    CAMPBELL, Sylvia
    18 Forth Place
    NE1 4EU Newcastle Upon Tyne
    পরিচালক
    18 Forth Place
    NE1 4EU Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish53211510001
    DITCHBURN, John Blackett Dennison
    The Laurels
    Frieth
    RG9 6PJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    পরিচালক
    The Laurels
    Frieth
    RG9 6PJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    British61233990002
    DRUDY, Carmel Ann
    15 Cinnamon Row
    Battersea
    SW11 3TW London
    পরিচালক
    15 Cinnamon Row
    Battersea
    SW11 3TW London
    British40928410001
    FIETH, Robin Paul
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Timbers
    Pyrton
    OX49 5AP Watlington
    Oxfordshire
    EnglandBritish49907850002
    GAHAGNON, Jacques Andre
    92 Place Louvois
    Velizy
    78140
    France
    পরিচালক
    92 Place Louvois
    Velizy
    78140
    France
    French68163380001
    GOVETT, Nigel Jeremy Cloudesley
    15 Tantallon Court
    Woodstone Village
    DH4 6TJ Houghton Le Spring
    County Durham
    পরিচালক
    15 Tantallon Court
    Woodstone Village
    DH4 6TJ Houghton Le Spring
    County Durham
    British89929500001
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandEnglish107835250001
    HARRIS, Glyn
    113-116 Bute Street
    CF1 6SB Cardiff
    South Glamorgan
    পরিচালক
    113-116 Bute Street
    CF1 6SB Cardiff
    South Glamorgan
    British8555610002
    MCGRANE, Paul Steven
    21 Stony Lane
    NR10 4QS Reepham
    Norwich
    পরিচালক
    21 Stony Lane
    NR10 4QS Reepham
    Norwich
    United KingdomBritish51004210002
    MCNAIR, Iain
    23 Mycenae Road
    SE3 7SF London
    Greater London
    পরিচালক
    23 Mycenae Road
    SE3 7SF London
    Greater London
    British85499250001
    MILLS, Mark Richard
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    পরিচালক
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    British10402540005
    MORINAY, Luc Jean Marie
    14 Rue De Tramelay
    Elancourt
    78990
    France
    পরিচালক
    14 Rue De Tramelay
    Elancourt
    78990
    France
    French68163140001
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    পরিচালক
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    EnglandBritish116252510001
    NWOSU HOPE, Nigel Peter
    Lakewood
    Minsteracres
    DH8 9RR Consett
    County Durham
    পরিচালক
    Lakewood
    Minsteracres
    DH8 9RR Consett
    County Durham
    United KingdomBritish64095750001
    PERKINS, Dennis
    18 Spring Grove
    HR8 2XB Ledbury
    Herefordshire
    পরিচালক
    18 Spring Grove
    HR8 2XB Ledbury
    Herefordshire
    United KingdomBritish44490630001
    RICHARDS, Keith
    43 Malford Grove
    Gilwern
    NP7 0RN Abergavenny
    Gwent
    পরিচালক
    43 Malford Grove
    Gilwern
    NP7 0RN Abergavenny
    Gwent
    British25612680001
    SARGENT, Christian William Lance
    26 Cheriton Drive
    Thornhill
    CF14 9DF Cardiff
    South Glamorgan
    পরিচালক
    26 Cheriton Drive
    Thornhill
    CF14 9DF Cardiff
    South Glamorgan
    British68162920001
    SCHOFIELD, Janet Elizabeth
    43 Florence Road
    Wimbledon
    SW19 8TH London
    পরিচালক
    43 Florence Road
    Wimbledon
    SW19 8TH London
    British36356290002
    SMART, Richard Ernest
    Oak House,Webbs Lane
    Beenham
    RG7 5LL Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    Oak House,Webbs Lane
    Beenham
    RG7 5LL Reading
    Berkshire
    British7970090001
    SMYTH, Peter Francis
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    পরিচালক
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Irish63863190002

    OLD GIROVEND LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ মে, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies (including interest accrued thereto) standing to the credit of the account to be opened in a UK clearing bank to be operated solely by the chargee or its solicitors in which the sum of fifteen thousand two hundred and thirty nine pounds has been deposited.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Helical (Westfields) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৩ মে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ ফেব, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ মার্চ, ১৯৯৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All f/h and l/h land in england and wales including (but not limited to) the property at unit 6 (formerly unit B4) progress business centre,whittle parkway,bath road,slough t/no.bk 266697. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ মার্চ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ সেপ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ সেপ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ সেপ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Single debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ মার্চ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মার্চ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ মার্চ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ সেপ, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0