BEACONTREE ESTATES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামBEACONTREE ESTATES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02291562
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    BEACONTREE ESTATES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিজস্ব রিয়েল এস্টেট কেনাবেচা (68100) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম

    BEACONTREE ESTATES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    St Martin's House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    BEACONTREE ESTATES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    CNC (EPSOM) LIMITED২১ অক্টো, ১৯৮৮২১ অক্টো, ১৯৮৮
    FILEPAPER LIMITED৩১ আগ, ১৯৮৮৩১ আগ, ১৯৮৮

    BEACONTREE ESTATES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১০

    BEACONTREE ESTATES LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    BEACONTREE ESTATES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ০৬ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    20 পৃষ্ঠা4.68

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    18 পৃষ্ঠা4.72

    ৩১ মে, ২০১৩ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ০৬ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    14 পৃষ্ঠা4.68

    ০৬ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    13 পৃষ্ঠা4.68

    রিসিভার বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ

    4 পৃষ্ঠাRM02

    রিসিভার বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ

    2 পৃষ্ঠাRM02

    রিসিভার বা ম্যানেজারের নিযুক্তি

    RM01

    রিসিভার বা ম্যানেজারের নিযুক্তি

    5 পৃষ্ঠাRM01

    রিসিভার বা ম্যানেজারের নিযুক্তি

    4 পৃষ্ঠাRM01

    ২১ আগ, ২০১২ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    legacy

    2 পৃষ্ঠাLQ02

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 4.19

    5 পৃষ্ঠা4.20

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য অসামান্য রেজোলিউশন

    LRESEX

    বার্ষিক রিটার্ন ২৩ জুল, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২০ সেপ, ২০১২

    ২০ সেপ, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,000,000
    SH01

    legacy

    4 পৃষ্ঠাLQ01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৩ জুল, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    17 পৃষ্ঠাAR01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ০২ এপ্রি, ২০১২The form replaces the AR01 registered on 12/08/2011 as it was not properly delivered

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৩ জুল, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ০২ এপ্রি, ২০১২A replacement AR01 was registered on 02/04/2012

    legacy

    9 পৃষ্ঠাMG01

    legacy

    12 পৃষ্ঠাMG06

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    BEACONTREE ESTATES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    AVIS, Marie Annick
    Farley Green
    Albury
    GU5 9DN Guildford
    Barn Cottage
    Surrey
    United Kingdom
    সচিব
    Farley Green
    Albury
    GU5 9DN Guildford
    Barn Cottage
    Surrey
    United Kingdom
    British91430630002
    LEVER, Gary Thomas
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    পরিচালক
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    United KingdomBritish83224530001
    LOCKER, Robert John
    Beukenhof
    Tite Hill
    TW20 0NJ Englefield Green
    Surrey
    পরিচালক
    Beukenhof
    Tite Hill
    TW20 0NJ Englefield Green
    Surrey
    EnglandBritish155603490001
    BLACKETT, Kathleen
    Sanderling Cottage
    8 Llanvair Close
    SL5 9HX South Ascot
    Berkshire
    সচিব
    Sanderling Cottage
    8 Llanvair Close
    SL5 9HX South Ascot
    Berkshire
    British1501820001
    WALKER-ROBSON, Colin Laird
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    সচিব
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    British2667400002
    WALKER-ROBSON, Colin Laird
    12 Bonser Road
    Strawberry Hill
    TW1 4RG Twickenham
    Middlesex
    সচিব
    12 Bonser Road
    Strawberry Hill
    TW1 4RG Twickenham
    Middlesex
    British2667400001
    WESTON, Carole Linda
    44 Stratford Road
    WD17 4NZ Watford
    সচিব
    44 Stratford Road
    WD17 4NZ Watford
    British62673550003
    HAVER, Raymond Victor
    21 Denehurst Gardens
    IG8 0PA Woodford Green
    Essex
    পরিচালক
    21 Denehurst Gardens
    IG8 0PA Woodford Green
    Essex
    British15226710001
    JOHNSTON, James Vincent
    18 Testwood Road
    SL4 5RW Windsor
    Berkshire
    পরিচালক
    18 Testwood Road
    SL4 5RW Windsor
    Berkshire
    British35134150001
    LEVER, Gary Thomas
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    পরিচালক
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    United KingdomBritish83224530001
    MAIS, Richard Jeremy Ian
    79 Seal Hollow Road
    TN13 3RY Sevenoaks
    Kent
    পরিচালক
    79 Seal Hollow Road
    TN13 3RY Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish1464610001
    NEDHAM, Andrew James
    8 Furzedown Close
    TW20 9PY Egham
    Surrey
    পরিচালক
    8 Furzedown Close
    TW20 9PY Egham
    Surrey
    British66426700001
    NEWEITT, Stephen Jeremy
    53 Coleridge Way
    BR6 0UQ Orpington
    Kent
    পরিচালক
    53 Coleridge Way
    BR6 0UQ Orpington
    Kent
    British35411650001
    UPTON, Richard
    Le Grouet
    La Rue Du Grouet
    JE3 8HL St Brelade
    Jersey
    Channel Islands
    পরিচালক
    Le Grouet
    La Rue Du Grouet
    JE3 8HL St Brelade
    Jersey
    Channel Islands
    United KingdomBritish46440870005
    WALKER-ROBSON, Colin Laird
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    পরিচালক
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritish2667400002

    BEACONTREE ESTATES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Supplemental mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ সেপ, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ অক্টো, ২০১০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from a chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The ground and first floor rear centre offices brooklyn house the green west drayton middlesex t/no AGL55700; assigns the rents, proceeds of insurance, any premium. See image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ০৭ অক্টো, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Fixed and floating security document
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ সেপ, ২০১০
    অর্জিত হয়েছে ২৮ সেপ, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ অক্টো, ২০১০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Full title guarantee and as security for the payment of all liabilities by way of fixed charge all its present and future see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ০৭ অক্টো, ২০১০অধিগ্রহণের নিবন্ধন (MG06)
    Fixed and floating security document
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ আগ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ সেপ, ২০০৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from a chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings at marshgate trading estate taplow t/no BM99637, 2 parcels of land on the south side of the B1334 and land and buildings lying to the south of north seaton industrial estate ashington t/no ND102629, 12 richmond street weston super mare t/no AV144818, parkside mills bridge street and land and buildings on north side of school street golborne (millingford industrial estate) t/no GM230087; fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Finance Parties
    ব্যবসায়
    • ০১ সেপ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ সেপ, ২০০৯
    • 1০২ জুন, ২০১২একজন প্রাপক বা ম্যানেজার নিয়োগ (LQ01)
    • 1২৬ মার্চ, ২০১৩একজন প্রাপক বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ (LQ02)
    • 3১৯ ফেব, ২০১৪একজন প্রাপক বা ম্যানেজার নিয়োগ (RM01)
    • 4১৯ ফেব, ২০১৪একজন প্রাপক বা ম্যানেজার নিয়োগ (RM01)
    • 3১৯ ফেব, ২০১৪একজন প্রাপক বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ (RM02)
    • 4১৯ ফেব, ২০১৪একজন প্রাপক বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ (RM02)
      • মামলা নম্বর 1
      • মামলা নম্বর 3
      • মামলা নম্বর 4
    Fixed and floating security document
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the chargors to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ মে, ২০০৮বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১১ জুল, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ জুল, ২০০০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein and each of the other obligors under the senior finance documents (or any of them) to the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ২৬ জুল, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ মে, ২০০৮বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    Account charge deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from cnc properties PLC to the chargee under a loan agreement dated 4TH december 1997 and all monies due from the cnc properties PLC and the second chargors being:- the valley centre limited, cnc estates limited, beacontree estates limited and shelfco (no 1381) limited under the security documents and any of them and all monies due from cnc properties PLC and the second chargors under the account charge deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies from time to time credited to and for the time being standing to the credit of the charged account together with all interest accrued and all other assets of the company and the second chargors. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credit Lyonnais
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ জুন, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rents assignment
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the cnc properties PLC to the chargee under the facility agreement dated 4TH december 1997 and the security documents (as defined in the facility agreement) and all monies due from the company to the chargee on any account whatsoever (including all sums covenanted to be paid by the company pursuant to a guarantee dated 4TH december 1997)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All its rights title and interest present and future to and in the assigned property which means all rents and other income and all other monies in respect of the property (including under the leases and the future leases and any of them). See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credit Lyonnais
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ জুন, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rents assignment
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the cnc properties PLC to the chargee under the facility agreement dated 4TH december 1997 and the security documents (as defined in the facility agreement) and all monies due from the company to the chargee on any account whatsoever (including all sums covenanted to be paid by the company pursuant to a guarantee dated 4TH december 1997)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All its rights title and interest present and future to and in the assigned property which means all rents and other income and all other monies in respect of the property (including under the leases and the future leases and any of them). See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credit Lyonnais
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ জুন, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the cnc properties PLC to the chargee under the facility agreement dated 4TH december 1997 and the security documents (as defined in the facility agreement) and all monies due from the company to the chargee on any account whatsoever (including all sums covenanted to be paid by the company pursuant to a guarantee dated 4TH december 1997)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land k/a units 1, 2 & 5 maple grove business park part t/no.NGL498430 and all plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credit Lyonnais
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ মে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the cnc properties PLC to the chargee under the facility agreement dated 4TH december 1997 and the security documents (as defined in the facility agreement) and all monies due from the company to the chargee on any account whatsoever (including all sums covenanted to be paid by the company pursuant to a guarantee dated 4TH december 1997)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land k/a cippenham lodge cippenham lane weekes drive slough berkshire t/no.BK266986 and all plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credit Lyonnais
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ মে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge by guarantor
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ অক্টো, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ নভে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from cnc properties PLC to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Freehold land and buildings on the west side of leach street and cranberry street the north side of stuart street the east side of fishwick street and the south side of bilberry street title number la 122271; freehold land and buildings on the north side of stuart street title number GM540309 together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery benefit of any leases, rents, monies, contracts, agreements, proceeds of sale, insurances. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ জুল, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ মার্চ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage:-f/h land and buildings known as langar trading estate harby road langar rushcliffe nottinghamshire t/n-NT316825. By way of fixed charge:- the plant machinery and fixtures and fittings of the company, the furniture furnishings equipment tools and other chattels of the company, the present and future goodwill of any business and the proceeds of any insurance from time to time affecting the property.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ মার্চ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ জুল, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Third party legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ অক্টো, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from clarke, nickolls & coombs PLC or the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the agreement dated 24TH october 1995
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the property as detailed on the reverse and continuation sheet of the form 395 and. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    ব্যবসায়
    • ১০ নভে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১০ মার্চ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মার্চ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from clarke, nickolls & coombs PLC to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a units 6 & 7 maple grove business centre, green lane, hounslow, mioddlesex t/no. AGL22263 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ মার্চ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ মে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ সেপ, ১৯৯৪
    অর্জিত হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ আগ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The aggregate of: (a) the present or future,actual or contingent obligations of cnc properties PLC under a loan agreement dated 20 january 1994 as varied by a supplemental loan agreement dated 5 september 1994 and a second supplemental loan agreement dated 23 december 1996 and of the company under the loan agreement as amended;and (b) all indemnification and expense reimbursement obligations of cnc properties PLC and beacontree estates limited under the said loan agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First legal mortgage the f/h property (including all fittings,fixtures and fixed or heavy plant and machinery thereon) now owned by beacontree estates limited,forming part of land on the west side of haig road,knutsford,cheshire.t/no.CH302335.fixed charge all the company's right,title and interest in and to any proceeds of any insurance of all the property which is at the date of the charge or may become subject to the charge. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Canadian Imperial Bank of Commerce
    ব্যবসায়
    • ০১ আগ, ১৯৯৭অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ১৩ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland
    তৈরি করা হয়েছে ০১ জুল, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জুল, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and whole that plot or area of ground lying on the north west side of eldon street, greenock together with the buildings thereon t/no. REN31815. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ জুল, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ জুন, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জানু, ১৯৯৪
    অর্জিত হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ আগ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The aggregate of: (a) the present or future,actual or contingent obligations of cnc properties PLC under a loan agreement dated 20 january 1994 as varied by supplemental loan agreements dated 5 september 1994 and 23 december 1996 and of the company under the loan agreement as amended;and (b) all indemnification and expense reimbursement obligations of cnc properties PLC and beacontree estates limited under the said loan agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company with full title guarantee thereby: charges by way of first legal mortgage the f/h property (including all fittings,fixtures and fixed or heavy plant and machinery thereon) t/nos.MX313519,MX303342,MX421647,MX329817,MX314283,NGL91082 and NGL498430 together with such estate and interest as the company has in the two pieces of land edged red on the plans attached to a transfer dated 22 july 1988.fixed charge all the company's right,title and interest in and to any proceeds of any insurance of all the property which is at the date of the charge or may become subject to the charge. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Canadian Imperial Bank of Commerce
    ব্যবসায়
    • ০১ আগ, ১৯৯৭অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ১৩ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জানু, ১৯৯৪
    অর্জিত হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ আগ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The aggregate of: (a) the present or future,actual or contingent obligations of cnc properties PLC under a loan agreement dated 20 january 1994 as varied by a supplemental loan agreements dated 5 september 1994 and 23 december 1996 and of the company under the loan agreement as amended;and (b) all indemnification and expense reimbursement obligations of cnc properties PLC and beacontree estates limited under the said loan agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company with full title guarantee thereby: a) first legal mortgage the f/h property (including all fittings,fixtures and fixed or heavy plant and machinery thereon) now owned by the company k/a cippenham lodge,cippenham lane,weekes drive,slough,berkshire.t/no.BK266086.fixed charge all the company's right,title and interest in and to any proceeds of any insurance of all the property subject to the charge. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Canadian Imperial Bank of Commerce
    ব্যবসায়
    • ০১ আগ, ১৯৯৭অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ১৩ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ অক্টো, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ অক্টো, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a units 17 & 18 longmead industrial estate, blenheim road epsom, surrey (see form 395 for full details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Clarke Nickolls & Coombs PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ অক্টো, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ ডিসে, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ অক্টো, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ অক্টো, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a units 17&18 blenheim road longmead industrial estate, epsom surrey - title no:- sy 589633 together with fixed plant & machinery & other fixtures assigns the goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hill Samuel & Co Limited
    ব্যবসায়
    • ০৭ অক্টো, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ ডিসে, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ অক্টো, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ অক্টো, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of floating security the whole of the company to. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hill Samuel & Co Limited
    ব্যবসায়
    • ০৭ অক্টো, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ ডিসে, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    BEACONTREE ESTATES LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1রিসিভার/ম্যানেজার নিযুক্ত
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Louisa Jane Brooks
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    রিসিভার ম্যানেজার
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Jonathan Howard Gershinson
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    রিসিভার ম্যানেজার
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    2
    তারিখপ্রকার
    ০৭ মার্চ, ২০১৩ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ২৯ সেপ, ২০১৬ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Julie Ann Swan
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    অভ্যাসকারী
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Mark Richard Phillips
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    অভ্যাসকারী
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    3রিসিভার/ম্যানেজার নিযুক্ত
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Louisa Jane Brooks
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    রিসিভার ম্যানেজার
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Jonathan Howard Gershinson
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    রিসিভার ম্যানেজার
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    4রিসিভার/ম্যানেজার নিযুক্ত
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Louisa Jane Brooks
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    রিসিভার ম্যানেজার
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Jonathan Howard Gershinson
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    রিসিভার ম্যানেজার
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0