PKL GROUP (UK) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPKL GROUP (UK) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিসক্রিয়
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02308713
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PKL GROUP (UK) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং স্পর্শযোগ্য পণ্য ভাড়া এবং লিজিং ন.এ.সি. (77390) / প্রশাসনিক এবং সহায়ক পরিষেবা কার্যক্রম

    PKL GROUP (UK) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PKL GROUP (UK) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    PORTABLE KITCHENS LIMITED০৯ মে, ১৯৯১০৯ মে, ১৯৯১
    OPEN ALL DAY LIMITED০১ মে, ১৯৯১০১ মে, ১৯৯১
    PORTABLE KITCHENS LIMITED২৫ অক্টো, ১৯৮৮২৫ অক্টো, ১৯৮৮

    PKL GROUP (UK) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণনা
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ ডিসে, ২০২৪
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩০ সেপ, ২০২৫
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০২৩

    PKL GROUP (UK) LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০১ এপ্রি, ২০২৫
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে১৫ এপ্রি, ২০২৫
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০১ এপ্রি, ২০২৪
    মেয়াদোত্তীর্ণনা

    PKL GROUP (UK) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২৩ পর্যন্ত তৈরি

    31 পৃষ্ঠাAA

    ০১ এপ্রি, ২০২৪ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ০১ এপ্রি, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Colin Nigel Dowds-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Neil William Gamble এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    চার্জ 023087130022 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 023087130023 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ নিবন্ধন 023087130024, ১৪ সেপ, ২০২৩ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    61 পৃষ্ঠাMR01

    ০১ এপ্রি, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি

    31 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ জুল, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Christopher Charles Richards এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি

    32 পৃষ্ঠাAA

    ০১ এপ্রি, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ২৮ মার্চ, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Rachel Mccausland-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৮ মার্চ, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Neil William Gamble-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৮ মার্চ, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Paul Lavery এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    চার্জ নিবন্ধন 023087130023, ১১ মার্চ, ২০২২ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    184 পৃষ্ঠাMR01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    32 পৃষ্ঠাAA

    চার্জ নিবন্ধন 023087130022, ০৯ জুল, ২০২১ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    30 পৃষ্ঠাMR01

    চার্জ নিবন্ধন 023087130021, ২১ জুন, ২০২১ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    18 পৃষ্ঠাMR01

    ০১ এপ্রি, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ০১ জানু, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Karen Rumsey-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩১ ডিসে, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Lee Anthony Vines এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩১ আগ, ২০২০ থেকে ৩১ ডিসে, ২০২০ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    চার্জ নিবন্ধন 023087130020, ০৯ এপ্রি, ২০২০ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    60 পৃষ্ঠাMR01

    ০১ এপ্রি, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    PKL GROUP (UK) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PERRY, William Edward
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    সচিব
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    181911740001
    DOWDS, Colin Nigel
    9 Lissue Walk
    BT28 2LU Lisburn
    Unit 1
    Northern Ireland
    পরিচালক
    9 Lissue Walk
    BT28 2LU Lisburn
    Unit 1
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritishDirector253795300001
    IRVING, Christopher James Elgin
    Stella Way
    Bishops Cleeve
    GL52 7DQ Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Stella Way
    Bishops Cleeve
    GL52 7DQ Cheltenham
    Gloucestershire
    ScotlandScottishDirector147035890001
    LOWRY, Rodney
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    পরিচালক
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    Northern IrelandBritishDirector219925750001
    MCCAUSLAND, Rachel
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    পরিচালক
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    Northern IrelandBritishDirector192783600002
    PERRY, William Edward
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    পরিচালক
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    EnglandBritishFinance Director247031000001
    RUMSEY, Karen
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    পরিচালক
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    EnglandBritishChief Operating Officer278213030001
    SCHAD, Peter Ferdinand
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    পরিচালক
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    United KingdomBritishDirector72449070002
    COLCHESTER, Timothy Mark
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    সচিব
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    BritishAccountant104741260001
    HUNT, Michael Peter
    Ashton House Neata Farm
    Market Lane Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Gloucestershire
    সচিব
    Ashton House Neata Farm
    Market Lane Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Secretary36149350002
    LOWE, Timothy Alun
    107 Heol Y Coed
    Rhiwbina
    CF14 6HS Cardiff
    সচিব
    107 Heol Y Coed
    Rhiwbina
    CF14 6HS Cardiff
    BritishCo Director36133150003
    MIDDLETON, Christopher Alan
    14 Saint Edwards Walk
    GL53 7RS Cheltenham
    Gloucestershire
    সচিব
    14 Saint Edwards Walk
    GL53 7RS Cheltenham
    Gloucestershire
    British74792740001
    PUGH, David Richard
    Snowfield House
    4 Sheraton Road The Oakalls
    B60 2RT Bromsgrove
    Worcestershire
    সচিব
    Snowfield House
    4 Sheraton Road The Oakalls
    B60 2RT Bromsgrove
    Worcestershire
    British108788360001
    SCHAD, Peter Ferdinand
    Westfield
    25 All Saints Villas Road
    GL52 2HB Cheltenham
    Gloucestershire
    সচিব
    Westfield
    25 All Saints Villas Road
    GL52 2HB Cheltenham
    Gloucestershire
    British72449070002
    VINCENT, Nicholas John
    Fairview 68 Sandy Lane
    Charlton Kings
    GL53 9DH Cheltenham
    Gloucestershire
    সচিব
    Fairview 68 Sandy Lane
    Charlton Kings
    GL53 9DH Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishAccountant4565330001
    VINCENT, Nicholas John
    Fairview 68 Sandy Lane
    Charlton Kings
    GL53 9DH Cheltenham
    Gloucestershire
    সচিব
    Fairview 68 Sandy Lane
    Charlton Kings
    GL53 9DH Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishAccountant4565330001
    BAILEY, Michael William John
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    পরিচালক
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    EnglandBritishNon-Executive148550460002
    BIRD, Kenneth John
    The Beeches
    Hewlett Road
    GL51 6QY Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    The Beeches
    Hewlett Road
    GL51 6QY Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector3875670001
    COLCHESTER, Tim Mark
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    পরিচালক
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    EnglandBritishAccountant184641070001
    CROW, Lynda Dawn
    19 Keynsham Road
    GL53 7PU Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    19 Keynsham Road
    GL53 7PU Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector18855840002
    CROW, Neil Ernest
    50 Naunton Crescent
    GL53 7BE Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    50 Naunton Crescent
    GL53 7BE Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishProject Manager34957860001
    DAY, Barry David
    The Old Rectory Hatton Green
    Hatton
    CV35 7LA Warwick
    Warwickshire
    পরিচালক
    The Old Rectory Hatton Green
    Hatton
    CV35 7LA Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritishAccountant57937960001
    GAMBLE, Neil William
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    পরিচালক
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    Northern IrelandBritishAccountant245581340001
    GLOVER, David Alan
    Birlingham
    WR10 3AB Pershore
    Glebe House
    Worcestershire
    পরিচালক
    Birlingham
    WR10 3AB Pershore
    Glebe House
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector133622500001
    HUNT, Michael Peter
    Ashton House Neata Farm
    Market Lane Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Ashton House Neata Farm
    Market Lane Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritishDirector36149350002
    JOHN, Noel Emlyn
    9 Redthorne Way
    Hatherley
    GL51 3NW Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    9 Redthorne Way
    Hatherley
    GL51 3NW Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector81392560001
    JOY, Christine Elizabeth
    Coxhorne London Road
    Charlton Kings
    GL52 6UY Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Coxhorne London Road
    Charlton Kings
    GL52 6UY Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector66531670001
    JOY, Peter Robin
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    পরিচালক
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    EnglandBritishDirector92906050002
    LAVERY, Paul
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    পরিচালক
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    Northern IrelandIrishFinance Director145537540001
    LOWE, Timothy Alun
    107 Heol Y Coed
    Rhiwbina
    CF14 6HS Cardiff
    পরিচালক
    107 Heol Y Coed
    Rhiwbina
    CF14 6HS Cardiff
    WalesBritishAccountant36133150003
    MELLOR, Michael Ernest George
    30 Oakland Avenue
    GL52 3EP Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    30 Oakland Avenue
    GL52 3EP Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector23607050002
    MIDDLETON, Christopher Alan
    14 Saint Edwards Walk
    GL53 7RS Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    14 Saint Edwards Walk
    GL53 7RS Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishDirector74792740001
    PUGH, David Richard
    Snowfield House
    4 Sheraton Road The Oakalls
    B60 2RT Bromsgrove
    Worcestershire
    পরিচালক
    Snowfield House
    4 Sheraton Road The Oakalls
    B60 2RT Bromsgrove
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector108788360001
    RICHARDS, Christopher Charles
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    পরিচালক
    Stella Way Bishops Cleeve
    Cheltenham
    GL52 7DQ Gloucestershire
    EnglandBritishOperations Director232369840001
    ROGERS, Paul Stuart
    Manor Farmhouse
    Stanley Pontlarge
    GL54 5HD Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Manor Farmhouse
    Stanley Pontlarge
    GL54 5HD Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritishSales Executive63211870002

    PKL GROUP (UK) LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Pkl Topco Limited
    Stella Way
    Bishops Cleeve
    GL52 7DQ Cheltenham
    Pkl
    England
    ৩১ জুল, ২০১৭
    Stella Way
    Bishops Cleeve
    GL52 7DQ Cheltenham
    Pkl
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশUnited Kingdom
    আইনি কর্তৃপক্ষThe Law Of England & Wales
    নিবন্ধিত স্থানUk Companies House
    নিবন্ধন নম্বর07110339
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    Pkl Topco Ltd
    Stella Way
    Bishops Cleeve
    GL52 7DQ Cheltenham
    Pkl Group (Uk) Ltd
    England
    ২০ জুল, ২০১৭
    Stella Way
    Bishops Cleeve
    GL52 7DQ Cheltenham
    Pkl Group (Uk) Ltd
    England
    হ্যাঁ
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশUk
    আইনি কর্তৃপক্ষEngland & Wales
    নিবন্ধিত স্থানUk Company Number 06627298
    নিবন্ধন নম্বর06627298
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    Pkl Parent Ltd
    Malvern View Business Park, Stella Way
    Bishops Cleeve
    GL52 7DQ Cheltenham
    Pkl
    England
    ১৮ মে, ২০১৬
    Malvern View Business Park, Stella Way
    Bishops Cleeve
    GL52 7DQ Cheltenham
    Pkl
    England
    হ্যাঁ
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশUk
    আইনি কর্তৃপক্ষEngland & Wales
    নিবন্ধিত স্থানCompany Register
    নিবন্ধন নম্বর06627298
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    PKL GROUP (UK) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ সেপ, ২০২৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ সেপ, ২০২৩
    বকেয়া
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1. old station yard, beckford, tewkesbury, GL20 7AN with title number WR74356.. Please see instrument for further details.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ares Management Limited (The “Security Agent”)
    ব্যবসায়
    • ১৫ সেপ, ২০২৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ মার্চ, ২০২২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ মার্চ, ২০২২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Upstream Working Capital LTD
    ব্যবসায়
    • ১৮ মার্চ, ২০২২একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১৯ সেপ, ২০২৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ জুল, ২০২১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ জুল, ২০২১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Upstream Working Capital LTD
    ব্যবসায়
    • ২২ জুল, ২০২১একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১৯ সেপ, ২০২৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২১ জুন, ২০২১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জুল, ২০২১
    বকেয়া
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    ব্যবসায়
    • ০৮ জুল, ২০২১একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ২০২০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ২০২০
    বকেয়া
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Material real property:. Mortgagor: pkl group (UK) limited. Address: old station yard, beckford, tewkesbury, GL20 7AN. Title no: WR74356.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ares Management Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ এপ্রি, ২০২০একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ আগ, ২০১৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ আগ, ২০১৯
    বকেয়া
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Please see instrument for further details.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ares Management Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ আগ, ২০১৯একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ মার্চ, ২০১৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ এপ্রি, ২০১৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The property known as old station yard beckford tewkesbury GL20 7AN as registered at hm land registry with title number WR74356.
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Handelsbanken PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ এপ্রি, ২০১৯একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১৮ ডিসে, ২০১৯একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জানু, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জানু, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ জানু, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৮ ডিসে, ২০১৯একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১১ নভে, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ নভে, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ নভে, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ডিসে, ২০১৯একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 1 december 2004 and
    তৈরি করা হয়েছে ১২ ফেব, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ফেব, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ ফেব, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ডিসে, ২০১৯একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    An omnibus guarantee and set off agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০১ ডিসে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ডিসে, ২০১৯একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ ডিসে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ডিসে, ২০১৯একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ ফেব, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ মার্চ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ মার্চ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment and charge of sub-leasing agreements
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জানু, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জানু, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the assignment and charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the rights title and interest of the company in sub leases now made or hereafter to be made by the company in respect of equipment comprised in hp/leasing/contract hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ০৬ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ এপ্রি, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Charge over sub-hire
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ অক্টো, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ অক্টো, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All its right title and benefit under or in the existing sub-leases. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Tsb Asset Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ১৯ অক্টো, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Equipment mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২০ সেপ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ অক্টো, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The equipment and all right title benefit and interest of the mortgagor in and to all insurances and warranties. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Tsb Asset Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ০৪ অক্টো, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জুল, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ জুল, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২১ জুল, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ ফেব, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge containing fixed and floating charges
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জুল, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the l/h property k/a unit 3 the courtyard gillingham business park gillingham kent t/no K703408. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ ফেব, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জুল, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The benefit of an agreement made 30/4/91 between grosvenor deveopments limited (1) and the company (2) relating to unit 3 the courtyard phase 35 gillingham business park kent.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A credit agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জুল, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জুল, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £37,266.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the right,title and interest in and to all sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Close Brothers Limited
    ব্যবসায়
    • ২৯ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A credit agreement entitled "prompt credit application"
    তৈরি করা হয়েছে ১২ নভে, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ নভে, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £22,429.60 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All its right,title and interest in and to all sums payable under the insurance.please see doc M167C for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Close Brothers Limited
    ব্যবসায়
    • ১৯ নভে, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold property k/as unit 3 the courtyard phase 35 gillingham business p ark gillingham kent. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ মে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০২ জানু, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জানু, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Unit 3 manchester park, tewkesbury road cheltenham and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ জানু, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ সেপ, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ এপ্রি, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ এপ্রি, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ এপ্রি, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0