LARSTRIKE LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামLARSTRIKE LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02337990
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    LARSTRIKE LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    LARSTRIKE LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    LARSTRIKE LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১০

    LARSTRIKE LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ০৯ অক্টো, ২০১২ তারিখে সচিব হিসাবে Francis Declan Finbar Tempany Mccormack এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    ২৪ জুল, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Timothy James Bolot এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ জানু, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৮ জানু, ২০১২

    ১৮ জানু, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    ১৫ নভে, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে William James Buchan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ নভে, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে David Andrew Smith এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৬ অক্টো, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Stephen Jonathan Taylor-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৬ অক্টো, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Timothy James Bolot-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Francis Declan Finbar Tempany Mccormack-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে William Mcleish এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ জানু, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Richard Midmer এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ২৭ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ জানু, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    ০৭ জানু, ২০১০ তারিখে Mr David Andrew Smith-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পরিচালক হিসাবে Mr David Andrew Smith-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে David Smith এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Mr David Andrew Smith-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Kamma Foulkes এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৭ অক্টো, ২০০৯ তারিখে William James Buchan-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৭ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Richard Neil Midmer-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৭ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Kamma Foulkes-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৭ অক্টো, ২০০৯ তারিখে William David Mcleish-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    LARSTRIKE LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    পরিচালক
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    সচিব
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    British53915080001
    FORD, Colin Andrew
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    সচিব
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    British70144650001
    HURRELL, Steven Alfred
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    সচিব
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    British82311390001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    সচিব
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British89002440002
    MACFARLANE, Rona Jane
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    সচিব
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    British62509960001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    সচিব
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158305150001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    সচিব
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    MITCHELL, Andrew Ross
    Highwood
    PA13 4TA Kilmacolm
    Refrewshire
    সচিব
    Highwood
    PA13 4TA Kilmacolm
    Refrewshire
    British25359180002
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    সচিব
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SPEIRS, Lesley Sarah
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    সচিব
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    British69112020001
    ABLETT, Julie
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    পরিচালক
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    British57906600001
    BARLOW, George Edward
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    পরিচালক
    41 Nidd Approach
    LS22 7UJ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish66559170001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    পরিচালক
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BRADEEN, Chester Howard
    Pipers Cottage Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6EU Woking
    Surrey
    পরিচালক
    Pipers Cottage Grove Heath Road
    Ripley
    GU23 6EU Woking
    Surrey
    American51593550001
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    পরিচালক
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    CHISMAN, Ronald Neil
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    পরিচালক
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    United KingdomBritish780950001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    পরিচালক
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    DENNY, Nigel John
    Brook House The Manor
    Potton
    SG19 2RN Sandy
    Bedfordshire
    পরিচালক
    Brook House The Manor
    Potton
    SG19 2RN Sandy
    Bedfordshire
    British53339290001
    FARRALL, Elaine Ann
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    British14241020001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    পরিচালক
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish53915080001
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    পরিচালক
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    American100530310001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    পরিচালক
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    পরিচালক
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    British66801660002
    HAMILTON, Thomas Banks
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    পরিচালক
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    British79846610001
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    পরিচালক
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporean101200680001
    LAWRENCE, Stephen John
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    পরিচালক
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    EnglandBritish5579020001
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    পরিচালক
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MACKAY, William Donald
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    পরিচালক
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    British796730001
    MCINTEER, Warren Hill
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    পরিচালক
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish100131200001
    MICHELS, David Michael Charles
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    পরিচালক
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    British4855250001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    পরিচালক
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    পরিচালক
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    PHIPPEN, Kent William
    12 Elm Tree Road
    St Johns Wood
    NW8 9JX London
    পরিচালক
    12 Elm Tree Road
    St Johns Wood
    NW8 9JX London
    United KingdomAmerican84576560001
    RHODES, Colin Eric
    12 Alexandra Park
    Lenzie
    G66 5BH Glasgow
    পরিচালক
    12 Alexandra Park
    Lenzie
    G66 5BH Glasgow
    British3918330003

    LARSTRIKE LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Commercial legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ আগ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The dets and rental sums as referred to in the governor and company of the bank of scotland's commercial charge conditions (1995 edition) as filed at h/m/ land registry under reference MD308F/01 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings on the west side of lode lane solihull k/a salisbury court nursing home 21 lodge lane B91 2AB t/n WM63362. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২০ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Commercial legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ আগ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The debts and rental sums referred to in the governor and company of the bank of scotland's commercial charge conditions (1995 edition) as filed at H.M.land registry under reference no MD308F/01 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Broomcroft house eccleshall road sheffield S11 9DY t/n LA108098. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২০ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the credit documents and/or the security documents (all as defined in the legal charge)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property charged being heathland court (formerly k/a heathlands) parkside wimbledon london borough of merton t/no;-SY232477. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Beneficiaries
    ব্যবসায়
    • ০৪ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the credit documents and/or the security documents (all as defined in the legal charge)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property charged being brunswick court 62 stratford road (formerly mardalke hempstead road) watford t/no;-HD282592. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland(As Security Trustee for the Beneficiaries
    ব্যবসায়
    • ০৪ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ ডিসে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জানু, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the credit documents and/or the security documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Wingham house oaken lane claygate surrey/elmbridge part t/n: SY643948 and all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery the insurances the ancillary rights relating to the property and income the goodwill of the business and the benefit of all licences floating charge all furnishings and fittings and all machinery equipment chattels consumables and stocks. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ০৮ জানু, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ সেপ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ সেপ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies obligations and liabilities now due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of the credit documents and/or the security documents (as defined) and this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The property k/a hill house high street elstree herts t/no hd 306249. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Beneficiaries (Asdefined)
    ব্যবসায়
    • ১৮ সেপ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security
    তৈরি করা হয়েছে ২২ জানু, ১৯৯৫
    অর্জিত হয়েছে ২১ নভে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ নভে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums of principal interest and expenses now due or to become due fromthe company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    That plot of ground k/a annfield house stirling t/no stg 9911.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Cala Management Limited
    ব্যবসায়
    • ৩০ নভে, ১৯৯৬অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ৩১ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ ফেব, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ ফেব, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to the facility documents and/or the security documents as defined in this deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See doc ref M114 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland(The "Security Agent") as Agent and Trustee Forand on Behalf of the Beneficiaries
    ব্যবসায়
    • ১৯ ফেব, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ ডিসে, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ আগ, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ সেপ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to teh chargee for itself and as agent for the banks (as defined in the charge). On any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (See Col 5)
    ব্যবসায়
    • ০৩ সেপ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৩ ফেব, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ আগ, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ সেপ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Stakis Public Limited Company.
    ব্যবসায়
    • ০৩ সেপ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৩ ফেব, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0