LODESTONE IMAGING LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামLODESTONE IMAGING LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02338730
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    LODESTONE IMAGING LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (8514) /

    LODESTONE IMAGING LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Iceni Centre
    Warwick Technology Park
    CV34 6DA Warwick
    Warwickshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    LODESTONE IMAGING LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HEALTHSOUTH (U.K.) PLC২৮ জানু, ১৯৯৮২৮ জানু, ১৯৯৮
    HEALTH IMAGES (U.K.) PLC০১ মার্চ, ১৯৮৯০১ মার্চ, ১৯৮৯
    HANDGRAM LIMITED২৫ জানু, ১৯৮৯২৫ জানু, ১৯৮৯

    LODESTONE IMAGING LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০০৮

    LODESTONE IMAGING LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    সচিব হিসাবে Mairead Mckenna এর পদব্যবস্থা বাতিল

    3 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Andrew Dun এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ১৬ জুল, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,000
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    2 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    2 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ২৯ জুন, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 500
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    2 পৃষ্ঠাCAP-SS

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Cancel share premium account 28/06/2010
    RES13

    পরিচালক হিসাবে Andrew Smith এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Keith Peter Rowling-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Andrew William Smith-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Mairead Maria Mckenna-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH03

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Jean-Luc Janet-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Dr Andrew Fredrick Dun-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    হিসাব ৩০ জুন, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা225

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    LODESTONE IMAGING LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    JANET, Jean-Luc Emmanuel
    Warwick Technology Park
    CV34 6DA Warwick
    Iceni Centre
    Warwickshire
    পরিচালক
    Warwick Technology Park
    CV34 6DA Warwick
    Iceni Centre
    Warwickshire
    EnglandFrenchDirector171688520001
    ROWLING, Keith Peter
    Warwick Technology Park
    CV34 6DA Warwick
    Iceni Centre
    Warwickshire
    পরিচালক
    Warwick Technology Park
    CV34 6DA Warwick
    Iceni Centre
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector109045590002
    BYRNE, Vincent Patrick
    17 Birchlands Avenue
    SW12 8ND London
    সচিব
    17 Birchlands Avenue
    SW12 8ND London
    BritishCompany Director9431810002
    CASTLE, Stephen
    141a Fuller Street
    Narrabeen
    Nsw 2101
    Australia
    সচিব
    141a Fuller Street
    Narrabeen
    Nsw 2101
    Australia
    British101440690001
    HALE, Brandon
    One Healthsouth Parkway
    Birmingham
    Alabama
    35243
    Us
    সচিব
    One Healthsouth Parkway
    Birmingham
    Alabama
    35243
    Us
    Us90156190001
    HORTON, William Wiley
    4007 Clairmont Avenue
    35222 Birmingham
    Alabama
    Usa
    সচিব
    4007 Clairmont Avenue
    35222 Birmingham
    Alabama
    Usa
    British57424670001
    JONES, Craig Howard
    291 Eastern Valley Way
    Middle Cove
    Nsw 2068
    Australia
    সচিব
    291 Eastern Valley Way
    Middle Cove
    Nsw 2068
    Australia
    British95453960001
    MCKENNA, Mairead Maria
    Warwick Technology Park
    CV34 6DA Warwick
    Iceni Centre
    Warwickshire
    সচিব
    Warwick Technology Park
    CV34 6DA Warwick
    Iceni Centre
    Warwickshire
    Irish115376340001
    OTT, Keith Terry
    50 Gayton Road
    Hampstead
    NW3 1TU London
    সচিব
    50 Gayton Road
    Hampstead
    NW3 1TU London
    British35285110001
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    কর্পোরেট সচিব
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    73539350001
    BAKER, Peter William
    3 Cootamundra Drive
    2100 Allambie Heights
    2100 New South Wales
    Australia
    পরিচালক
    3 Cootamundra Drive
    2100 Allambie Heights
    2100 New South Wales
    Australia
    AustralianChief Development Officer90829910001
    BARNIER, Gary Paul
    Unit 1, 337 Victoria Place
    Drummoyne
    Nsw 2047
    Australia
    পরিচালক
    Unit 1, 337 Victoria Place
    Drummoyne
    Nsw 2047
    Australia
    AustralianChief Executive Officer I Med101440810002
    BASSETT, Gerald Dennet
    474 Spring End Lane Ne
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30067
    Usa
    পরিচালক
    474 Spring End Lane Ne
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30067
    Usa
    UsaExecutive14399020001
    BENNETT, James Patrick
    3732 Shady Cove Drive
    35243 Birmingham
    Jefferson/Alabama
    Usa
    পরিচালক
    3732 Shady Cove Drive
    35243 Birmingham
    Jefferson/Alabama
    Usa
    Us CitizenHealthcare Executive56437260001
    BROWN, Paul Daryl
    2604 Caldwell Mill Lane
    Birmingham
    Alabama 35243
    Usa
    পরিচালক
    2604 Caldwell Mill Lane
    Birmingham
    Alabama 35243
    Usa
    Us CitizenHealthcare Executive71461430001
    BYRNE, James Vincent, Professor
    Hawkyard House
    New Street
    OX7 5LJ Chipping Norton
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Hawkyard House
    New Street
    OX7 5LJ Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritishMedical Director204226020002
    BYRNE, Vincent Patrick
    39 Blenkarne Road
    SW11 6HZ London
    পরিচালক
    39 Blenkarne Road
    SW11 6HZ London
    United KingdomBritishManaging Director9431810003
    CARL III, Robert Delroy
    857 Hillwood Drive
    30067 Marietta
    Georgia
    Usa
    পরিচালক
    857 Hillwood Drive
    30067 Marietta
    Georgia
    Usa
    UsaCompany Director14399030001
    COOPER, Anthony Rupert Valentine
    Edington Priory
    Edington
    BA13 4QR Westbury
    Wiltshire
    পরিচালক
    Edington Priory
    Edington
    BA13 4QR Westbury
    Wiltshire
    BritishCompany Director106180001
    DUN, Andrew Frederick
    Warwick Technology Park
    CV34 6DA Warwick
    Iceni Centre
    Warwickshire
    পরিচালক
    Warwick Technology Park
    CV34 6DA Warwick
    Iceni Centre
    Warwickshire
    United KingdomBritishChief Operating Officer85855780002
    HOLLIS, Colin Edwin
    14 Bitterne Way
    Bitterne
    SO19 4EA Southampton
    Hampshire
    পরিচালক
    14 Bitterne Way
    Bitterne
    SO19 4EA Southampton
    Hampshire
    BritishCompany Director41703940001
    HOUSDEN, Peter John
    Unit 8
    6 Cliff Street
    Milsons Point
    New South Wales 2061
    Australia
    পরিচালক
    Unit 8
    6 Cliff Street
    Milsons Point
    New South Wales 2061
    Australia
    AustralianChief Financial Officer76382260001
    JAYNE, David
    1621 Wingfield Drive
    Birmingham
    35242 Alabama
    Usa
    পরিচালক
    1621 Wingfield Drive
    Birmingham
    35242 Alabama
    Usa
    AmericanBusiness Executive74352900001
    KMET, Walter
    33 Kareela Road
    2067 Chatswood
    New South Wales 2067
    Australia
    পরিচালক
    33 Kareela Road
    2067 Chatswood
    New South Wales 2067
    Australia
    AustralianChief Operating Officer76559360001
    MACINTOSH, Peter Kirton
    Unit 2
    32a Awaba Street
    Mosman
    New South Wales 2088
    Australia
    পরিচালক
    Unit 2
    32a Awaba Street
    Mosman
    New South Wales 2088
    Australia
    AustralianChief Executive Officer76382400001
    MASTERSON, Mark
    West Street
    Balgowlah
    35
    Nsw 2093
    Australia
    পরিচালক
    West Street
    Balgowlah
    35
    Nsw 2093
    Australia
    AustralianCompany Director130088690001
    MIRABELLE, Paul Alexander
    7 Kingslangley Road
    Greenwich
    Nsw 2065
    Australia
    পরিচালক
    7 Kingslangley Road
    Greenwich
    Nsw 2065
    Australia
    AustralianChief Executive Officer95454060001
    MURRAY, Robin Eubanks
    580 Telford Place
    30342 Atlanta
    Georgia
    Usa
    পরিচালক
    580 Telford Place
    30342 Atlanta
    Georgia
    Usa
    AmericanLawyer52158900001
    OWENS, William T
    One Healthsouth Parkway
    Birmingham
    Alabama
    35243
    Usa
    পরিচালক
    One Healthsouth Parkway
    Birmingham
    Alabama
    35243
    Usa
    AmericanChief Financialofficer73099590001
    PRESCOTT, Anthony Thomas
    Cornerways 8 Velmead Road
    GU13 9JY Fleet
    Hampshire
    পরিচালক
    Cornerways 8 Velmead Road
    GU13 9JY Fleet
    Hampshire
    BritishManaging Director14286040001
    SCRUSHY, Richard Marin
    2406 Longleaf Street
    352243 Birmingham
    Alabama
    Usa
    পরিচালক
    2406 Longleaf Street
    352243 Birmingham
    Alabama
    Usa
    Us CitizenHealthcare Executive57424600001
    SMITH, Andrew William
    Warwick Technology Park
    CV34 6DA Warwick
    Iceni Centre
    Warwickshire
    পরিচালক
    Warwick Technology Park
    CV34 6DA Warwick
    Iceni Centre
    Warwickshire
    EnglandEnglishManaging Director52718610001
    TANNER, Anthony John
    2112 Swan Lake Cove
    35244 Birmingham
    Alabama
    Usa
    পরিচালক
    2112 Swan Lake Cove
    35244 Birmingham
    Alabama
    Usa
    Us CitizenHealthcare Executive57424520001
    TAYLOR, Larry
    4045 Water Willow Lane
    Birmingham
    Alabama
    35244
    Usa
    পরিচালক
    4045 Water Willow Lane
    Birmingham
    Alabama
    35244
    Usa
    Us CitizenBusiness Executive84037350001
    THOMPSON, Geoffrey Arthur
    23 Bent Street
    Greenwich
    Nsw 2065
    Australia
    পরিচালক
    23 Bent Street
    Greenwich
    Nsw 2065
    Australia
    AustralianAccountant95453880001

    LODESTONE IMAGING LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জানু, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জানু, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any chargor to any finance party and any subordinated finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bwa Custodians Limited as Security Trustee for the Secured Parties (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৭ জানু, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ সেপ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ অক্টো, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the security trustee and each of the mortgagees (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anz Fiduciary Services Pty Limited (Acting as Trustee of the Dca Group Limited Security Trust)
    ব্যবসায়
    • ১৩ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ অক্টো, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ নভে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the debenture holders and/or the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge on all the company's present and future interests and rights in real property, buildings and fixtures, capital, personal property, goodwill patents trademarks copyrights designs trade secrets confidential information and other intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Australia Bank Trustees Limited (The Debenture Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১১ নভে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ সেপ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Letter of charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ আগ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ সেপ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All moneys standing to the credit of any account(s) of the company with the bank re: health images (UK) PLC.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ সেপ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ নভে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0