TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02345011
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    3 Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ASHURST PARK INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED২৩ জানু, ১৯৯১২৩ জানু, ১৯৯১
    SCATSOUTH A51 LIMITED০৮ ফেব, ১৯৮৯০৮ ফেব, ১৯৮৯

    TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৪

    TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    একজন পরিচালকের পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ০২ নভে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Simon Gordon এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০২ নভে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Spire Healthcare Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP02

    ০২ নভে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Robert Roger এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ০১ জুন, ২০১৫ তারিখে Mr Simon Gordon-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ জুন, ২০১৫ তারিখে Mr Robert Roger-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ জুল, ২০১৫ তারিখে Mr Robert Roger-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ জুল, ২০১৫ তারিখে Mr Simon Gordon-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা Thames House Portsmouth Road Esher Surrey KT10 9AD United Kingdom থেকে 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ ফেব, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৯ ফেব, ২০১৫

    ০৯ ফেব, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    চার্জ 9 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ ফেব, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১১ ফেব, ২০১৪

    ১১ ফেব, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ ফেব, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    ২৩ আগ, ২০১২ তারিখে Mr Daniel Francis Toner-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ ফেব, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Jean De Gorter এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    TONER, Daniel Francis
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    সচিব
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    British100270040001
    TONER, Daniel Francis
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    পরিচালক
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United KingdomBritish100270040002
    SPIRE HEALTHCARE LIMITED
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United Kingdom
    কর্পোরেট পরিচালক
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর1522532
    202359590001
    MORRIS, David Richard
    22 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    সচিব
    22 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    British64514410001
    PRESTON, David James
    4 Victoria Mansions
    Navigation Way Ashton On Ribble
    PR2 2YX Preston
    Lancashire
    সচিব
    4 Victoria Mansions
    Navigation Way Ashton On Ribble
    PR2 2YX Preston
    Lancashire
    British46551430003
    PRESTON, David James
    5 Cock Robin Cottages
    Croston
    PR5 7HH Preston
    সচিব
    5 Cock Robin Cottages
    Croston
    PR5 7HH Preston
    British46551430001
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    সচিব
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    British6658190001
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    কর্পোরেট সচিব
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    107319700001
    BARKER, Hilary Jane
    Flat B22 Herbal Hill Gardens
    9 Herbal Hill
    EC1R 5EJ London
    পরিচালক
    Flat B22 Herbal Hill Gardens
    9 Herbal Hill
    EC1R 5EJ London
    British62838010001
    BEAZLEY, Nicholas Tetley
    The Dower House
    Westmill
    SG9 9LY Buntingford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    The Dower House
    Westmill
    SG9 9LY Buntingford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish105797560001
    BURNS, Robert Ian
    6 Netherfield Road
    AL5 2AG Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    6 Netherfield Road
    AL5 2AG Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish36584260002
    CHADWICK, Bernard Keith
    Willow Glen Dowbridge
    Kirkham
    PR4 2YL Preston
    Lancashire
    পরিচালক
    Willow Glen Dowbridge
    Kirkham
    PR4 2YL Preston
    Lancashire
    EnglandBritish3632310001
    DAVIES, Julian Peter
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    পরিচালক
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish29367700001
    DE GORTER, Jean Jacques, Dr
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    পরিচালক
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    United KingdomFrench128865640001
    DUGDALE, Michael Ian
    29 Magnolia Dene
    HP15 7QE Hazlemere
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    29 Magnolia Dene
    HP15 7QE Hazlemere
    Buckinghamshire
    British79570840001
    ELLERBY, Mark
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish40582650004
    FOZARD, Ian
    The Old Brewhouse
    8a Waterside
    HG5 9AZ Knaresborough
    North Yorkshire
    পরিচালক
    The Old Brewhouse
    8a Waterside
    HG5 9AZ Knaresborough
    North Yorkshire
    EnglandBritish21934910001
    GORDON, Simon
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    পরিচালক
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United KingdomBritish162037020001
    GRAY, Duncan Archibald
    51 Exchange Building
    132 Commercial Street
    E1 6NG London
    পরিচালক
    51 Exchange Building
    132 Commercial Street
    E1 6NG London
    EnglandBritish68845270002
    GREGORY, Fraser David
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    পরিচালক
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    United KingdomBritish107664270001
    HEMMING, Eric Rodney
    The Elms
    4 Clifton Drive
    FY8 5PP Lytham St. Annes
    Lancashire
    পরিচালক
    The Elms
    4 Clifton Drive
    FY8 5PP Lytham St. Annes
    Lancashire
    British84030950001
    HOLDEN, Dean Allan
    Spring House
    Spring Hill Fordcombe
    TN3 0SE Tunbridge Wells
    Kent
    পরিচালক
    Spring House
    Spring Hill Fordcombe
    TN3 0SE Tunbridge Wells
    Kent
    British32671980002
    HOLLINGSWORTH, Clare Margaret
    House Farm
    Crowhurst Lane Crowhurst
    RH7 6LR Lingfield
    Mansion
    Surrey
    পরিচালক
    House Farm
    Crowhurst Lane Crowhurst
    RH7 6LR Lingfield
    Mansion
    Surrey
    United KingdomBritish62952630002
    JONES, Richard James Edward
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    পরিচালক
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    EnglandBritish133019680001
    KEE, Fergus Alexander
    The Old Cottage
    Howe Green
    SG13 8LH Hertford
    পরিচালক
    The Old Cottage
    Howe Green
    SG13 8LH Hertford
    United KingdomIrish26911740008
    KENT, Benjamin David Jemphrey
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish93897360003
    KING, Raymond
    Westlands House
    Cowfold Road West Grinstead
    RH13 8LZ Horsham
    West Sussex
    পরিচালক
    Westlands House
    Cowfold Road West Grinstead
    RH13 8LZ Horsham
    West Sussex
    British56146040001
    LEA, Edward William
    81 Castle Road
    AL1 5DQ St. Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    81 Castle Road
    AL1 5DQ St. Albans
    Hertfordshire
    British28018450003
    PRESTON, David James
    4 Victoria Mansions
    Navigation Way Ashton On Ribble
    PR2 2YX Preston
    Lancashire
    পরিচালক
    4 Victoria Mansions
    Navigation Way Ashton On Ribble
    PR2 2YX Preston
    Lancashire
    British46551430003
    ROGER, Robert
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    পরিচালক
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United KingdomBritish151959030001
    SARSFIELD, Vincent Gerard
    Little Lowes Fold Heath Lane
    Lowton
    WA3 2SJ Warrington
    Cheshire
    পরিচালক
    Little Lowes Fold Heath Lane
    Lowton
    WA3 2SJ Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish5491860001
    SMITH, Graham
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish142125320001
    SMITH, Graham
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish142125320001
    STEVENS, Geoffrey Robert
    Beech House
    3 Millhouses Court
    S11 9HZ Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    Beech House
    3 Millhouses Court
    S11 9HZ Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish57380020001
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    পরিচালক
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish6658190001

    TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Security accession deed
    তৈরি করা হয়েছে ২২ অক্টো, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ অক্টো, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any charging company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland (The Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ২৯ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ অক্টো, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ জুল, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ জুল, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited as Borrower Security Trustee (as Defined Therein)
    ব্যবসায়
    • ৩১ জুল, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ আগ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ জুল, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জুল, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Tunbridge wells independent hospital ashurst park fordcombe tunbridge wells t/no K709645 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ জানু, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    ব্যবসায়
    • ২৫ মার্চ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ ডিসে, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জানু, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof, fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts andthe benefits of any licences l/h property comprised in title no k 709645 being a lease of ashurst park independent hospital fordcombe road tunbridge wells kent from ibh limited (1) to ashurst park independent hospital limited (2) dated 21/8/91.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ জানু, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ ডিসে, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২১ আগ, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ সেপ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage l/h property, tunbridge wells independent hospital tunbridge wells kent. Including all fixtures fittings other than trade fixtures and fittings plant and machinery. (See form 395 and continuation sheet for full details document M114). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yorkshire Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ সেপ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৩ জানু, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুল, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ আগ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or any of the other companies named therein to the chargee on any account
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See for 395 document M13C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yorkshire Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ আগ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৩ জানু, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ জানু, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    500000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land at ashurst park fordcombe county of kent being part of land comprised in t/no. K535622.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ibh Limited.
    ব্যবসায়
    • ২৪ জানু, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৩ জানু, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ অক্টো, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ অক্টো, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land at ashurst park near fordcombe road, fordcombe in the company of kent title no K535622. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yorkshire Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ অক্টো, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৩ জানু, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0