CS LEISURE LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCS LEISURE LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিসক্রিয়
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02357146
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CS LEISURE LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ক্রীড়া সুবিধার অপারেশন (93110) / কলা, বিনোদন এবং বিনোদন
    • ক্রীড়া ক্লাবের কার্যক্রম (93120) / কলা, বিনোদন এবং বিনোদন
    • ফিটনেস সুবিধা (93130) / কলা, বিনোদন এবং বিনোদন
    • অন্যান্য বিনোদন এবং বিনোদন কার্যক্রম এন.ই.সি. (93290) / কলা, বিনোদন এবং বিনোদন

    CS LEISURE LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    C/O Pure Gym Limited
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    United Kingdom
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CS LEISURE LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    C.S. LEISURE PLC২৮ মে, ১৯৯৯২৮ মে, ১৯৯৯
    L.A. FITNESS PLC৩১ জুল, ১৯৮৯৩১ জুল, ১৯৮৯
    HURSTREEL INVESTMENTS PLC০৮ মার্চ, ১৯৮৯০৮ মার্চ, ১৯৮৯

    CS LEISURE LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণনা
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ ডিসে, ২০২৪
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩০ সেপ, ২০২৫
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০২৩

    CS LEISURE LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০১ জুন, ২০২৫
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে১৫ জুন, ২০২৫
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০১ জুন, ২০২৪
    মেয়াদোত্তীর্ণনা

    CS LEISURE LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    ৩১ ডিসে, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Clive Alexander Sloan Chesser-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩১ ডিসে, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Rebecca Elizabeth Passmore-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩১ ডিসে, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Humphrey Michael Cobbold এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২৩ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    ০১ জুন, ২০২৪ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    ০১ জুন, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ০১ জুন, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ মে, ২০২২ তারিখে Mr Alexander Basil John Wood-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    ০১ জুন, ২০২১ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    ০১ জুন, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ০১ নভে, ২০১৯ তারিখে Mr Humphrey Michael Cobbold-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    ০১ জুন, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ১০ অক্টো, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Adam John Gordon Bellamy এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১০ অক্টো, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Alexander Basil John Wood-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১০ অক্টো, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে Adam John Gordon Bellamy এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ০১ জুন, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    ৩০ নভে, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Peter William Denby Roberts এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩০ নভে, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jacques De Bruin এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    Jacques De Bruin কে পরিচালক হিসাবে নিয়োগের জন্য দ্বিতীয় দাখিল

    6 পৃষ্ঠাRP04AP01

    CS LEISURE LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CHESSER, Clive Alexander Sloan
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    পরিচালক
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Executive Officer329718250001
    PASSMORE, Rebecca Elizabeth
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    পরিচালক
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Operating Officer330745170001
    WOOD, Alexander Basil John
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    পরিচালক
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer251374440001
    BELLAMY, Adam John Gordon
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    সচিব
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    198433740001
    DIMENT, Peter Charles Michael
    4 Westfield Close
    CM23 2RD Bishops Stortford
    Hertfordshire
    সচিব
    4 Westfield Close
    CM23 2RD Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British32770400001
    ROONEY, June Kay
    Chelsea Reach
    Molember Road
    KT8 9NH East Molesey
    Surrey
    মনোনীত সচিব
    Chelsea Reach
    Molember Road
    KT8 9NH East Molesey
    Surrey
    British900006120001
    STORR, Christopher James
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    সচিব
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    British114849640001
    TAYLOR, Graham
    14 Roupell Street
    SE1 8SP London
    সচিব
    14 Roupell Street
    SE1 8SP London
    British82374420004
    TURNER, David
    1 Village Close
    Belsize Lane Hampstead
    NW3 5AH London
    সচিব
    1 Village Close
    Belsize Lane Hampstead
    NW3 5AH London
    British5194700001
    WENBOURNE, Stewart James
    56 Bladindon Drive
    DA5 3BN Bexley
    Kent
    সচিব
    56 Bladindon Drive
    DA5 3BN Bexley
    Kent
    British49164890001
    BELLAMY, Adam John Gordon
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    পরিচালক
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector172693720002
    BROSTER, Stuart Paul
    Greystones Bromley Road
    Cockleford Heath Ardleigh
    CO7 7SE Colchester
    Essex
    পরিচালক
    Greystones Bromley Road
    Cockleford Heath Ardleigh
    CO7 7SE Colchester
    Essex
    United KingdomBritishDirector114847350001
    BRUIN, Jacques De
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    পরিচালক
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    United KingdomSouth AfricanDirector198346420001
    CAMERON, Kay Marie
    6 Melton Courtwalk
    Amyand Park Road
    TW1 3HT Great Margarets
    Twickenham
    পরিচালক
    6 Melton Courtwalk
    Amyand Park Road
    TW1 3HT Great Margarets
    Twickenham
    BritishAdmin Dir35981770002
    CHESTER, Ross Steven
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    পরিচালক
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    BritishDirector137527310001
    COBBOLD, Humphrey Michael
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    পরিচালক
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector100141010002
    LONG, Martin
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    পরিচালক
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector125885350001
    MCCOLL, Arthur
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    পরিচালক
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    AustraliaBritishDirector139099550001
    ROBERTS, Peter William Denby
    Hutts Lane, Grewelthorpe
    HG4 3DA Ripon
    The Hutts
    United Kingdom
    পরিচালক
    Hutts Lane, Grewelthorpe
    HG4 3DA Ripon
    The Hutts
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector106538510001
    STORR, Christopher James
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    পরিচালক
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    United KingdomBritishDirector114849640001
    TAYLOR, Bryce Robert
    Jasmine House North Street
    Winkfield
    SL4 4SY Windsor
    Berkshire
    পরিচালক
    Jasmine House North Street
    Winkfield
    SL4 4SY Windsor
    Berkshire
    NzCompany Director64749400001
    TAYLOR, Jeremy Guy
    59 Sandlands Road
    KT20 7XB Walton On The Hill
    Surrey
    পরিচালক
    59 Sandlands Road
    KT20 7XB Walton On The Hill
    Surrey
    BritishDirector117619380001
    TAYLOR, Richard
    33 Green Lane
    HA8 7PS Edgware
    Middlesex
    পরিচালক
    33 Green Lane
    HA8 7PS Edgware
    Middlesex
    BritishFinance Director71126560002
    TURNER, David
    1 Village Close
    Belsize Lane Hampstead
    NW3 5AH London
    পরিচালক
    1 Village Close
    Belsize Lane Hampstead
    NW3 5AH London
    United KingdomBritishDirector5194700001
    TUROK, Frederick Oliver
    1 Broome Hall
    RH5 6HJ Cold Harbour
    Surrey
    পরিচালক
    1 Broome Hall
    RH5 6HJ Cold Harbour
    Surrey
    EnglandSouth AfricanDirector41174400002
    WOODROW, Peter Alastair
    Tylers Croft
    Hitchen Hatch Lane
    TN13 3AY Sevenoaks
    Kent
    পরিচালক
    Tylers Croft
    Hitchen Hatch Lane
    TN13 3AY Sevenoaks
    Kent
    BritishCorporate Finance Executive22426500001

    CS LEISURE LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Town Centre House
    Merrion Centre
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Town Centre House
    Merrion Centre
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশUnited Kingdom
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর03224406
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    CS LEISURE LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জুন, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ জুন, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The winners club 9 dennis parade winchmore hill road london t/no EGL373650. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৩ জুন, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ২১ অক্টো, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Fixed and floating security document
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ আগ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ সেপ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The property k/a royal oak centre brighton road purley surrey CR8 2PG (for further properties charged please see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Trustee for the Secured Parties (Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ০৫ সেপ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ আগ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুল, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Lower ground and ground floors regent house 291/307 kirkdale sydenham and units 1 and 6 regent house london borough of lewisham t/nos TGL137439 TGL137436 TGL137435.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জুন, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুল, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    9 dennis parade winchmore hill southgate london borough of enfield t/n EGL373650.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জুন, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুল, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Ground and first floor warwick squash club welton road wedgenock industrial estate warwick warwickshire t/n WK378482.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জুন, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুল, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Umit 6 and units 8-12 royal oak shopping centre brighton road purley london borough of croydon t/n SGL606941.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জুন, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ মে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জুন, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The l/h property k/a the leisure centre lion wharf road old isleworth middlesex. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ এপ্রি, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ জুন, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুন, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a 9 dennis parade winchmore hill southgate london. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০২ জুন, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জুন, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Springdale spa health club 291 kirkdale sydenham london. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ মে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ মে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ মে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জুন, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a swan court, swan street, old isleworth business village, old isleworth, middlesex and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ জুন, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ মে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জুন, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ জুন, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জুন, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুন, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • B.Taylor
    ব্যবসায়
    • ১১ জুন, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ আগ, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জুল, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ আগ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ আগ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১২ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0