RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামRELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিলিকুইডেশন
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02368530
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    124 Rookery Road
    Handsworth
    B21 9NN Birmingham
    England And Wales
    United Kingdom
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) PLC১৫ মার্চ, ২০১২১৫ মার্চ, ২০১২
    RELIGARE CAPITAL MARKETS PLC১০ মার্চ, ২০১০১০ মার্চ, ২০১০
    RELIGARE HICHENS, HARRISON PLC০১ আগ, ২০০৮০১ আগ, ২০০৮
    HICHENS, HARRISON & CO. PLC০৫ এপ্রি, ১৯৮৯০৫ এপ্রি, ১৯৮৯

    RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ মার্চ, ২০২০
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩১ মার্চ, ২০২১
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১৯

    RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০৬ ফেব, ২০২১
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে২০ মার্চ, ২০২১
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০৬ ফেব, ২০২০
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    আদালতের আদেশ উইন্ডিং আপের জন্য

    3 পৃষ্ঠাCOCOMP

    ০৬ ফেব, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    35 পৃষ্ঠাAA

    ১৫ অক্টো, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr. Amarjeet Singh Arora-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ বন্ধ করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাDISS40

    ০৬ ফেব, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ২৯ মার্চ, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Rajesh Sharma এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাDISS16(SOAS)

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    40 পৃষ্ঠাAA

    ১৭ সেপ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mark Alastair Runacres এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৪ ডিসে, ২০১৮ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Shivinder Mohan Singh এর বন্ধ

    1 পৃষ্ঠাPSC07

    ১৪ ডিসে, ২০১৮ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Malvinder Mohan Singh এর বন্ধ

    1 পৃষ্ঠাPSC07

    ১৪ ডিসে, ২০১৮ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Rajesh Sharma এর বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাPSC01

    ১৬ নভে, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে Tmf Corporate Administration Services Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ২২ এপ্রি, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Brian William Tempest এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৬ ফেব, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    ১৪ নভে, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Anil Saxena এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    37 পৃষ্ঠাAA

    ১২ অক্টো, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Rajesh Sharma-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৮ সেপ, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Sunil Kumar Garg এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৬ ফেব, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    7 পৃষ্ঠাCS01

    ০১ অক্টো, ২০১৬ তারিখে Mark Alastair Runacres-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১১ জানু, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা The Studio 1 Doughty Street London WC1N 2PH থেকে 124 Rookery Road Handsworth Birmingham England and Wales B21 9NNপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    83 পৃষ্ঠাAA

    RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    ARORA, Amarjeet Singh, Mr.
    I-42, Ff, Jangpura Extension, Delhi
    110014 Jangpura
    I-42, Ff, Jangpura Extension, Delhi
    New Delhi
    India
    পরিচালক
    I-42, Ff, Jangpura Extension, Delhi
    110014 Jangpura
    I-42, Ff, Jangpura Extension, Delhi
    New Delhi
    India
    IndiaIndian263432890001
    AVES, Peter Nicholas
    26 Sidney Square
    E1 2EY London
    সচিব
    26 Sidney Square
    E1 2EY London
    British71180520001
    BAILEY, Dennis Bryan
    Tile House
    Shepherds Green
    RG9 4QW Rotherfield Greys Henley On Thames
    Oxfordshire
    সচিব
    Tile House
    Shepherds Green
    RG9 4QW Rotherfield Greys Henley On Thames
    Oxfordshire
    British4881010002
    GARMON JONES, Richard
    Plas Newydd
    Devonshire Avenue
    HP6 5JF Amersham
    Buckinghamshire
    সচিব
    Plas Newydd
    Devonshire Avenue
    HP6 5JF Amersham
    Buckinghamshire
    British85123650003
    NOROSE COMPANY SECRETARIAL SERVICE LTD
    3 More London Riverside
    SE1 2AQ London
    কর্পোরেট সচিব
    3 More London Riverside
    SE1 2AQ London
    123465420001
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    6 St Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    England
    কর্পোরেট সচিব
    6 St Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    England
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর06902863
    140723560001
    TMF NOMINEES LIMITED
    Capability Green
    LU1 3AE Luton
    400
    Bedfordshire
    কর্পোরেট সচিব
    Capability Green
    LU1 3AE Luton
    400
    Bedfordshire
    136449070001
    BAILEY, Dennis Bryan
    Tile House
    Shepherds Green
    RG9 4QW Rotherfield Greys Henley On Thames
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Tile House
    Shepherds Green
    RG9 4QW Rotherfield Greys Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish4881010002
    BALANI, Jaickismin Wadhumal
    Compas De La Victoria
    Malaga
    29012
    Spain
    পরিচালক
    Compas De La Victoria
    Malaga
    29012
    Spain
    Spanish25676590001
    BHANSALI, Pankaj, Mr.
    B Dheeraj Gaurav Heights Ii
    Off Link Road, Oshiwara, Andheri (W)
    Mumbai
    400053
    India
    পরিচালক
    B Dheeraj Gaurav Heights Ii
    Off Link Road, Oshiwara, Andheri (W)
    Mumbai
    400053
    India
    IndiaIndian135937020004
    CAMPBELL, Jeremy Philip
    The Brough
    Upper Hartfield
    TN7 4DL Hartfield
    East Sussex
    পরিচালক
    The Brough
    Upper Hartfield
    TN7 4DL Hartfield
    East Sussex
    British24078880001
    COIA, Gary James
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    100
    পরিচালক
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    100
    United KingdomBritish174444760001
    DELMAR-MORGAN, Jeremy
    5 Western Terrace
    Hammersmith
    W6 9TX London
    পরিচালক
    5 Western Terrace
    Hammersmith
    W6 9TX London
    United KingdomBritish23953030001
    DHILLON, Gurpreet Singh, Mr.
    20 Dunraven Street
    W1K 7FF London
    Flat 1
    পরিচালক
    20 Dunraven Street
    W1K 7FF London
    Flat 1
    United KingdomSpanish134369040001
    DURRENT, Simon Tobias
    Turneville Road
    W14 9PS London
    32
    পরিচালক
    Turneville Road
    W14 9PS London
    32
    British138367220001
    GARG, Sunil Kumar
    District Centre
    Saket
    110017 New Dehli
    D3 P3b
    India
    পরিচালক
    District Centre
    Saket
    110017 New Dehli
    D3 P3b
    India
    IndiaIndian206396590001
    GONZENBACH, Gerald
    Flat 8 Cranley Place
    SW7 3AB London
    পরিচালক
    Flat 8 Cranley Place
    SW7 3AB London
    Swiss79153450002
    HOWARD SMITH, John Christopher Anthony
    Hill End
    Woodcote Side
    KT18 7HB Epsom
    Surrey
    পরিচালক
    Hill End
    Woodcote Side
    KT18 7HB Epsom
    Surrey
    British81994350001
    HYTNER, Robert William
    6 Bressingham Gardens
    CM3 5RF Southwoodham Ferrers
    Essex
    পরিচালক
    6 Bressingham Gardens
    CM3 5RF Southwoodham Ferrers
    Essex
    British76950590001
    KUNATHARAJU, Venkata Raghuram Raju, Mr.
    Saket
    New Delhi
    D3 P3b District Centre
    110017
    India
    পরিচালক
    Saket
    New Delhi
    D3 P3b District Centre
    110017
    India
    IndiaIndian168289440001
    MCGUIRE, Roland Clive
    Ironwood
    Heath Drive Walton On The Hill
    KT20 7QJ Tadworth
    Surrey
    পরিচালক
    Ironwood
    Heath Drive Walton On The Hill
    KT20 7QJ Tadworth
    Surrey
    EnglandEnglish24078890001
    MEHROTRA, Ravi Umesh
    Estoril Court
    55, Garden Road, Mid Levels
    Hong Kong
    40a Block 1
    Hong Kong
    পরিচালক
    Estoril Court
    55, Garden Road, Mid Levels
    Hong Kong
    40a Block 1
    Hong Kong
    IndiaIndian162836300001
    NATH, Shachindra
    Villas At Palm Springs
    Sector 54 Urban Estate
    122001 Gurgagon
    Tpv-Gv-65
    Haryana
    India
    পরিচালক
    Villas At Palm Springs
    Sector 54 Urban Estate
    122001 Gurgagon
    Tpv-Gv-65
    Haryana
    India
    IndiaIndian129564460003
    NEWSON, Martin John
    Palace Gardens Terrace
    W8 4RP London
    22
    পরিচালক
    Palace Gardens Terrace
    W8 4RP London
    22
    United KingdomBritish146049450001
    PUNTER, Jonathan Dominic
    7 Orchard Drive
    Blackheath
    SE3 0QP London
    পরিচালক
    7 Orchard Drive
    Blackheath
    SE3 0QP London
    United KingdomBritish26297750001
    ROWBOTHAM, Brian
    7 Dundee Court
    73 Wapping High Street
    E1W 2YG London
    পরিচালক
    7 Dundee Court
    73 Wapping High Street
    E1W 2YG London
    EnglandBritish88067200001
    RUNACRES, Mark Alastair
    Safdarjung Enclave
    New Delhi
    110029 Delhi
    A1/166, Second Floor
    India
    পরিচালক
    Safdarjung Enclave
    New Delhi
    110029 Delhi
    A1/166, Second Floor
    India
    IndiaBritish140980120004
    SAMUELS, James Anthony Angus
    Flat 6
    34 Stanhope Gardens
    SW7 5QY London
    পরিচালক
    Flat 6
    34 Stanhope Gardens
    SW7 5QY London
    EnglandBritish66307920004
    SAXENA, Anil
    Sector 104
    Gautam Buddha Nagar
    201304 Noida
    Flat No. 4222, Tower 4, Ats One Hamlet
    Uttar Pradesh
    India
    পরিচালক
    Sector 104
    Gautam Buddha Nagar
    201304 Noida
    Flat No. 4222, Tower 4, Ats One Hamlet
    Uttar Pradesh
    India
    IndiaIndian129564380005
    SHARMA, Rajesh
    Rookery Road
    Handsworth
    B21 9NN Birmingham
    124
    England And Wales
    United Kingdom
    পরিচালক
    Rookery Road
    Handsworth
    B21 9NN Birmingham
    124
    England And Wales
    United Kingdom
    IndiaIndian239345240001
    TEMPEST, Brian William, Dr
    Grayswood Road
    GU27 2DJ Haslemere
    South Park Farm
    Surrey
    England
    পরিচালক
    Grayswood Road
    GU27 2DJ Haslemere
    South Park Farm
    Surrey
    England
    United KingdomBritish124004410003
    THOMAS, Colin Richard
    Moorcroft 56 Lammas Lane
    KT10 8PD Esher
    Surrey
    পরিচালক
    Moorcroft 56 Lammas Lane
    KT10 8PD Esher
    Surrey
    EnglandBritish40946090002
    WILSON, Adam Richard
    78 Park Street
    Mayfair
    W1K 2JZ London
    পরিচালক
    78 Park Street
    Mayfair
    W1K 2JZ London
    United Arab EmiratesBritish114909720002
    WONG QUEE QUEE, Jeffrey
    43rd Floor Uob Plaza 1
    048624 Singapore
    80 Raffles Place
    Singapore
    পরিচালক
    43rd Floor Uob Plaza 1
    048624 Singapore
    80 Raffles Place
    Singapore
    SingaporeSingapore Citizen170574120001

    RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Mr. Rajesh Sharma
    Rookery Road
    Handsworth
    B21 9NN Birmingham
    124
    England And Wales
    United Kingdom
    ১৪ ডিসে, ২০১৮
    Rookery Road
    Handsworth
    B21 9NN Birmingham
    124
    England And Wales
    United Kingdom
    না
    জাতীয়তা: Indian
    বাসস্থানের দেশ: India
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তি কোম্পানির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ ব্যায় করার অধিকার রাখেন বা কার্যত ব্যায় করেন।
    Mr. Malvinder Mohan Singh
    Janpath
    110001 New Delhi
    54
    India
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Janpath
    110001 New Delhi
    54
    India
    হ্যাঁ
    জাতীয়তা: Indian
    বাসস্থানের দেশ: India
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তি কোম্পানির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ ব্যায় করার অধিকার রাখেন বা কার্যত ব্যায় করেন।
    Mr. Shivinder Mohan Singh
    Janpath
    110001 New Delhi
    54
    India
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Janpath
    110001 New Delhi
    54
    India
    হ্যাঁ
    জাতীয়তা: Indian
    বাসস্থানের দেশ: India
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তি কোম্পানির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ ব্যায় করার অধিকার রাখেন বা কার্যত ব্যায় করেন।

    RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Headlease security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ জুল, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জুল, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the borrower to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property at 98-106 (even) cannon street and 9 laurence pountney hill, london, all buildings, fixtures, fixed plant and machinery, see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    ব্যবসায়
    • ২৪ জুল, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ মে, ২০১৩সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ চার্জ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে (MR05)
    • ২২ মার্চ, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deposit, charge and settlement agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ জুল, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জুল, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the borrower to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All of its right, title and interest in and to the deposit account and the deposit see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC (The Facility Agent) as Agent and Trustee for the Finance Parties
    ব্যবসায়
    • ২৪ জুল, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ মে, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ ডিসে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £10,465.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London
    ব্যবসায়
    • ৩১ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ মে, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ জুন, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জুন, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All personal property and fixtures, the security agreement. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Bank of New York
    ব্যবসায়
    • ১৯ জুন, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ জানু, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Terms of business agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১০ আগ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All obligations of the company or any associate under the agreement and under any transaction or other obligation of the company to the chargee or any associate of the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first, fixed charge and pledge over all deposits and margin and all securities, documents of or entering title property, cash or other assets of any nature held by or subject to the control of ics (or any nominee or custodian of ics) for the account of the company and a general lien and right of set-off.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Meespierson Ics Limited
    ব্যবসায়
    • ১৮ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ মে, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Supplemental deed
    তৈরি করা হয়েছে ১০ মার্চ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ মার্চ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company or any crest member to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first fixed charge all sums and payments receivable all right title and interest to and in all monies by way of first floating charge all eligible stock all and any property all and any sums. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of England
    ব্যবসায়
    • ১১ মার্চ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ মে, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Security deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ ফেব, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All debts obligations or liabilities whatsoever due or to become due from the company or by the crest member (as defined) to the chargee including all debts obligations and liabilities which arise out of or in connection with the provision of crest settlement bank facilities
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All sums and payments receivable by or for the company referable to the crest member in crest or any transfer by the company or the crest member of any of it's right title and interest in all stock represented by credit balance. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of England
    ব্যবসায়
    • ১৭ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ মে, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ এপ্রি, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All shares stock and other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The International Stock Exchange of the United Kingdom and the Republic of Ireland Limited
    ব্যবসায়
    • ২০ এপ্রি, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ সেপ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    RELIGARE CAPITAL MARKETS (EUROPE) LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    2
    তারিখপ্রকার
    ২৭ মার্চ, ২০২০আবেদন তারিখ
    ২৩ নভে, ২০২০ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    বাধ্যতামূলক তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    The Official Receiver Or Birmingham
    3rd Floor, Cannon House, 18 The Priory Queensway
    B4 6FD Birmingham
    অভ্যাসকারী
    3rd Floor, Cannon House, 18 The Priory Queensway
    B4 6FD Birmingham

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0