HELICAL PROPERTIES RETAIL LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামHELICAL PROPERTIES RETAIL LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02371285
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    HELICAL PROPERTIES RETAIL LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিজস্ব বা ভাড়াকৃত রিয়েল এস্টেটের অন্যান্য ভাড়া এবং পরিচালনা (68209) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম

    HELICAL PROPERTIES RETAIL LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    5 Hanover Square
    W1S 1HQ London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    HELICAL PROPERTIES RETAIL LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    DEALPLAN LIMITED১২ এপ্রি, ১৯৮৯১২ এপ্রি, ১৯৮৯

    HELICAL PROPERTIES RETAIL LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১৬

    HELICAL PROPERTIES RETAIL LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    চার্জ 34 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    2 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 35 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    2 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 36 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    ১২ জুল, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Duncan Charles Eades Walker এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১২ জুল, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Duncan Charles Eades Walker এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১২ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    ২৫ জুল, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Michael Eric Slade এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ১২ এপ্রি, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৪ এপ্রি, ২০১৬

    ১৪ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    27 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১২ এপ্রি, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৫ মে, ২০১৫

    ০৫ মে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    ০১ সেপ, ২০১৪ তারিখে Helical Registrars Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH04

    ১৩ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jack Struan Pitman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    ১৯ আগ, ২০১৪ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 11-15 Farm Street London W1J 5RS থেকে 5 Hanover Square London W1S 1HQপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ১২ এপ্রি, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৫ এপ্রি, ২০১৪

    ২৫ এপ্রি, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১২ এপ্রি, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Mr Timothy John Murphy-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Nigel Mcnair Scott এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১২ এপ্রি, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    HELICAL PROPERTIES RETAIL LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HELICAL REGISTRARS LIMITED
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    কর্পোরেট সচিব
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর4701446
    89869830001
    KAYE, Gerald Anthony
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    পরিচালক
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    United KingdomBritishDevelopment Director38299690006
    MURPHY, Timothy John
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    পরিচালক
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    EnglandBritishChartered Accountant40547240005
    FREEMAN, Benjamin Patrick
    24 Hurst Road
    KT8 9AF East Molesey
    Surrey
    সচিব
    24 Hurst Road
    KT8 9AF East Molesey
    Surrey
    British105715820001
    GONDHIA, Sima
    114 Squirrels Heath Lane
    RM11 2DY Hornchurch
    Essex
    সচিব
    114 Squirrels Heath Lane
    RM11 2DY Hornchurch
    Essex
    British83926180001
    GONDHIA, Sima
    114 Squirrels Heath Lane
    RM11 2DY Hornchurch
    Essex
    সচিব
    114 Squirrels Heath Lane
    RM11 2DY Hornchurch
    Essex
    British83926180001
    MARSTON, Lisa Margaret
    18 Terrapin Road
    Tooting
    SW17 8QN London
    সচিব
    18 Terrapin Road
    Tooting
    SW17 8QN London
    BritishSecretary27528570001
    ROLFE, Lee-Ann
    Flat 2 307 Upper Richmond Road
    Putney
    SW15 6SS London
    সচিব
    Flat 2 307 Upper Richmond Road
    Putney
    SW15 6SS London
    South African79280470001
    BROWN, Philip Michael
    Battle House
    Elvendon Road
    RG8 0DR Goring
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Battle House
    Elvendon Road
    RG8 0DR Goring
    Oxfordshire
    United KingdomBritishInvestment Director191384330001
    BUTCHER, Michael William
    19 Rigault Road
    SW6 4JJ London
    পরিচালক
    19 Rigault Road
    SW6 4JJ London
    BritishChartered Surveyor1279410002
    INWOOD, John Charles
    Letterbox House
    58 Windmill Road
    TW12 1QU Hampton Hill
    Middlesex
    পরিচালক
    Letterbox House
    58 Windmill Road
    TW12 1QU Hampton Hill
    Middlesex
    United KingdomBritishChartered Surveyor56398550002
    KAYE, Gerald Anthony
    Henham
    CM22 6AH Bishops Stortford
    The Glebe House
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Henham
    CM22 6AH Bishops Stortford
    The Glebe House
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDevelopment Director38299690006
    MCNAIR SCOTT, Nigel Guthrie
    11-15 Farm Street
    London
    W1J 5RS
    পরিচালক
    11-15 Farm Street
    London
    W1J 5RS
    EnglandBritishFinance Director6065190002
    MOSS, Brian
    70 Deverill Court
    Avenue Road
    SE20 7SA London
    পরিচালক
    70 Deverill Court
    Avenue Road
    SE20 7SA London
    BritishProperty Manager35008800001
    PITMAN, Jack Struan
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    পরিচালক
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    United KingdomBritishInvestment Director74487000002
    SCOTT, Clive David
    Eildon Hall
    TD6 9HD Melrose
    Roxburghshire
    পরিচালক
    Eildon Hall
    TD6 9HD Melrose
    Roxburghshire
    BritishDirector48826800001
    SLADE, Michael Eric
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    পরিচালক
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    EnglandBritishManaging Director38913980001
    WALKER, Duncan Charles Eades
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    পরিচালক
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    United KingdomBritishSurveyor129346360008

    HELICAL PROPERTIES RETAIL LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Helical Plc
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    না
    আইনি ফর্মPublic Limited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland And Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানRegistrar Of Companies (England And Wales)
    নিবন্ধন নম্বর156663
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    HELICAL PROPERTIES RETAIL LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ জুল, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ জুল, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or helical bar PLC to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings on the north east side of winterstoke road weston super mare north somerset t/n AV166133.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ জুল, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ আগ, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ মে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All liabilities due or to become due from helical bar PLC to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold property known as vaults under the footway on the south west side of kingsway london borough of camden; t/no 218813. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ আগ, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ মে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All liabilities due or to become due from helical bar PLC to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/Hold property known as international buildings 67/75 kingsway london borough of camden; t/no ngl 334488. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ আগ, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ অক্টো, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ নভে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or helical bar PLC to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Great surrey house 203 to 208 blackfriars road (inclusive) southwark l/b of southwark t/no's SGL322825 TGL2938.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ অক্টো, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ নভে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or helical baar PLC to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    5 to 10 bury street (inclusive) l/b of city of london t/no NGL297979.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ নভে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ নভে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due from helical bar PLC to the chargee under the terms of the facility letter (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that area or piece of ground lying to the north of carse road inverness part of telford street retail park inverness. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    ব্যবসায়
    • ০৬ নভে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ আগ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ নভে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ নভে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a guarantee dated 02.11.93
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge over all and whole the area of ground lying generally to thw north of carse road inverness part of the telford street retail park inverness. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ নভে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ আগ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rental assignation
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ অক্টো, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ নভে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the rental assignation
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rents payable under a lease dated 25.10.88 and 25.05.89 and registered in the books of the council and session on 14.06.89 of unit d telford street retail park inverness.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    ব্যবসায়
    • ০৬ নভে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ আগ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    First legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জানু, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 23-6-89 and/or this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and premises adjoining marcham road and nuffield way abingdon oxfordshire fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Security Pacific National Bank
    ব্যবসায়
    • ০৬ ফেব, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জুল, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ আগ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 23.6.89 and this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and premises on the south side of gorseinon road, garngoch west glamorgan title no wa 153997 WA278451 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment for mor details see form 395 ref M135.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Security Pacific National Bank
    ব্যবসায়
    • ০৮ আগ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জুল, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from the company to security pacific national bank under the terms of a loan agreement dated 23RD june 1989 was registered pursuant to chapter 1, part xii of the companies act 1985, on 19TH july 1989.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    20, 22 & 24 graham st, and 14 collon st & 26, 28 & 30 (rear) graham st, airdrie see 395 ref: 416C.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Security Pacific National Bank
    ব্যবসায়
    • ১৯ জুল, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জুল, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from the company to security pacific national bank under the terms of a loan agreement dated 23RD june 1989. was registed pursuant to chapter 1, part xii of the companies act 1985, on 19TH july 1989.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All & whole that plot of ground at bank st, coatbridge in the parish of old monkland & county of lanark extending to fifty six decimal or one hundredth parts of an acre or thereby (for full details see 395 tc ref: M418C).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Security Pacific National Bank
    ব্যবসায়
    • ১৯ জুল, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ জুল, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 23/6/87 (as agent)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land & buildings at the junction of anchor lane & west henderson's wynd, dundee angus & land lying to the north of anchor lane.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Security Pacific National Bank
    ব্যবসায়
    • ১৪ জুল, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    Standard security
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ জুল, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 23/6/89 (as agent)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land & buildings lying on the south west side of newhaven road edinburgh midlothian.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Security Pacific National Bank
    ব্যবসায়
    • ১৪ জুল, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    Standard security
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ জুল, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 23/6/89 (as agent)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Weston house hay street elgin.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Security Pacific National Bank
    ব্যবসায়
    • ১৪ জুল, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    First legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ জুন, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ জুল, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    For securing £44,540,000 due to the chargee.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that land and buildings situate thereon on the east side of faraday close and north west side of marshall road, east sussex eastborne title no esx 128546 by way of fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See doc 395/136/c/2117 for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Security Pacific National Bank
    ব্যবসায়
    • ১৩ জুল, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    First legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ জুন, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £44,540,000 secured on property acquired by helical properties retail l imited
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H piece or parcel of land with buildings situate thereon 51, 53, 55, high st., & 10, walkers lane, kettering., Fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment and building materials of all kinds. Please see mort doc M383 for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Security Pacific National Bank
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    First legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ জুন, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £44,540,000 secured on property acquired by helical properties retail limited
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land k/a 116, crayford rd, bexley, kent title no: p 48787 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment and building materials of all kinds. Please see mort doc M379 for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Security Pacific National Bank
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ জুন, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent for the banks) under the terms of a loan agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land k/a 47 to 49 high street dortford l/b of kent t/no k 61397 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Security Pacific National Bank
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ জুন, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent for the banks) under the terms of a loan agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land & buildings to the west of hexhon road swalwell gateshead tyne & wear t/no ty 80118 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Security Pacific National Bank
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ জুন, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent for the banks) under the terms of a loan agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land with retail warehouse premises situate at walworth road & nightingale road hitchin herts fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Security Pacific National Bank
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ জুন, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent for the banks) under the terms of a loan agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land & buildings k/a the showroom, berkeley court at the junction of scotter road & doncaster road scunthorpe humberside t/no hs 89450 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Security Pacific National Bank
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ জুন, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent for the banks) under the terms of a loan agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land & premises k/a 558 cowbridge road east cardiff t/no wa 126535 & land & buildings on the east side of alasworth road cardiff fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Security Pacific National Bank
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ জুন, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent for the banks) under the terms of a loan agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land & buildings on the southside of porteland road cowgate newcastle upon tyne tyne & wear t/no ty 102313 fixed charge over all moveable plant machineryimplements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Security Pacific National Bank
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ জুন, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent for the banks) under the terms of a loan agreement of even date.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land & buildings k/a no 6 & 8 aughton street ormskirk fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Security Pacific National Bank
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৭ জানু, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0