TERMINUS 36 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTERMINUS 36 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02385062
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TERMINUS 36 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7415) /

    TERMINUS 36 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    1 Apex Business Centre
    Boscombe Road
    LU5 4SB Dunstable
    Bedfordshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TERMINUS 36 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    POLESTAR NEWS & CONSUMER LIMITED০৩ জুল, ২০০০০৩ জুল, ২০০০
    POLESTAR POWERPRINT LIMITED২২ জুন, ১৯৯৯২২ জুন, ১৯৯৯
    POLESTAR GRAVURE LIMITED০৬ নভে, ১৯৯৮০৬ নভে, ১৯৯৮
    BPC CATALOGUES LTD১৮ জানু, ১৯৯৪১৮ জানু, ১৯৯৪
    BPCC CATALOGUES LTD০৮ নভে, ১৯৮৯০৮ নভে, ১৯৮৯
    WIDESHINE LIMITED১৬ মে, ১৯৮৯১৬ মে, ১৯৮৯

    TERMINUS 36 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০০৯

    TERMINUS 36 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    5 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ০৯ মে, ২০১১

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    বার্ষিক রিটার্ন ১৪ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২০ অক্টো, ২০১০

    ২০ অক্টো, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 50,001,002
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৪ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    ৩১ জুল, ২০০৯ তারিখে Alan Goodwin-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ৩১ জুল, ২০০৯ তারিখে Alan Goodwin-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    29 পৃষ্ঠা395

    legacy

    28 পৃষ্ঠা395

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    TERMINUS 36 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    GOODWIN, Alan
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    সচিব
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    BritishCompany Secretary98921850001
    GOODWIN, Alan James
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    পরিচালক
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    United KingdomBritishCompany Secretary98921850003
    HEARN, Catherine Ann
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishGroup Hr Director83713930001
    HIBBERT, Barry Alan
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    পরিচালক
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    United KingdomBritishChief Executive Officer68122470005
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Peters Lane
    HP27 OLQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    পরিচালক
    Peters Lane
    HP27 OLQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    EnglandBritishFinance Director138015860001
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    সচিব
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British987230001
    ADLEM, Philip
    4 Upton Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HX Cheadle
    Cheshire
    পরিচালক
    4 Upton Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HX Cheadle
    Cheshire
    BritishSales Director70694890001
    ALDREN, Stephen
    59 Seward Road
    WR11 7HQ Badsey
    Evesham
    পরিচালক
    59 Seward Road
    WR11 7HQ Badsey
    Evesham
    United KingdomBritishFinance Director105696350001
    BRAMLEY, Christopher John
    6 Park Farm Court
    Longwell Green
    BS30 7EE Bristol
    Avon
    পরিচালক
    6 Park Farm Court
    Longwell Green
    BS30 7EE Bristol
    Avon
    BritishDivisional Managing Director67411960001
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant987230001
    BROWN, Frederick James
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    পরিচালক
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    BritishChief Executive Officer16105360002
    CLARK, Stephen John
    Beaumont House Evesham Road
    Salford Priors
    WR11 5UU Evesham
    Worcestershire
    পরিচালক
    Beaumont House Evesham Road
    Salford Priors
    WR11 5UU Evesham
    Worcestershire
    BritishManaging Director49702240002
    GARNHAM, Peter John Jennings
    121 Selby Road
    NG2 7BB West Bridgford
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    121 Selby Road
    NG2 7BB West Bridgford
    Nottinghamshire
    BritishManufacturing Director73519870001
    GWILLIAM, Paul Raymond
    The Hazel The Briars
    Hawkridge
    BA14 6AD Yarnbrook
    Wiltshire
    পরিচালক
    The Hazel The Briars
    Hawkridge
    BA14 6AD Yarnbrook
    Wiltshire
    BritishFinance Director63643220001
    HOLLORAN, Peter John
    Southmoor Farmhouse
    Stonehill Lane Southmoor
    OX13 5HU Abingdon
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Southmoor Farmhouse
    Stonehill Lane Southmoor
    OX13 5HU Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritishGroup Chief Executive61418710001
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    পরিচালক
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    BritishGroup Finance Director83714120001
    MEDLER, Christopher Robert
    Harvest House
    Salters Meadow Tolleshunt Darcy
    CM9 8JE Maldon
    Essex
    পরিচালক
    Harvest House
    Salters Meadow Tolleshunt Darcy
    CM9 8JE Maldon
    Essex
    BritishAccountant32618460001
    MILES, Steven
    13 Simon De Montfort Drive
    WR11 4NR Evesham
    Worcestershire
    পরিচালক
    13 Simon De Montfort Drive
    WR11 4NR Evesham
    Worcestershire
    BritishCommercial Director70694940001
    PAVEY, Ian Malcolm
    The Old Post Office
    Ardens Grafton
    B49 6DS Alcester
    Warwickshire
    পরিচালক
    The Old Post Office
    Ardens Grafton
    B49 6DS Alcester
    Warwickshire
    BritishHr Director73168740003
    PAVLOSKY, Christopher John
    HP17 9LT Askett
    Askett House
    Bucks
    পরিচালক
    HP17 9LT Askett
    Askett House
    Bucks
    United KingdomBritishChief Operating Officer151956700001
    PIGOTT, Neil
    179 Harrow Road
    Wollaton Park
    NG8 1FL Nottingham
    পরিচালক
    179 Harrow Road
    Wollaton Park
    NG8 1FL Nottingham
    BritishSales Director37801830001
    PURCELL, John Carlsson
    Wharfedale 3 Beaufort Close
    HP21 9BB Aylesbury
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Wharfedale 3 Beaufort Close
    HP21 9BB Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishKey Accounts Director70644890001
    ROBERTSON, Malcolm Murray
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director39155140002
    RUDSTON, Anthony
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    EnglandBritishGroup Chief Executive44908110001
    STATON, David Montague
    23 Southfield Drive
    Hazlemere
    HP15 6HB High Wycombe
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    23 Southfield Drive
    Hazlemere
    HP15 6HB High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishPersonnel Director15853080001
    SWATMAN, Kenneth John
    3 Trevelyan Way
    HP4 1JG Berkhamsted
    Hertfordshire
    পরিচালক
    3 Trevelyan Way
    HP4 1JG Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant73145410001
    TIMMINS, Richard Keith
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    পরিচালক
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    United KingdomBritishDirector127238050003

    TERMINUS 36 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ নভে, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    For details of properties charged please refer to the form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P. Morgan Europe Limited as Agent and Trustee for the Benefit of the Lenders
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Amendment agreement relating to the security agreement dated 13 december 2006 and
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ নভে, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    For properties charged please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P. Morgan Europe Limited as Agent and Trustee for the Benefit of the Lenders
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P.Morgan Europe Limited for Itself and as Agent and Trustee for Each of the Secured Creditors
    ব্যবসায়
    • ২২ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 19TH june 1998
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ সেপ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Restated amendment to the supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 19 june 1998 and dated 4 september 1998
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Chase Manhattan International Limited) as Security Trusteefor Itself and the Other Secured Parties or Such Other Person as May from Time to Time Be Appointed Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ১০ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Restated amendment of and accession to the composite guarantee & debenture dated 19/06/98
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Chase Manhattan International Limited) or Such Otherperson as May from Time to Time Be Appointed Security Agent and Trustee
    ব্যবসায়
    • ১০ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A composite guarantee and debenture between polestar,the polestar corporation PLC,certain subsidiaries of polestar and J.P.morgan europe limited
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জানু, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys and liabilities due or to become due from the chargor to the secured parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) and under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Including (I) l/hold over unit B5 blenheim industrial park estate,bury st edmunds,suffolk; (ii) l/hold unit 14 luton stadium estate,craddock rd,luton,bedfordshire; BD77546; (iii) l/hold over wigman rd,aspley,nottingham; t/nos NT78782 and NT180765; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P.Morgan Europe Limited,as Security Trstee for the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ১৫ ফেব, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A composite guarantee and debenture between the chargor, the polestar corporation PLC, certain subsidiaries of the chargor and chase manhattan international limited
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ নভে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chase Manhattan International Limited (As Security Trustee for Itself and Investcorp Fundinglimited)
    ব্যবসায়
    • ১৪ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জুন, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জুল, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys and discharging of all liabilities now or hereafter due, owing or incurred by the company and/or all or any of the other companies named therein (the "original UK charging subsidiaries") to the chargee in its capacity as security trustee for the banks, the agent, the security trustee, the arranger, the ancillary banks and the hedge counterparties (all as defined therein) or any of them including, without limitation, all moneys, liabilities due, owing or incurred under or pursuant to the facilities agreement, the debenture, the ancillary documents and/or any of the other finance documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 5 culley way maidenhead t/n BK111256, f/h 71 portlock road maidenhead t/n BK30684, 2 fielding road maidenhead t/n BK130387, for details of the further properties in england and the l/h property in scotland charged please refer to form M395, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery, see ch microfiche for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chase Manhattan International Limited
    ব্যবসায়
    • ১০ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ডিসে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জানু, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chemical Investment Bank Limitedas Security Agent (As Defined Therein)
    ব্যবসায়
    • ০৮ জানু, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ডিসে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জানু, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the british printing company LTD to the chargee under the terms of the restated facilities (as therein defined) and this deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Charged under the security documents (as defined) to which the company is a party. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Lenders (As Defined Therein)
    ব্যবসায়
    • ০৫ জানু, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ ডিসে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জানু, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from bucksmere limited now k/a bpcc LTD.to the chargee under the terms of a loan agreement dated 21 december 1988 and this charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (For full details - see form 395- ref M241). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Standard Chartered Bank(As Agent and Trustee for the Mezzanine Lenders)
    ব্যবসায়
    • ১৭ জানু, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৬ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ ডিসে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জানু, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from bucksmere limited now k/a bpcc LTD.to the chargee under the terms of a loan agreement dated 21 december 1988 and this charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (For full details - see form 395. ref M262). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.(As Agent and Trustee for the Banks and the Overdraft Bank)
    ব্যবসায়
    • ১৭ জানু, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২২ জানু, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জানু, ১৯৮৯
    অর্জিত হয়েছে ২০ জানু, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জানু, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from bpcc LTD to each of the mezzanine lenders under a loan agreement dated 21/12/88
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See doc M658C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Mezzanine Lenders
    ব্যবসায়
    • ০৯ জানু, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৬ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জানু, ১৯৮৯
    অর্জিত হয়েছে ২০ জানু, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জানু, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from bpcc LTD to each of the mezzanine lenders under a loan agreement dated 21/12/88 and from the company and/or all or any of the other companies named therein under the facilities agreement (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See doc M664C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Banks (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ০৯ জানু, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৬ জানু, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জানু, ১৯৮৯
    অর্জিত হয়েছে ০৫ জানু, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from bpcc LTD and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under a loan agreement dated 21ST december 1988 and the facilities agreement secured on property acquired by bpcc catalogues LTD on the 5TH january 1990.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See doc M400- ref M200C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent & Trustee for the Banks and the Overdraft Bank as Defined.
    ব্যবসায়
    • ২৪ জানু, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জানু, ১৯৮৯
    অর্জিত হয়েছে ০৫ জানু, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from bpcc LTD to the chargee under a loan agreement dated 21-12-88 secured on property acquired by bpcc catalogues limited on the 5-1-1990.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See doc M400- ref M207C for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Mezzanine Lenders
    ব্যবসায়
    • ২৪ জানু, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৬ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0