GIBB HOLDINGS LTD

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামGIBB HOLDINGS LTD
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02387714
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    GIBB HOLDINGS LTD এর উদ্দেশ্য কী?

    • হেড অফিসের কার্যক্রম (70100) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    GIBB HOLDINGS LTD কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Cottons Centre
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    United Kingdom
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    GIBB HOLDINGS LTD এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    GIBB LIMITED১৮ সেপ, ১৯৮৯১৮ সেপ, ১৯৮৯
    CHULSAVALE LIMITED২২ মে, ১৯৮৯২২ মে, ১৯৮৯

    GIBB HOLDINGS LTD এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে০১ অক্টো, ২০২১

    GIBB HOLDINGS LTD এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    ২১ আগ, ২০২৩ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Geoffrey Roberts-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ২১ আগ, ২০২৩ তারিখে সচিব হিসাবে Rhona Mary Holman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    1 পৃষ্ঠাDS01

    ২৯ জুন, ২০২৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 0.40412
    5 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    2 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    2 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ১০ ফেব, ২০২৩ তারিখে সচিব হিসাবে Rhona Mary Holman-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ১০ ফেব, ২০২৩ তারিখে সচিব হিসাবে Tejender Singh Chaudhary এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ২০ জানু, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ১৫ ডিসে, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Katherine Helen Kenny-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৫ ডিসে, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Hugh Donald Morrison এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ০১ অক্টো, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি

    24 পৃষ্ঠাAA

    ২০ জানু, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ০২ অক্টো, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    26 পৃষ্ঠাAA

    ১১ আগ, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Sally Miles-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১১ আগ, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Guy Douglas এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২০ জানু, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    26 পৃষ্ঠাAA

    ৩০ নভে, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jonathan R. Shattock এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩০ নভে, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Hugh Donald Morrison-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৭ ডিসে, ২০২০ তারিখে Mr Guy Douglas-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০২ নভে, ২০২০ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Jacobs Uk Limited এর বিবরণের পরিবর্তন

    2 পৃষ্ঠাPSC05

    GIBB HOLDINGS LTD এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    ROBERTS, Geoffrey
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    সচিব
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    312725290001
    KENNY, Katherine Helen
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    পরিচালক
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish216980410001
    MILES, Sally Linda Joyce
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    পরিচালক
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    EnglandBritish161125950001
    CHAUDHARY, Tejender Singh
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    সচিব
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    246698880001
    HOLMAN, Rhona Mary
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    সচিব
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    305629180001
    MARKLEY, William Clyde
    2105 Sunnybank Drive
    La Canada
    91011 Flintridge
    California
    United States Of America
    সচিব
    2105 Sunnybank Drive
    La Canada
    91011 Flintridge
    California
    United States Of America
    American57955380001
    NORRIS, Michael Timothy
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    সচিব
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    British52563600002
    UDOVIC, Michael Sean
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    সচিব
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    165335900001
    WARD, Sandra Lesley
    17 Clayfields
    HP10 8AT Tylers Green
    Bucks
    সচিব
    17 Clayfields
    HP10 8AT Tylers Green
    Bucks
    British89320390001
    WITHERS, Graham Reginald
    33 Ryhill Way
    Lower Earley
    RG6 4AZ Reading
    Berkshire
    সচিব
    33 Ryhill Way
    Lower Earley
    RG6 4AZ Reading
    Berkshire
    British1420080001
    BACK, Paul Adrian Auchmuty, Dr
    Parsonage Farm
    How Lane
    SL6 3JP White Waltham
    Berkshire
    পরিচালক
    Parsonage Farm
    How Lane
    SL6 3JP White Waltham
    Berkshire
    British22932520001
    BARBER, Walter Charles
    61 Riverside House
    Bear Wharf Fobney Street
    RG1 6BJ Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    61 Riverside House
    Bear Wharf Fobney Street
    RG1 6BJ Reading
    Berkshire
    American93663320001
    BOWCOCK, John Brown
    Lothlorien
    Crowsley Road
    RG9 3JU Shiplake
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Lothlorien
    Crowsley Road
    RG9 3JU Shiplake
    Oxfordshire
    British34950050001
    BRETTELL, Peter Donald
    Blorenge Cottage
    Holly Lane Ashampstead
    RG8 8RT Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    Blorenge Cottage
    Holly Lane Ashampstead
    RG8 8RT Reading
    Berkshire
    British34455550003
    BRICE, Geoffrey John
    3 Orwell Close
    Caversham
    RG4 7PU Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    3 Orwell Close
    Caversham
    RG4 7PU Reading
    Berkshire
    British7239880001
    COATES, Geoffrey Hamilton
    The Shealing
    Backsideans Wargrave-On-Thames
    RG10 8JP Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    The Shealing
    Backsideans Wargrave-On-Thames
    RG10 8JP Reading
    Berkshire
    British1420060001
    COLES, Bruce Charles
    703 Henley Fields Circle
    FOREIGN Duluth
    Georgia 30155
    Usa
    পরিচালক
    703 Henley Fields Circle
    FOREIGN Duluth
    Georgia 30155
    Usa
    American49990460001
    DANGER, James Ivan
    2694 Northbrook Drive
    Atlanta
    FOREIGN Georgia 30340
    Usa
    পরিচালক
    2694 Northbrook Drive
    Atlanta
    FOREIGN Georgia 30340
    Usa
    American43472160001
    DAWSON, James Grant Forbes
    Woodpeckers
    Pangbourne Hill
    RG8 8JS Pangbourne
    Berkshire
    পরিচালক
    Woodpeckers
    Pangbourne Hill
    RG8 8JS Pangbourne
    Berkshire
    British32689240001
    DOUGLAS, Guy
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    পরিচালক
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish258025190001
    DOYLE, John Conor
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandIrish78009780001
    DUFF, Robert Shepherd
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish165632810001
    ELLIS, David
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    পরিচালক
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United KingdomBritish206422550001
    FOOSHEE, Robert Brown
    9000 Etching Overlook Drive
    FOREIGN Duluth
    Georgia 30097
    Usa
    পরিচালক
    9000 Etching Overlook Drive
    FOREIGN Duluth
    Georgia 30097
    Usa
    American49990480001
    HENNESSEY, John Richard
    Folly Farm
    Barkham Road
    RG11 4BS Wokingham
    Berkshire
    পরিচালক
    Folly Farm
    Barkham Road
    RG11 4BS Wokingham
    Berkshire
    British22928530001
    IRVIN, Robert Anthony Michael
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish161055320001
    JONES, Graham Roger
    Coningsby 81 The Rise
    TN13 1RN Sevenoaks
    Kent
    পরিচালক
    Coningsby 81 The Rise
    TN13 1RN Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish42069750001
    MONTGOMERY, Michael Wayne
    Red Fox Cottage
    Old Bath Road Sonning
    RG4 0TA Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    Red Fox Cottage
    Old Bath Road Sonning
    RG4 0TA Reading
    Berkshire
    American32725930002
    MORRISON, Hugh Donald
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    পরিচালক
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish240150920001
    SEHGAL, Raghbir Kumar
    55 Cliffside Crossing
    Atlanta
    Georgia Ga 30338
    Usa
    পরিচালক
    55 Cliffside Crossing
    Atlanta
    Georgia Ga 30338
    Usa
    American32725940001
    SHATTOCK, Jonathan R.
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    পরিচালক
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish259549880001
    STANCOMBE, Christopher John
    8 Wellington Gardens
    Southend Bradfield
    RG7 6EJ Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    8 Wellington Gardens
    Southend Bradfield
    RG7 6EJ Reading
    Berkshire
    EnglandBritish33841950002
    STEINBRENNER, Frederick James
    5707 Brynwood Circle
    30101 Georgia
    Usa
    পরিচালক
    5707 Brynwood Circle
    30101 Georgia
    Usa
    American7239910004
    TAYLOR, Allyn Byram
    Mill Lane
    Cookham
    SL6 9QT Maidenhead
    Formosa Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Mill Lane
    Cookham
    SL6 9QT Maidenhead
    Formosa Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandUnited States124922150002
    WALKER, William Allen
    3345 Robinson Farms Court
    Marietta
    FOREIGN Atlanta
    Georgia Ga 30068
    Usa
    পরিচালক
    3345 Robinson Farms Court
    Marietta
    FOREIGN Atlanta
    Georgia Ga 30068
    Usa
    American15467690004

    GIBB HOLDINGS LTD এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Jacobs Uk Limited
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মLimited Company
    নিবন্ধিত দেশUnited Kingdom
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানEngland Companies Registry
    নিবন্ধন নম্বর02594504
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    GIBB HOLDINGS LTD এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Deed of rectification and supplemental charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ নভে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ নভে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    13% of the issued share capital of prointec sa being: 300,000 pesetas............................13 Common stock of pesetas,100,000 numbered 8-18 and 21 and 94; all stocks,shares,bonds,debentures,notes...etc..........all dividends/other income and all rights,benefits,money or property..................all repayments of principal on loan notes.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Suntrust Bank,Atlanta
    ব্যবসায়
    • ২২ নভে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ অক্টো, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ অক্টো, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over shares
    তৈরি করা হয়েছে ১১ অক্টো, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ অক্টো, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to suntrust bank,atlanta for itself and as agent and trustee on behalf of the lenders (as defined)to each lender in any currency and whether or not the lender in question shall have been a party to the original transaction except any money or liabilities due by any company as guarantor for the depositor
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The securities all dividends distributions interest and other income all accretions of a capital nature and all capital sums received. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Suntrust Bank Atlanta
    ব্যবসায়
    • ১৮ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    First charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ অক্টো, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ অক্টো, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities (i)of law companies group,inc.to trust company bank and other banks under a credit agreement dated 8 october 1993 (us$42,000,000 together with interest,charges and costs)(ii)of law companies group,inc.to trust company bank under a reimbursement agreement dated 8 october 1993 (all amounts due under letters of credit issued by trust company bank)(iii)of law companies group,inc.and sir alexander gibb & partners limited to barclays bank PLC under a facility letter dated 8 october 1993 (£16,900,000 together with interest charges and costs)(iv)of gibb limited to barclays bank PLC under a commercial mortgage facility letter dated 8 february 1990 (£495,900 together with interest charges and costs) and (v)the obligations of certain partnerships and companies defined as sir alexander gibb partnerships to barclays bank PLC (£2,000,000 together with interest,charges and costs)and amounts due under the indemnity contained in clause 15.3 of the first charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    2,217,800 shares of £1 each in sir alexander gibb & partners limited together with any substituted or additional shares or other securities and further including all allotments,accretions,offers,voting or other rights.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Trust Company Bankertain Other Banksas Collateral Agent and Trustee for Itself and C
    ব্যবসায়
    • ১৩ অক্টো, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ মার্চ, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মার্চ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Flat 5, 2 hyde park street, london W2. Title no. Ngl 617261.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ মার্চ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩১ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ আগ, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ আগ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    ব্যবসায়
    • ২৪ আগ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0