ASCRIBE LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামASCRIBE LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02394847
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ASCRIBE LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ব্যবসায়িক এবং গার্হস্থ্য সফ্টওয়্যার উন্নয়ন (62012) / তথ্য এবং যোগাযোগ

    ASCRIBE LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Pkf Gm, 3rd Floor
    One Park Row
    LS1 5HN Leeds
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ASCRIBE LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ASC COMPUTER SOFTWARE LIMITED১৪ জুন, ১৯৮৯১৪ জুন, ১৯৮৯

    ASCRIBE LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০২০

    ASCRIBE LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    16 পৃষ্ঠাLIQ13

    ১৫ সেপ, ২০২৩ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    18 পৃষ্ঠাLIQ03

    ১০ অক্টো, ২০২২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 0.01
    5 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Cancel; share prem a/c 23/08/2022
    RES13
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ০৩ অক্টো, ২০২২ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA England থেকে Pkf Gm, 3rd Floor One Park Row Leeds LS1 5HNপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    6 পৃষ্ঠাLIQ01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১৬ সেপ, ২০২২ তারিখে

    LRESSP

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Cancel share prem a/c 23/08/2022
    RES13
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    Mr Paul Stewart কে পরিচালক হিসাবে নিয়োগের জন্য দ্বিতীয় দাখিল

    3 পৃষ্ঠাRP04AP01

    ২০ জুল, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Paul Stewart-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ২৫ জুল, ২০২২Clarification A second filed AP01 was registered on 25/07/22

    ২০ জুল, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Andrew John Thorburn এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২০ জুল, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Suzanne Marie Foster এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৪ জুন, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    30 পৃষ্ঠাAA

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD04

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD04

    ১৪ জুন, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা 6 Airport West Lancaster Way Yeadon Leeds LS19 7ZA England থেকে Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    28 পৃষ্ঠাAA

    ASCRIBE LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BENSON, Christine
    One Park Row
    LS1 5HN Leeds
    Pkf Gm, 3rd Floor
    সচিব
    One Park Row
    LS1 5HN Leeds
    Pkf Gm, 3rd Floor
    239350110001
    SOUTHBY, Peter John
    One Park Row
    LS1 5HN Leeds
    Pkf Gm, 3rd Floor
    পরিচালক
    One Park Row
    LS1 5HN Leeds
    Pkf Gm, 3rd Floor
    EnglandBritish116859780002
    STEWART, Paul
    One Park Row
    LS1 5HN Leeds
    Pkf Gm, 3rd Floor
    পরিচালক
    One Park Row
    LS1 5HN Leeds
    Pkf Gm, 3rd Floor
    EnglandBritish262072580001
    FARBRIDGE, Caroline Louise
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    সচিব
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    193500130001
    JONES, Christopher Kenneth
    12 Cherry Tree Avenue
    WA13 0NS Lymm
    Cheshire
    সচিব
    12 Cherry Tree Avenue
    WA13 0NS Lymm
    Cheshire
    English29059120001
    LEE, Jeremy Stephen William
    10 Hodge Fold
    SK14 6BL Broadbottom
    Cheshire
    সচিব
    10 Hodge Fold
    SK14 6BL Broadbottom
    Cheshire
    British98814590001
    MOTTRAM, Mandy Joanne
    Constable Drive
    Marple Bridge
    SK6 5BG Stockport
    18
    Cheshire
    England
    সচিব
    Constable Drive
    Marple Bridge
    SK6 5BG Stockport
    18
    Cheshire
    England
    166860490001
    RUSCOE, Antony Myles
    21 Sycamore Close
    Endmoor
    LA8 0NY Kendal
    Cumbria
    সচিব
    21 Sycamore Close
    Endmoor
    LA8 0NY Kendal
    Cumbria
    British49371150003
    WAITE, Simon Nicholas
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    সচিব
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    213728810001
    BRADSHAW, Arthur Richard
    4 The Spinney
    Horrobin Lane Turton
    BL7 0JA Bolton
    Lancashire
    পরিচালক
    4 The Spinney
    Horrobin Lane Turton
    BL7 0JA Bolton
    Lancashire
    British5411670002
    CRITCHLOW, Anthony Stephen
    Grange Farm
    Grange Road Bromley Cross
    BL7 9AX Bolton
    পরিচালক
    Grange Farm
    Grange Road Bromley Cross
    BL7 9AX Bolton
    United KingdomBritish101716720002
    DICKSON, Christopher John
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    পরিচালক
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    EnglandBritish100748280003
    FOSTER, Suzanne Marie
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    পরিচালক
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    EnglandBritish262072440001
    GARRINGTON, Stephen John
    15 Chesterton Close
    Hunt End
    B97 5XS Redditch
    Worcestershire
    পরিচালক
    15 Chesterton Close
    Hunt End
    B97 5XS Redditch
    Worcestershire
    British45513680001
    HUGHES, David Michael
    Lea House
    Patshull Road, Albrighton
    WV7 3BH Wolverhampton
    পরিচালক
    Lea House
    Patshull Road, Albrighton
    WV7 3BH Wolverhampton
    EnglandBritish12292930002
    JOHNSON, Paul Thomas
    51 Glebe Lane
    ST20 0HG Gnosall
    Staffordshire
    পরিচালক
    51 Glebe Lane
    ST20 0HG Gnosall
    Staffordshire
    British74821110001
    JONES, Christopher Kenneth
    43 Moorland Drive Rise
    Haslingden
    BB4 6UA Rossendale
    Lancashire
    পরিচালক
    43 Moorland Drive Rise
    Haslingden
    BB4 6UA Rossendale
    Lancashire
    English29059120002
    KELLY, Mark William
    129 Regent Road
    BL6 4DX Bolton
    Lancashire
    পরিচালক
    129 Regent Road
    BL6 4DX Bolton
    Lancashire
    British79084160001
    LAWRENCE, Duane Stephen
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    পরিচালক
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    EnglandBritish,American195658640003
    LEE, Jeremy Stephen William
    10 Hodge Fold
    SK14 6BL Broadbottom
    Cheshire
    পরিচালক
    10 Hodge Fold
    SK14 6BL Broadbottom
    Cheshire
    United KingdomBritish98814590001
    MELLOR, Marcus Irving
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    পরিচালক
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    EnglandUnited Kingdom156959810001
    RUSCOE, Antony Myles
    21 Sycamore Close
    Endmoor
    LA8 0NY Kendal
    Cumbria
    পরিচালক
    21 Sycamore Close
    Endmoor
    LA8 0NY Kendal
    Cumbria
    UkBritish49371150003
    SALTER, Richard Leonard James
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    পরিচালক
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    EnglandBritish181746490001
    SPENCER, Christopher Michael Kennedy
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    পরিচালক
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    EnglandBritish4742550002
    STENTON, Raymond
    2 Old Hall Lane
    Worsley
    M28 2FG Manchester
    পরিচালক
    2 Old Hall Lane
    Worsley
    M28 2FG Manchester
    British97198410001
    TAMBLYN, Christina
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    পরিচালক
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    EnglandBritish191028210001
    TAYLOR, Ian Albert
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    পরিচালক
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    United KingdomBritish237425740001
    THORBURN, Andrew John
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    পরিচালক
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    United KingdomBritish124801800001
    TOWNEND, Nicholas Adam
    Ascribe House Branker Street
    Westhoughton
    BL5 3JD Bolton
    Lancashire
    পরিচালক
    Ascribe House Branker Street
    Westhoughton
    BL5 3JD Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish154577090001
    WILLIAMS, Jane
    163 Smithy Lane
    L40 8HJ Scarisbrick
    Lancashire
    পরিচালক
    163 Smithy Lane
    L40 8HJ Scarisbrick
    Lancashire
    British79289770001

    ASCRIBE LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    না
    আইনি ফর্মCompany Limited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর05204003
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তিটির কোনও ফার্মের কার্যক্রমের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করার অধিকার রয়েছে বা প্রকৃতপক্ষে প্রয়োগ করে, যা পরিচালিত আইন অনুসারে আইনী ব্যক্তি নয়; এবং সেই ফার্মের সদস্যরা (সেই ক্ষমতায়) সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    ASCRIBE LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Eci Ventures Nominees Limited
    ব্যবসায়
    • ০১ এপ্রি, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ অক্টো, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Clydesdale Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ এপ্রি, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ অক্টো, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A specific security deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The securities, the rights, all proceeds of any securities or rights and all documents of the title relating to any securities or rights see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yorkshire Bank (A Trading Name of Clydesdale Bank PLC)
    ব্যবসায়
    • ০১ এপ্রি, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ অক্টো, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A deed of mortgage of marketable securities
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All of the issued capital of asc computer software pty. LTD (abn 75 075 121 028) held by the mortgagor, which as at the date of the deed consists of 1,000 fully paid ordinary shares of $1.00 each see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    ব্যবসায়
    • ০১ এপ্রি, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ অক্টো, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মার্চ, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ মার্চ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জানু, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ জুন, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জুন, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ জুন, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জানু, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)

    ASCRIBE LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৬ সেপ, ২০২২ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১০ এপ্রি, ২০২৪ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    James Sleight
    3rd Floor One Park Row
    LS1 5HN Leeds
    অভ্যাসকারী
    3rd Floor One Park Row
    LS1 5HN Leeds

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0