EX HAMPS DEAC LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামEX HAMPS DEAC LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02396152
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    EX HAMPS DEAC LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    EX HAMPS DEAC LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Portland
    25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    West Sussex
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    EX HAMPS DEAC LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    DEACON INSURANCE SERVICES LIMITED১৬ জুন, ১৯৮৯১৬ জুন, ১৯৮৯

    EX HAMPS DEAC LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১১

    EX HAMPS DEAC LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    EX HAMPS DEAC LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    17 পৃষ্ঠা4.71

    ০৫ নভে, ২০১৪ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    12 পৃষ্ঠা4.68

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠা600

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন

    LRESSP

    পরিচালক হিসাবে Ian Sutherland এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    পরিচালক হিসাবে Ian Ronald Sutherland-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Ian Sutherland এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩১ ডিসে, ২০১২ থেকে ৩০ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত

    2 পৃষ্ঠাAA01

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩১ ডিসে, ২০১৩ থেকে ৩০ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত

    3 পৃষ্ঠাAA01

    পরিচালক হিসাবে Michael Ramsey এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed deacon insurance services LIMITED\certificate issued on 03/06/13
    2 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name০৩ জুন, ২০১৩

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ০১ মে, ২০১৩

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    পরিচালক হিসাবে Kevin Michael Withington-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ১১ মে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital৩১ মে, ২০১৩

    ৩১ মে, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 10,000
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে David Oliver এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Mr Michael Francis Ramsey-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ১১ মে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    ২১ নভে, ২০১১ তারিখে Ian Ronald Sutherland-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পরিচালক হিসাবে Ian Ronald Sutherland-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১১ মে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    EX HAMPS DEAC LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    YE, Christina Hong
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    সচিব
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    British133681410001
    WITHINGTON, Kevin Michael
    25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    Portland
    West Sussex
    পরিচালক
    25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    Portland
    West Sussex
    EnglandEnglish178721390001
    ATHERTON, Andrew James
    Beauchamp
    Westover Road Milford On Sea
    SO41 0PW Lymington
    Hampshire
    সচিব
    Beauchamp
    Westover Road Milford On Sea
    SO41 0PW Lymington
    Hampshire
    British148270340001
    BALDWIN, Nicholas Charles
    80 Pilford Heath Road
    BH21 2ND Wimborne
    Dorset
    সচিব
    80 Pilford Heath Road
    BH21 2ND Wimborne
    Dorset
    British57752860001
    BELLIS, Juliet Mary Susan
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    সচিব
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    British69991160002
    DAVIS, Nigel Peter
    66 Redway Drive
    TW2 7NW Twickenham
    Middlesex
    সচিব
    66 Redway Drive
    TW2 7NW Twickenham
    Middlesex
    British93673010001
    DUCKER, Elaine
    9 Whincroft Drive
    Ferndown
    BH22 9LH Bournemouth
    Dorset
    সচিব
    9 Whincroft Drive
    Ferndown
    BH22 9LH Bournemouth
    Dorset
    British12261980001
    JOHNSON, Robin Simon
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    সচিব
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    British11498320001
    PALMER, Jeffrey Edward
    22 Catalina Close
    BH23 4JG Christchurch
    Dorset
    সচিব
    22 Catalina Close
    BH23 4JG Christchurch
    Dorset
    British82018950001
    ZEALE, Nadine Catherine
    12 The Brewery The Maltings
    Church Street
    TW18 4XH Staines
    Middlesex
    সচিব
    12 The Brewery The Maltings
    Church Street
    TW18 4XH Staines
    Middlesex
    British58435360001
    ZEALE, Richard John Alexander
    The Clive
    Croft Road,Neacroft
    BH23 8JS Christchurch
    Dorset
    সচিব
    The Clive
    Croft Road,Neacroft
    BH23 8JS Christchurch
    Dorset
    British22396670002
    ATHERTON, Andrew James
    Beauchamp
    Westover Road Milford On Sea
    SO41 0PW Lymington
    Hampshire
    পরিচালক
    Beauchamp
    Westover Road Milford On Sea
    SO41 0PW Lymington
    Hampshire
    United KingdomBritish148270340001
    BALDWIN, Nicholas Charles
    80 Pilford Heath Road
    BH21 2ND Wimborne
    Dorset
    পরিচালক
    80 Pilford Heath Road
    BH21 2ND Wimborne
    Dorset
    EnglandBritish57752860001
    BOYD, Iain Grant
    1 Highland View Close
    BH21 2QX Wimborne
    Dorset
    পরিচালক
    1 Highland View Close
    BH21 2QX Wimborne
    Dorset
    British51260620002
    CRAN, John Andrew George
    19 Countess Gardens
    BH7 7RR Bournemouth
    Dorset
    পরিচালক
    19 Countess Gardens
    BH7 7RR Bournemouth
    Dorset
    United KingdomBritish61456650002
    DAVIS, Nigel Peter
    6 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    পরিচালক
    6 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    EnglandBritish93673010002
    DAVIS, Paul Malcolm
    3 Church Close
    WD7 8BJ Radlett
    Hertfordshire
    পরিচালক
    3 Church Close
    WD7 8BJ Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish30526830004
    DUCKER, David George Bartholomew
    43 Groenhof Wezembeek
    Oppen
    FOREIGN 1970 Brussels
    Belgium
    পরিচালক
    43 Groenhof Wezembeek
    Oppen
    FOREIGN 1970 Brussels
    Belgium
    British45548190004
    DUCKER, David George Bartholomew
    9 Whincroft Drive
    BH22 9LH Ferndon
    Bournemouth
    পরিচালক
    9 Whincroft Drive
    BH22 9LH Ferndon
    Bournemouth
    British45548190002
    GOODING, Jonathan Michael
    13 Albany Street
    NW1 4DX London
    পরিচালক
    13 Albany Street
    NW1 4DX London
    United KingdomBritish16684130002
    JENKINSON, Andrew Timothy
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    United KingdomBritish74069620002
    LIPMAN, Larry Glenn
    12 Park St James
    Prince Albert Road
    NW8 7LE St Johns Wood
    পরিচালক
    12 Park St James
    Prince Albert Road
    NW8 7LE St Johns Wood
    EnglandBritish62622410007
    OLIVER, David Martin
    13 Kirklee Circus
    G12 0TW Glasgow
    Lanarkshire
    পরিচালক
    13 Kirklee Circus
    G12 0TW Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish115764650001
    PALMER, Jeffrey Edward
    22 Catalina Close
    BH23 4JG Christchurch
    Dorset
    পরিচালক
    22 Catalina Close
    BH23 4JG Christchurch
    Dorset
    EnglandBritish82018950001
    PEJNOVIC, Tomislav
    18 B Winchester Road
    GU32 3BL Petersfield
    Hampshire
    পরিচালক
    18 B Winchester Road
    GU32 3BL Petersfield
    Hampshire
    United KingdomBritish204966490001
    PLUMB, Robert Henry Charles
    Uplands Cottage
    Whitchurch On Thames
    RG8 7HH Reading
    পরিচালক
    Uplands Cottage
    Whitchurch On Thames
    RG8 7HH Reading
    EnglandBritish20686100001
    PURKISS, Julie
    1 Headinglea
    5 The Avenue
    BH13 6AA Poole
    Dorset
    পরিচালক
    1 Headinglea
    5 The Avenue
    BH13 6AA Poole
    Dorset
    British99182850001
    RAMSEY, Michael Francis
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    পরিচালক
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United KingdomBritish80310620002
    SMITH, James Robert Drummond
    11 Wellesley Road
    CR0 2NW Croydon
    Caley Limited Phoenix House
    Surrey
    পরিচালক
    11 Wellesley Road
    CR0 2NW Croydon
    Caley Limited Phoenix House
    Surrey
    SpainBritish130443150001
    SUTHERLAND, Ian Ronald
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    United KingdomBritish163582690001
    SUTHERLAND, Ian Ronald
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Bedford Park
    CR0 2AP Croydon
    Third Floor Sunley House
    United Kingdom
    United KingdomBritish189660790001
    WILLIAMS, Neil Vaughan
    1 Richmond Place
    TN2 5JZ Tunbridge Wells
    Kent
    পরিচালক
    1 Richmond Place
    TN2 5JZ Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish71561050001
    ZEALE, Richard John Alexander
    The Whittle
    24 Chewton Farm Road
    BH23 5QN Highcliffe
    Dorset
    পরিচালক
    The Whittle
    24 Chewton Farm Road
    BH23 5QN Highcliffe
    Dorset
    British22396670003

    EX HAMPS DEAC LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Supplemental charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ জানু, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জানু, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fifth floor offices, oxford house, oxford road, bournemouth t/no. DT64769.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (Formerly Known as the Governor and Company of the Bank of Scotland)(the Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০৮ জানু, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ জুন, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Group debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুল, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ আগ, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Finance Parties(The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০৩ আগ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ জুন, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC, as Security Trustee for the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ১৪ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of accession relating to a composite guarantee and debenture dated 9TH november 1999 issued by the company
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All indebtedness, liabilities and obligations due or to become due to the chargee in any manner whatsoever by any group company pursuant to the guarantee or otherwise
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জানু, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies obligations and liabilities owing or incurred from the company to the chargee under or pursuant to the facilities agreement of even date and/or the debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bhf-Bank Ag
    ব্যবসায়
    • ০৫ জানু, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ সেপ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ সেপ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC,
    ব্যবসায়
    • ২০ সেপ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    EX HAMPS DEAC LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    2
    তারিখপ্রকার
    ০৪ ফেব, ২০১৬ভেঙে গেছে
    ০৬ নভে, ২০১৩ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    John Ariel
    Portland 25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    West Sussex
    অভ্যাসকারী
    Portland 25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    West Sussex
    Matthew Richard Meadley Wild
    3rd Floor One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    অভ্যাসকারী
    3rd Floor One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0