NITRIDING SERVICES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামNITRIDING SERVICES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02406009
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    NITRIDING SERVICES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7499) /

    NITRIDING SERVICES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    39-43 Bilton Way
    Luton
    LU1 1UU Bedfordshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    NITRIDING SERVICES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    THERMO CHEMICAL TREATMENTS LIMITED০৭ নভে, ১৯৮৯০৭ নভে, ১৯৮৯
    INGLEBY (429) LIMITED১৯ জুল, ১৯৮৯১৯ জুল, ১৯৮৯

    NITRIDING SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৯

    NITRIDING SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ জানু, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৪ জানু, ২০১১

    ২৪ জানু, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 544,400.02
    SH01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ জানু, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    সচিব হিসাবে Miss Denise Osborn-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে Nicholas Duncalf এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Nicholas Duncalf এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Stephen Dell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ১৮ মার্চ, ২০২১Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 18/03/2021 under section 1088 of the Companies Act 2006

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    8 পৃষ্ঠা363s

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৪ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৩ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    NITRIDING SERVICES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    OSBORN, Denise
    39-43 Bilton Way
    Luton
    LU1 1UU Bedfordshire
    সচিব
    39-43 Bilton Way
    Luton
    LU1 1UU Bedfordshire
    146124880001
    JAEGER, Oliver
    Mettmann
    Germany
    পরিচালক
    Mettmann
    Germany
    GermanyGerman138189510001
    ASHTON, David John
    Oak Cottage
    27 Church Road, Lilleshall
    TF10 9HE Newport
    Salop
    সচিব
    Oak Cottage
    27 Church Road, Lilleshall
    TF10 9HE Newport
    Salop
    British24459630003
    DUNCALF, Nicholas John
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    সচিব
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British148208420001
    KNIGHTS, John Ivan
    The Haven 4 Berberry Drive
    MK45 5ER Flitton
    Bedfordshire
    সচিব
    The Haven 4 Berberry Drive
    MK45 5ER Flitton
    Bedfordshire
    British126545670001
    POLLAK, David Arthur
    40 The Gardens
    WD17 3DW Watford
    Hertfordshire
    সচিব
    40 The Gardens
    WD17 3DW Watford
    Hertfordshire
    British64234590001
    ASHTON, David John
    Oak Cottage
    27 Church Road, Lilleshall
    TF10 9HE Newport
    Salop
    পরিচালক
    Oak Cottage
    27 Church Road, Lilleshall
    TF10 9HE Newport
    Salop
    EnglandBritish24459630003
    BACON, Nicholas Andrew William
    Shaftesbury House Clover Hill
    Old Warwick Road, Lapworth
    B94 6JY Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    Shaftesbury House Clover Hill
    Old Warwick Road, Lapworth
    B94 6JY Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish159081540001
    BAUMANN, Christopher John
    31 Old Slade Lane
    SL0 9DY Richings Park
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    31 Old Slade Lane
    SL0 9DY Richings Park
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish102220130001
    BUSTER, Richard Geoffrey
    58 Mount Road
    Tettenhall Wood
    WV6 8HQ Wolverhampton
    West Midlands
    পরিচালক
    58 Mount Road
    Tettenhall Wood
    WV6 8HQ Wolverhampton
    West Midlands
    EnglandBritish4325580001
    DELL, Stephen John
    55 Bucklow Gardens
    WA13 9RN Lymm
    Cheshire
    পরিচালক
    55 Bucklow Gardens
    WA13 9RN Lymm
    Cheshire
    British124021740001
    DUNCALF, Nicholas John
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    পরিচালক
    5 Sandon Avenue
    Westlands
    ST5 3QB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishBritish148208420001
    EALES, Darryl Charles
    7 Sycamore Drive
    Hollywood
    B47 5QX Birmingham
    West Midlands
    পরিচালক
    7 Sycamore Drive
    Hollywood
    B47 5QX Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritish2886080001
    HEAP, William John
    Alameda Keepers Lane
    Codsall
    WV8 2DP Wolverhampton
    West Midlands
    পরিচালক
    Alameda Keepers Lane
    Codsall
    WV8 2DP Wolverhampton
    West Midlands
    British24459640001
    KNIGHTS, John Ivan
    The Haven 4 Berberry Drive
    MK45 5ER Flitton
    Bedfordshire
    পরিচালক
    The Haven 4 Berberry Drive
    MK45 5ER Flitton
    Bedfordshire
    British126545670001
    LEEK, Peter William
    Tintagel 119 Broad Lane
    WV3 9BP Wolverhampton
    West Midlands
    পরিচালক
    Tintagel 119 Broad Lane
    WV3 9BP Wolverhampton
    West Midlands
    British10939100001
    LEEKE, Graham Maurice
    The Grove
    Tachbrook Mallory
    CV33 9QE Leamington Spa
    Warwickshire
    পরিচালক
    The Grove
    Tachbrook Mallory
    CV33 9QE Leamington Spa
    Warwickshire
    British29510450001
    ROBINSON, Kevin
    34 Winster Avenue
    Dorridge
    B93 8ST Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    34 Winster Avenue
    Dorridge
    B93 8ST Solihull
    West Midlands
    British61267640001
    SHARP, Keith
    Harewood House
    4 Spa Crescent
    TF5 0DH Admaston
    Shropshire
    পরিচালক
    Harewood House
    4 Spa Crescent
    TF5 0DH Admaston
    Shropshire
    EnglandBritish77395770001
    STAINES, Anthony Martin, Doctor
    10 Carmichael Close
    WS14 9YW Lichfield
    Staffordshire
    পরিচালক
    10 Carmichael Close
    WS14 9YW Lichfield
    Staffordshire
    British57218330001

    NITRIDING SERVICES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ ফেব, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    ব্যবসায়
    • ২৭ ফেব, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of rental deposit
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ নভে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ নভে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £40,000 together with interest thereon due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deposit of £40,000.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lilden Properties Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ অক্টো, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ সেপ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ অক্টো, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 15 february 1994 or under the chattel mortgage
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Nitrex gas nitriding system with serial no.be-5078 including various constituant parts. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ জানু, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ জানু, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Factory and land at hortonwood 40 telford shropshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Development Capital Limited
    ব্যবসায়
    • ৩০ জানু, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৮ ফেব, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ ডিসে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ ডিসে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The items as set out on the attached schedule (see form 395 for full details) the mortgage contains a covenant not to sell, transfer demise, let on hire or otherwise part with possession of the goods comprised in the mortgage charge, pledge lien or other encumbrance to arise in said goods.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ১২ ডিসে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৯ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ ডিসে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ ডিসে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and buildings comprising three acres on thereabouts at hortonwood, telford shropshire. The legal charge contains a covenant by the company not to sell encumber or otherwise deal with the equity of redemption in the property without the previous consent in writing of the chargee.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ১২ ডিসে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২১ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২২ নভে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ নভে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage the f/h property known as factory and land at hortonwood 40, telford shropshire goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ নভে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ মার্চ, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    78400 all monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of the chargee.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See form 395 document M539 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • John Townleyas Trustees for the Tct Pension Fund
    • Ann Douglas
    • Richard Geoffrey Buster
    • David John Ashton
    ব্যবসায়
    • ০৪ এপ্রি, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৮ ফেব, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ মার্চ, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ মার্চ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rights benefits, title and interest in and to a contract dated 19/3/90 and an agreement dated 19/3/90 in the works to be carried out at hortonwood 40 telford shropshire the company's rights, title and interest (if any) in hortonwood 40 telford shropshire described in an agreement dated 19/3/90. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ মার্চ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Single debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ মার্চ, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ মার্চ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ মার্চ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Single debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ মার্চ, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ মার্চ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Development Capital Limited
    ব্যবসায়
    • ২৩ মার্চ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৮ ফেব, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0