WINDELECTRIC LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামWINDELECTRIC LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02407377
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    WINDELECTRIC LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    WINDELECTRIC LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    WINDELECTRIC LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১০

    WINDELECTRIC LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ১৭ জুল, ২০১২ তারিখে Juliet Sarah Loveday Davenport-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৬ এপ্রি, ২০১২ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Nigel Tranah-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    ১৬ এপ্রি, ২০১২ তারিখে সচিব হিসাবে Angela Newman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৫ মার্চ, ২০১২

    ০৫ মার্চ, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 14,875
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    23 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে John Sellers এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাCAP-SS

    legacy

    3 পৃষ্ঠাSH20

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    সচিব হিসাবে Miss Angela Newman-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে Mark Hopkins এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    23 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    ১১ মার্চ, ২০১০ তারিখে Jonathan George Fairchild-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ০১ জানু, ২০১০ তারিখে Mr Peter Dixon Edwards-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ জানু, ২০১০ তারিখে Juliet Sarah Loveday Davenport-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    সচিব হিসাবে Mr Mark Hopkins-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে Jonathan Fairchild এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    22 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    WINDELECTRIC LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    TRANAH, Nigel
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    সচিব
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    168397380001
    DAVENPORT, Juliet Sarah Lovedy
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    পরিচালক
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    United KingdomBritish70686370003
    EDWARDS, Martin John
    The Bungalow
    Deli
    PL33 9BZ Delabole
    Cornwall
    পরিচালক
    The Bungalow
    Deli
    PL33 9BZ Delabole
    Cornwall
    EnglandBritish81829090001
    EDWARDS, Peter Dixon
    Deli
    PL33 9BZ Delabole
    N Cornwall
    পরিচালক
    Deli
    PL33 9BZ Delabole
    N Cornwall
    United KingdomBritish6723810001
    EDWARDS, Jeremy Paul
    Kempson House
    PO BOX 570,Camomile Street
    EC3A 7AN London
    সচিব
    Kempson House
    PO BOX 570,Camomile Street
    EC3A 7AN London
    British27850190002
    FAIRCHILD, Jonathan George
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    সচিব
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    British91228100003
    HOPKINS, Mark
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    সচিব
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    149634170001
    NEWMAN, Angela
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    সচিব
    Monkton Reach
    Monkton Hill
    SN15 1EE Chippenham
    Wiltshire
    155558130001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    FISK, Nicholas John Spencer
    10 Edwards Meadow
    SN8 1UD Marlborough
    Wiltshire
    পরিচালক
    10 Edwards Meadow
    SN8 1UD Marlborough
    Wiltshire
    British36028930001
    LOPEZ-CACICEDO, Carlos, Dr
    362 Marlborough Road
    SN3 1NP Swindon
    পরিচালক
    362 Marlborough Road
    SN3 1NP Swindon
    Spanish14105600002
    MASOOD, Tariq
    22 Ashgrove Avenue
    Ashley Down
    BS7 9LJ Bristol
    পরিচালক
    22 Ashgrove Avenue
    Ashley Down
    BS7 9LJ Bristol
    United KingdomBritish46049660002
    MASOOD, Tariq
    46 Sherbourne Avenue
    Bradley Stoke
    BS12 8BB Bristol
    Avon
    পরিচালক
    46 Sherbourne Avenue
    Bradley Stoke
    BS12 8BB Bristol
    Avon
    British46049660001
    MASTERMAN, Richard Thomas
    Thuborough House
    Sutcombe
    EX22 7QE Holsworthy
    Devon
    পরিচালক
    Thuborough House
    Sutcombe
    EX22 7QE Holsworthy
    Devon
    British3437250001
    SEED, John Junior
    Highfield House North Road
    BA2 6HW Bath
    Bath & North East Somerset
    পরিচালক
    Highfield House North Road
    BA2 6HW Bath
    Bath & North East Somerset
    British8670120001
    SELLERS, John Ernest
    Rodway Hill Manor
    Manor Road Mangotsfield
    BS16 9LG Bristol
    পরিচালক
    Rodway Hill Manor
    Manor Road Mangotsfield
    BS16 9LG Bristol
    United KingdomBritish47428650001
    SWARBRICK, Gerard Joseph
    39 Upper Cranbrook Road
    Westbury Park
    BS6 7UR Bristol
    পরিচালক
    39 Upper Cranbrook Road
    Westbury Park
    BS6 7UR Bristol
    EnglandBritish27850210001
    SWINDELLS, Brian James
    7 Hollymead Lane
    Stoke Bishop
    BS9 1LN Bristol
    পরিচালক
    7 Hollymead Lane
    Stoke Bishop
    BS9 1LN Bristol
    British32426200002
    SAXON FINANCE CORPORATION LIMITED
    Thuborough House
    Sutcombe
    EX22 7QE Holsworthy
    Devon
    কর্পোরেট পরিচালক
    Thuborough House
    Sutcombe
    EX22 7QE Holsworthy
    Devon
    59178080001

    WINDELECTRIC LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Performance guarantee and warranty guarantee assignment
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ নভে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ নভে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 4/11/91 and security documents issued pursuant thereto
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the companys rights title and interest in and to a performance guarantee dated 12/11/91.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Natwest Investment Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ২২ নভে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ নভে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Contract consultant's appointment and warranty and maintenance agreement charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ নভে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ নভে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from thecompany to the chargee under the terms of the facility letter dated 4TH NOVEMBER1991 and this deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the benefit of the contract agreement,the agreement,andthe warranty and maintenance agreement all dated 19TH july 1991 see form 395 ref M792C for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Natwest Investment Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ২০ নভে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ নভে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Contract charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ নভে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ নভে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter of even date and the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the benefit of an agreement dated 9/8/91.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Natwest Investment Banl Limited
    ব্যবসায়
    • ১৫ নভে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ নভে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over deposit account
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ নভে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ নভে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's right, title and interest-bearing deposit account number 66457901 at natwest investment bank limited designated cnw re: windelectric limited. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Natwest Investment Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ নভে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ সেপ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over power purchase agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ নভে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ নভে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to natwest investment bank limited or to any receiver appointed by the bank under the terms of the facility letter and/or mortgage debenture, both of even date, and/or this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All sums payable by non-fossil purchasing agency limited to the company under the power purchase agreement dated 12TH september 1990 and made beyween the company (1) non-fossil purchasing agency limited (2) and south western electricity PLC (3).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Natwest Investment Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ নভে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ নভে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ নভে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ নভে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage all those areas of leasehold land and premises at deli farm development delabole cornwall and/or the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Natwest Investment Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ নভে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ সেপ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0