M1 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামM1 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02407947
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    M1 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ভবন নির্মাণ প্রকল্প উন্নয়ন (41100) / নির্মাণ

    M1 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    M1 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    KILNGROVE LIMITED২৫ জুল, ১৯৮৯২৫ জুল, ১৯৮৯

    M1 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৫

    M1 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    9 পৃষ্ঠাLIQ13

    ২৯ মার্চ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Colin Barry Wagman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৯ মার্চ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Paul Jonathan Goswell-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৮ জুন, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 40 Queen Anne Street London W1G 9EL থেকে 26-28 Bedford Row London WC1R 4HEপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    5 পৃষ্ঠাLIQ01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১২ মে, ২০১৭ তারিখে

    LRESSP

    সমিতির এবং সংবিধির নথি

    9 পৃষ্ঠাMA

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES01

    ০৫ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Alexander Wilson Lamont এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৫ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে James Anthony Piper এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৫ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Paul Jonathan Goswell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৫ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Michael George Cohen এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩১ অক্টো, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    চার্জ 46 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 45 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 47 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    ১৭ নভে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Colin Barry Wagman-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ অক্টো, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৪ নভে, ২০১৫

    ২৪ নভে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ ডিসে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr James Anthony Piper-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩১ ডিসে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Michael George Cohen-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩১ ডিসে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Edward Robert William Moody এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    M1 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    GOSWELL, Paul Jonathan
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector202597650001
    EZEKIEL, Ivan Howard
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    সচিব
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    BritishDirector56155670004
    KLEINER, Richard Howard
    26 Atwood Avenue
    Kew
    TW9 4HG Richmond
    Surrey
    সচিব
    26 Atwood Avenue
    Kew
    TW9 4HG Richmond
    Surrey
    British29866240002
    SHARP, Graham William
    34 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    সচিব
    34 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    British13331010001
    YEWMAN, Steven John
    114 Durham Road
    BR2 0SR Bromley
    Kent
    সচিব
    114 Durham Road
    BR2 0SR Bromley
    Kent
    British45742320001
    COHEN, Michael George
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    England
    পরিচালক
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    England
    EnglandBritishChartered Accountant153509790001
    COSTER, Paul Antony
    Garth Steading
    Walpole Avenue
    CR5 3PN Chipstead
    Surrey
    পরিচালক
    Garth Steading
    Walpole Avenue
    CR5 3PN Chipstead
    Surrey
    BritishCompany Director35406400003
    EZEKIEL, Ivan Howard
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director56155670004
    GARNHAM, Timothy Claude
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector66502160002
    GARRARD, David Eardley, Sir
    29 Orchard Court
    Portman Square
    W1H 9PA London
    পরিচালক
    29 Orchard Court
    Portman Square
    W1H 9PA London
    EnglandBritishCompany Director76373440001
    GOSWELL, Paul Jonathan
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    England
    পরিচালক
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    England
    United KingdomBritishChartered Surveyor60475780003
    HASAN, Salmaan
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector106868320001
    LAMONT, Alexander Wilson
    New Burlington Street
    W1S 3BE London
    6th Floor, 10
    England
    পরিচালক
    New Burlington Street
    W1S 3BE London
    6th Floor, 10
    England
    EnglandBritishDirector158518680001
    MOODY, Edward Robert William
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Great BritainBritishDirector62122950001
    PIPER, James Anthony
    New Burlington Street
    W1S 3BE London
    Ares Management, 10
    England
    পরিচালক
    New Burlington Street
    W1S 3BE London
    Ares Management, 10
    England
    EnglandBritishManaging Director, Real Estate Investment163685440001
    ROSENFELD, Andrew Ian
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    পরিচালক
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    SwitzerlandBritishCompany Director118467060001
    SHARP, Graham William
    34 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    পরিচালক
    34 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    BritishCompany Director13331010001
    WAGMAN, Colin Barry
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor, Lansdowne House
    England
    পরিচালক
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor, Lansdowne House
    England
    EnglandBritishChartered Accountant189915990001

    M1 LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Minerva Property Holdings Limited
    Queen Anne Street
    W1G 9EL London
    40
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Queen Anne Street
    W1G 9EL London
    40
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland And Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানRegister Of Companies England And Wales
    নিবন্ধন নম্বর03358076
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    M1 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Account pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ নভে, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ নভে, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the pledgees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Rights, title and interest arising from or in relation to all of its bank accounts being;. Rent account, hsh nordbank ag, account no. 1200015667, bank code; hshndehh;. Category a fit out works account (formerly called the 'sale proceeds account'), hsh nordbank ag, account no. 1200015673, bank code; hshndehh. And all rights and claims arising from all future bank accounts of the pledgor as soon as they come into existence. See image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Landesbank Berlin Ag (The "Original Lender" or "Original Pledgee") and Hsh Nordbank Ag (the "Original Lender", "Hedge Counterparty", "Agent" or "Original Pledgee") (the "Original Pledgees") and the "Original Lenders")
    ব্যবসায়
    • ১৬ নভে, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০২ ফেব, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জানু, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জানু, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H land being st botolph's, 138-139 houndsditch, london and 2 white kennett street, london by way of fixed security its rights and interest in any income, the rent, the sale proceeds, see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch
    ব্যবসায়
    • ২০ জানু, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০২ ফেব, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ ফেব, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ ফেব, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    For details of various properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch as Agent and Security Trustee for the Beneficiaries (The "Agent")
    ব্যবসায়
    • ০৯ ফেব, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ ফেব, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জুল, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ আগ, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsh Nordbank Ag London Branch as Agent and Security Trustee for the Beneficiaries
    ব্যবসায়
    • ০৪ আগ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ মে, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Agreement relating to community benefits payments
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ নভে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £470,000.00 due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Barclays bank PLC,account no.60819220,charged under clauses 9 and 10 of the agreement.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London
    ব্যবসায়
    • ২৯ নভে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ ডিসে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১১ মে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All or any of the present or future or actual or contingent obligations or liabilities of the obligors (as defined) to the chargee or the beneficiaries (as defined) under any finance document (as defined) and all monies payable by the chargor under the debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H st botolphs house houndsditch london EC3. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bhf-Bank Ag (The "Agent") as Trustee for Itself and the Beneficiaries
    ব্যবসায়
    • ১৭ মে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ মে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Bank accounts charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ ডিসে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ডিসে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan facility agreement and/or in connection with the facility thereby granted and/or under the charge or any other security document
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies standing to the credit of the bank accounts and all entitlements to interest and other rights and benefits accruing to or arising in connection with such monies. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Deutsche Pfandbrief-Und Hypothekenbank Ag
    ব্যবসায়
    • ১৭ ডিসে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ ফেব, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ ডিসে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ডিসে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan facility agreement and/or in connection with the facility thereby granted and/or under the mortgage debenture or any of the other security documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Deutsche Pfandbrief-Und Hypothekenbank Ag
    ব্যবসায়
    • ১৭ ডিসে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ ফেব, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or helios property investments limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Leasehold eastgate house (formerly derwent house), nottingham road, derby title number DY256030. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ আগ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or helios property investments limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Freehold kingsway house, hatton gardens, liverpool title number MS303117. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ আগ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or helios property investments limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Freehold tyne bridge tower on the junction of church street and cannon street, gateshead title number TY154486. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ আগ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Freehold the unicentre preston and part of the eastern car park situated at lords walk and derby street preston and the leasehold property comprising the western car park and part of the eastern car park both situated at lords walk and derby street preston title numbers LA243792,LA386560,LA733688,LA219132,LA386923. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ আগ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ আগ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 25 february 1998 and
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and whole the subjects and others registered in the land register of scotland under t/no.lan 115508;together with (one) the whole buildings and others erected thereon;(two) the whole rights common,mutual and others otherwise effeiring thereto;(three) the whole fittings and fixtures present and future therein and thereon;(four) the proprietor's whole right,title and interest,present and future,therein and thereto.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ আগ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জুল, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ জুল, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or minerva PLC to the chargee under the terms of the finance documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h and l/h property k/a the unicentre lords walk preston lancashire together with adjacent car parking areas f/h t/no's:- LA243792, LA219132 and LA386560 l/ titles LA733688 LA386923. F/h property k/a tyne bridge tower gateshead tyne and wear t/no:-TY154486 f/h property k/a kinsway house hatton garden liverpool MS303117 l/h property k/a eastgate house 10 nottingham road derby t/no's:-DY256030. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bhf-Bank Ag
    ব্যবসায়
    • ৩১ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    • ২২ আগ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignation of rents
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জুল, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ জুল, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of leases dated 28/3/96 & 29/3/96 as varied supplemented and/or amended
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rents due future & present in terms of the lease dated 28TH &29TH march 96. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hf-Bank Ag
    ব্যবসায়
    • ২৬ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 23RD july 1996 and
    তৈরি করা হয়েছে ১১ জুল, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জুল, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement in respect of a loan facility of £78,750,000 dated 19TH july 1996 as defined in the debenture also dated 19TH july 1996
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Subjects k/a atholl house east kilbride scotland t/no LAN115508.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bhf - Bank Ag
    ব্যবসায়
    • ২৭ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 2ND april 1996
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ মার্চ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and obligations due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a debenture dated 8TH april 1994 as may be amended supplemented or varied
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Area or piece of ground extending to 2.83 acres or thereby lying on or towards the south side of whitemoss avenue east kilbride. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chemical Bank as Security Agent and Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ১০ এপ্রি, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ আগ, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 2ND april 1996
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ মার্চ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and obligations due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a debenture dated 19TH december 1989 and an agreement dated 19TH december 1989 as may be amended or supplemented
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Area or piece of ground extending to 2.83 acres or thereby lying on or towards the south side of whitemoss avenue east kilbride and all buildings.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chemical Bank
    ব্যবসায়
    • ১০ এপ্রি, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ অক্টো, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 2ND april 1996
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ মার্চ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and obligations due or to become from the company to the chargee pursuant to the terms of a debenture dated 8TH april 1994 as may be amended or supplemented
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Area or piece of ground extending to 2.83 acres lying on or towards the south side of whitemoss avenue east kilbride and with the buildings and others erected thereon and k/a atholl house east kilbride.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chemical Bank as Security Agent and Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ১০ এপ্রি, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ অক্টো, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ অক্টো, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to as the case may be the loan agreement the interest rate hedging agreements and any other security document (as defined) to which the borrower is a party
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title and interest in and to the contract and the bond, the contract being the construction contract dated 12 september 1995 for the development being the refurbishment work to offices on the ground floor, part second floor, third floor and fourth floor at unicentre lords walk preston lancashire and the bond being a performance bond dated 6 october 1995. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chemical Banks (As Defined) and Any of Themas Trustee for and on Behalf of the Beneficiarie
    ব্যবসায়
    • ১৮ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ অক্টো, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ অক্টো, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to as the case may be the loan agreement the interest rate hedging agreements and any other security document (as defined) to which the borrower is a party
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title and interest in and to the contract and the bond; the contract being the construction contract dated 12 september 1985 for the development being the refurbishment work to offices on the 5TH and 6TH floor at unicentre lords walk preston lancashire and the bond being a performance bond dated 6 october 1995. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chemical Banks (As Defined) and Any of Themas Trustee for and on Behalf of the Beneficiarie
    ব্যবসায়
    • ১৮ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ অক্টো, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security presented for registration in scotland
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Area of ground in the parish of east kilbride & county of lanark lying on the west side of avondale ave east kilbride together with office building k/a atholl house east kilbride t/no lan 61860. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chemical Bank (As Security Agent and Trustee for and on Behalf of the Beneficiaries)
    ব্যবসায়
    • ২৭ এপ্রি, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security presented for registration in scotland
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Bridge house 18-20 bridge street 27 bank street & 21/23 church street inverness.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chemical Bank (As Security Agent and Trustee for and on Behalf of the Beneficiaries)
    ব্যবসায়
    • ২৭ এপ্রি, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ জুল, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security presented for registration in scotland
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plot or area of ground at herschell street anniesland glasgow together with buildings erected thereon t/no GLA63218.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chemical Bank (As Security Agent and Trustee for and on Behalf of the Beneficiaries)
    ব্যবসায়
    • ২৭ এপ্রি, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জুন, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    M1 LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১২ মে, ২০১৭ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১৩ ফেব, ২০১৯ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Asher Miller
    David Rubin & Partners
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London
    অভ্যাসকারী
    David Rubin & Partners
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0