QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামQMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02426512
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Suite 64 Waterhouse Business Park
    2 Cromar Way
    CM1 2QE Chelmsford
    Essex
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    QUEENS MOAT HOUSES (A) DEVELOPMENTS LIMITED০৪ জুল, ২০০৫০৪ জুল, ২০০৫
    ASHFORD DEVELOPMENTS LTD০৪ ডিসে, ১৯৮৯০৪ ডিসে, ১৯৮৯
    JUGMEAD LIMITED২৬ সেপ, ১৯৮৯২৬ সেপ, ১৯৮৯

    QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৪

    QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ০২ জানু, ২০১৬ তারিখে Sally Ann Coughlan-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    ০৭ ডিসে, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE থেকে Suite 64 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QEপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৯ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১১ জুন, ২০১৫

    ১১ জুন, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100,000
    SH01

    ০২ অক্টো, ২০১৪ তারিখে Sally Ann Coughlan-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    ৩০ সেপ, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Erwin Joseph Rieck এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৯ সেপ, ২০১৪ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Queens Court 9-17 Eastern Road Romford Essex RM1 3NG থেকে 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QEপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৯ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০২ জুল, ২০১৪

    ০২ জুল, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100,000
    SH01

    পরিচালক হিসাবে Martin Quinn-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Matthew Rosenberg এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    19 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৯ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে W2001 Two Cv এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে W2001 Britannia Llc এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৯ জুন, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    ১২ সেপ, ২০১১ তারিখে Erwin Joseph Rieck-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    21 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৯ জুন, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৯ জুন, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে W2001 Two Cv-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP02

    QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    COUGHLAN, Sally Ann
    Waterhouse Business Park
    2 Cromar Way
    CM1 2QE Chelmsford
    Suite 64
    Essex
    England
    সচিব
    Waterhouse Business Park
    2 Cromar Way
    CM1 2QE Chelmsford
    Suite 64
    Essex
    England
    British107832420001
    QUINN, Martin Joseph
    34 Francis Grove, Wimbledon
    SW19 4DT London
    Westmont Management Limited
    England
    পরিচালক
    34 Francis Grove, Wimbledon
    SW19 4DT London
    Westmont Management Limited
    England
    EnglandIrish186571310001
    BURGESS, Keith John
    3 Queen Annes Gate
    White House Walk
    GU9 9AN Farnham
    Surrey
    সচিব
    3 Queen Annes Gate
    White House Walk
    GU9 9AN Farnham
    Surrey
    British7009790002
    CHRISTIAN, Tracy Joanne
    19 Lovell Walk
    RM13 7ND Rainham
    Essex
    সচিব
    19 Lovell Walk
    RM13 7ND Rainham
    Essex
    British102667300001
    JONES, Vanessa
    Stables House
    Castle Hill
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    সচিব
    Stables House
    Castle Hill
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    British72146200001
    PURVIS, Martin Terence Alan
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    সচিব
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    British7901050001
    STADEN, Paul Sidney
    Swallows Barn
    New College Court
    MK18 5JP Chackmore
    Buckingham
    সচিব
    Swallows Barn
    New College Court
    MK18 5JP Chackmore
    Buckingham
    British35453800001
    WATERS, Jonathan Roy
    Maldon Road
    CO3 3BQ Colchester
    237
    Essex
    সচিব
    Maldon Road
    CO3 3BQ Colchester
    237
    Essex
    British129848360001
    ALLSOP, Heather Louise
    62 Prebend Street
    N1 8PS London
    পরিচালক
    62 Prebend Street
    N1 8PS London
    British101912850001
    ASHFORD, Martin John
    The Elms
    Chessetts Wood Road
    B94 6EL Lapworth
    Solihull
    পরিচালক
    The Elms
    Chessetts Wood Road
    B94 6EL Lapworth
    Solihull
    British1450190001
    BEASLEY, Colin John
    The Ridings
    Plumpton Road, Woodend
    NN12 8RZ Towcester
    Northamptonshire
    পরিচালক
    The Ridings
    Plumpton Road, Woodend
    NN12 8RZ Towcester
    Northamptonshire
    United KingdomBritish65499270001
    COLES, Alan Clifford
    The Knoll
    Grendon
    NN7 1JG Northampton
    Beeches, 5
    Northamptonshire
    পরিচালক
    The Knoll
    Grendon
    NN7 1JG Northampton
    Beeches, 5
    Northamptonshire
    EnglandBritish101144900002
    COLLYER, Brian Charles
    49 Route De Croissy
    78110 Le Vesinet
    France
    পরিচালক
    49 Route De Croissy
    78110 Le Vesinet
    France
    Canadian101144260001
    COPPEL, Andrew Maxwell
    Orchard House
    8 Claremont Park Road
    KT10 9LT Esher
    Surrey
    পরিচালক
    Orchard House
    8 Claremont Park Road
    KT10 9LT Esher
    Surrey
    EnglandBritish14330100002
    COURT, Gregory James
    46 Buckminster Drive
    Dorridge
    B93 8PG Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    46 Buckminster Drive
    Dorridge
    B93 8PG Solihull
    West Midlands
    British17155090002
    CUTTS, John Charles
    Tudor Gables Old Warwick Road
    Lapworth
    B94 6AY Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    Tudor Gables Old Warwick Road
    Lapworth
    B94 6AY Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish56651680001
    ELLAMS, Robert
    34 Alderbrook Road
    B91 1NN Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    34 Alderbrook Road
    B91 1NN Solihull
    West Midlands
    British80180860001
    FEARNSIDE, James Nicholas
    7 Harris Close
    Henley In Arden
    B95 5DE Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    7 Harris Close
    Henley In Arden
    B95 5DE Solihull
    West Midlands
    British54861980001
    GOIN, Russell Todd
    4 Rue Jadin
    75017
    FOREIGN Paris
    France
    পরিচালক
    4 Rue Jadin
    75017
    FOREIGN Paris
    France
    American108675490001
    KABALAN, Fadi
    Keyes House
    Dolphin Square
    SW1V 3NA London
    Suite 311
    পরিচালক
    Keyes House
    Dolphin Square
    SW1V 3NA London
    Suite 311
    EnglandBritish133846470001
    KEIR, David Christopher Lindsay
    Laird Manoch
    Church Lane
    NN6 9NX Harrington
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Laird Manoch
    Church Lane
    NN6 9NX Harrington
    Northamptonshire
    British32255280001
    KRAIS, Ashley Simon
    74 Marsh Lane
    NW7 4NT London
    পরিচালক
    74 Marsh Lane
    NW7 4NT London
    United KingdomBritish105921220001
    LE POIDEVIN, Andrew Daryl
    Kinneil
    34 Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Kinneil
    34 Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish4958800007
    MENARD, Veronique Pascale Dominique
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    England
    পরিচালক
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    England
    United KingdomFrench141156250001
    METCALFE, Michael Stuart
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish40294180002
    MOORE, Richard John
    2 Maple Wood
    Bedhampton
    PO9 3JB Havant
    Hampshire
    পরিচালক
    2 Maple Wood
    Bedhampton
    PO9 3JB Havant
    Hampshire
    EnglandBritish101144680001
    MULAHASANI, Heather Louise
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    পরিচালক
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    EnglandBritish136994090001
    OGDEN, Kathryn
    14 Arundel Court
    43-47 Arundel Gardens
    W11 2LP London
    পরিচালক
    14 Arundel Court
    43-47 Arundel Gardens
    W11 2LP London
    American114248790002
    RIECK, Erwin Joseph
    Queens Court
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    পরিচালক
    Queens Court
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    German108675520002
    ROBERTS, Peter Charles William
    White Lodge
    78 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    পরিচালক
    White Lodge
    78 Tiddington Road
    CV37 7BA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritish81817780001
    ROSENBERG, Matthew Alexander
    Queens Court
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    পরিচালক
    Queens Court
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    EnglandBritish134723670001
    SCOBLE, Timothy James
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    পরিচালক
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish83743120001
    STADEN, Paul Sidney
    Swallows Barn
    New College Court
    MK18 5JP Chackmore
    Buckingham
    পরিচালক
    Swallows Barn
    New College Court
    MK18 5JP Chackmore
    Buckingham
    British35453800001
    W2001 BRITANNIA LLC
    The Corporation Trust Company
    1209 Orange Street
    Wilmington
    The Corporation Trust Company
    County Of Newcastle
    Usa
    কর্পোরেট পরিচালক
    The Corporation Trust Company
    1209 Orange Street
    Wilmington
    The Corporation Trust Company
    County Of Newcastle
    Usa
    আইনি ফর্মLIMITED LIABILITY COMPANY
    পরিচয়পত্রের ধরননন ইইএ
    আইনি কর্তৃপক্ষDELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY ACT
    152068320001
    W2001 TWO CV
    Strawinskylaan 1207
    1077 Xx Amsterdam
    Strawinskylaan 1207
    Netherlands
    কর্পোরেট পরিচালক
    Strawinskylaan 1207
    1077 Xx Amsterdam
    Strawinskylaan 1207
    Netherlands
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর34207195
    152068470001

    QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ মার্চ, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    ব্যবসায়
    • ০৪ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ নভে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ ডিসে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage all estates or interests in the f/h, l/h and other immovable property. By way of fixed charge all estates or interests in any f/h, l/h and other immovable property, all stocks shares debentures bonds notes and loan capital, the goodwill, all copyrights and patents. By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    ব্যবসায়
    • ১৪ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ জুন, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Trust Coproration PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ জুন, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ ফেব, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental deed to the composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জুন, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুন, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Security Trustee for the Junior Term Lenders Defined in Theterm Facility Agreement)
    ব্যবসায়
    • ১১ জুন, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Security Trustee for the Junior Term Lenders)
    ব্যবসায়
    • ২৬ মার্চ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge on shares
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুল, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from glancepress (wokingham) limited or a memeber of the same group to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Seven hundred and fitiyy one sh of £1.00 each in the issued share capiatl of the borrower with all dividends interest and other money for full details please refer to form 395.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুল, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed without instrument
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জুন, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ জুন, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £440,000 due from the company and/or wilson bowden properties limited to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Farmhouse bungalow farm buildings and land containing 6.84 acres or thereabouts forming part of gate farm bardon hill near coalville leicestershire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • David Walker
    ব্যবসায়
    • ১৩ জুন, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ এপ্রি, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land at rockingham road market harborough leicestershire t/n lt 227168.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land at the embankment wellingborough northhamptonshire t/n nn 147287.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land at embankment wellingborough northamptonshire t/n nn 139614.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The palais bingo hall, wentworth street, peterborough, cambridgeshire. T/n CB77541.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land on the south side of raywell street, kingston-upon-hull, humberside. T/n HS194357.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ এপ্রি, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    5 new walk, and 38-50 (even numbers) king street, leicester, leicestershire. T/n LT151627.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    5 new walk and 38-50 (even numbers) king street, leicester, leicestershire. T/n LT58751.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    5 new walk and 38-50 (even numbers) king street, leicester, leicestershire. T/n LT39919.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land at rockingham road, market harborough, leicestershire. T/n LT233767.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land at barton dock road, trafford park, manchester, greater manchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ আগ, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ জুল, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জুল, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H plot e, swift park rugby, title no wk 327361 all the companys right title & interest in the balance of the sale proceeds (if any) (see form 395 for full details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Electronic Magnetic Services Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ জুল, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৯ এপ্রি, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ নভে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ নভে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    24.65 acres of land at cosford lane, rugby, warwickshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ নভে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৯ জুন, ২০০৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৯ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0