MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামMICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02428813
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবা কার্যক্রম (62090) / তথ্য এবং যোগাযোগ

    MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    CALDER ASHBY PROPERTY SYSTEMS LIMITED০২ জানু, ১৯৯০০২ জানু, ১৯৯০
    GATEFIR LIMITED০৪ অক্টো, ১৯৮৯০৪ অক্টো, ১৯৮৯

    MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ এপ্রি, ২০১৮

    MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    6 পৃষ্ঠাLIQ13

    ০৩ মে, ২০১৯ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4NW থেকে 15 Canada Square London E14 5GLপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ০৩ এপ্রি, ২০১৯ তারিখে

    LRESSP

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    5 পৃষ্ঠাLIQ01

    মাইক্রো এন্ট্রিটি হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    ০৪ অক্টো, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩০ এপ্রি, ২০১৯ থেকে ৩১ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ০৬ আগ, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ian Michael Noble এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৬ আগ, ২০১৮ তারিখে Mr Stephen James Callaghan-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    মাইক্রো এন্ট্রিটি হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    ০৪ অক্টো, ২০১৭ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ০৬ ডিসে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ian Michael Noble-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৬ ডিসে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Andrew Coll এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১০ অক্টো, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Stephen James Callaghan-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১০ অক্টো, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে David John Meaden এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৪ অক্টো, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৪ অক্টো, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০২ নভে, ২০১৫

    ০২ নভে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 40,000
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ২২ ডিসে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে David John Meaden-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২২ ডিসে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে John Robert Stier এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২২ ডিসে, ২০১৪ তারিখে সচিব হিসাবে Pinsent Masons Secretarial Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP04

    MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর2318923
    76579530001
    CALLAGHAN, Stephen James
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish201347710052
    COUTTS, Cheryl Jane
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    সচিব
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    British12016130002
    COX, Melanie Rachel
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    সচিব
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    British96139050001
    EMERTON, Leslie David
    Pentarrow
    39 Elphinstone Road Highcliffe
    BH23 5LL Christchurch
    Dorset
    সচিব
    Pentarrow
    39 Elphinstone Road Highcliffe
    BH23 5LL Christchurch
    Dorset
    British49739670002
    HARDING, Gary John
    3 Denham Close
    HP2 7JW Hemel Hempstead
    Herts
    সচিব
    3 Denham Close
    HP2 7JW Hemel Hempstead
    Herts
    British33944660001
    HEMMING, Vivienne Ruth
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    সচিব
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    British41962390006
    HUMPHREY, Christopher John
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    সচিব
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    British32877720003
    MURRAY, Margaret
    15 Southborough Road
    KT6 6JN Surbiton
    Surrey
    সচিব
    15 Southborough Road
    KT6 6JN Surbiton
    Surrey
    British27816020002
    RICHARDSON, John David
    High Street
    Burnham
    SL1 7JD Slough
    27
    Berks
    সচিব
    High Street
    Burnham
    SL1 7JD Slough
    27
    Berks
    British128558470001
    SADLER, John Michael
    14 Highlands Close
    SL9 0DR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    সচিব
    14 Highlands Close
    SL9 0DR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78431540001
    SCHENCK, Daniel William
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    সচিব
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Usa181204960001
    AL-SALEH, Adel Bedry
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican165900220001
    ASHBY, Peter Anthony
    46 Manford Way
    IG7 4JG Chigwell
    Essex
    পরিচালক
    46 Manford Way
    IG7 4JG Chigwell
    Essex
    British4998540001
    BASS, Neil Anthony
    31 Archery Fields
    RG29 1AE Odiham
    Hampshire
    পরিচালক
    31 Archery Fields
    RG29 1AE Odiham
    Hampshire
    EnglandBritish70199330002
    BODHA, James Sanjay
    Rook How
    22 Elm Tree Road
    WA13 0NB Lymm
    Cheshire
    পরিচালক
    Rook How
    22 Elm Tree Road
    WA13 0NB Lymm
    Cheshire
    EnglandBritish93657140001
    BRITTAIN, David Leonard
    The Gables Avey Lane
    EN9 3QH Waltham Abbey
    Essex
    পরিচালক
    The Gables Avey Lane
    EN9 3QH Waltham Abbey
    Essex
    British70451880001
    COLL, Andrew
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish237260100001
    DAMIRAL, Alan
    18 Paddock Close
    St Marys Platt
    TN15 8NN Sevenoaks
    Kent
    পরিচালক
    18 Paddock Close
    St Marys Platt
    TN15 8NN Sevenoaks
    Kent
    British21498890001
    GIBSON, John Leonard
    Ivydene
    Delly End
    OX29 9XD Hailey
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Ivydene
    Delly End
    OX29 9XD Hailey
    Oxfordshire
    British104554430001
    MASSIE, Michael Leslie
    Homeleigh 218 Main Road
    Hoo
    ME3 9HG Rochester
    Kent
    পরিচালক
    Homeleigh 218 Main Road
    Hoo
    ME3 9HG Rochester
    Kent
    United KingdomBritish21498880001
    MEADEN, David John
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish193740420001
    MOORE, Graham Anthony
    81 Aldwick Felds
    Aldwick
    PO21 3TH Bognor Regis
    W Sussex
    পরিচালক
    81 Aldwick Felds
    Aldwick
    PO21 3TH Bognor Regis
    W Sussex
    British53937410001
    MURRAY, Lawrence John
    Michaelmas Lodge
    Sandy Down Boldre
    SO41 8PN Lymington
    Hampshire
    পরিচালক
    Michaelmas Lodge
    Sandy Down Boldre
    SO41 8PN Lymington
    Hampshire
    British27816030003
    MURRAY, Margaret
    15 Southborough Road
    KT6 6JN Surbiton
    Surrey
    পরিচালক
    15 Southborough Road
    KT6 6JN Surbiton
    Surrey
    British27816020002
    NOBLE, Ian Michael
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish199843940001
    O'KEEFE, Gerard Patrick
    10 Cornes Close
    SO22 5DS Winchester
    Hampshire
    পরিচালক
    10 Cornes Close
    SO22 5DS Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish96633370001
    ROWLEY, Stephen Paul, Mr.
    Hadleigh 16 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    পরিচালক
    Hadleigh 16 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    United KingdomBritish93738770001
    STIER, John Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish78901530003
    STONE, Christopher Michael Renwick
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish66955690003
    TAIT, Ian
    Field House
    Evesham Road
    WR10 2QR Fladbury
    Worcestershire
    পরিচালক
    Field House
    Evesham Road
    WR10 2QR Fladbury
    Worcestershire
    United KingdomBritish76976490001
    TYRRELL, Simon Robert Edgar
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    পরিচালক
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    EnglandBritish77284710002

    MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland And Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom (England And Wales)
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর03495019
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ফেব, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ নভে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ নভে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ নভে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 9TH december 2002
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ মার্চ, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ মার্চ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    An omnibus letter of set-off
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ ডিসে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ অক্টো, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date and any documents supplemental thereto
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deposit account which the deposit of £15,000 has been paid.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Vemore Limited
    ব্যবসায়
    • ২০ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মে, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জানু, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জানু, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date and any documents supplemental thereto
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deposit account which the deposit of £6,171 has been paid.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Vemore Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ জানু, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ এপ্রি, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ আগ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ সেপ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    MICRO SURVEYS PROPERTY SYSTEMS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৩ এপ্রি, ২০১৯ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০১ ফেব, ২০২০ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    অভ্যাসকারী
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    অভ্যাসকারী
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0