COX PLASTICS TECHNOLOGIES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCOX PLASTICS TECHNOLOGIES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02429408
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    COX PLASTICS TECHNOLOGIES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (2524) /

    COX PLASTICS TECHNOLOGIES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    C/O Pc Cox Turnpike Industrial Estate
    Turnpike Road
    RG14 2LR Newbury
    Berkshire
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    COX PLASTICS TECHNOLOGIES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ARK PLASTIC PRODUCTS LIMITED০৫ অক্টো, ১৯৮৯০৫ অক্টো, ১৯৮৯

    COX PLASTICS TECHNOLOGIES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৯

    COX PLASTICS TECHNOLOGIES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৩ জুন, ২০১০

    ২৩ জুন, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353

    legacy

    1 পৃষ্ঠা190

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    legacy

    6 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    30 পৃষ্ঠা395

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    4 পৃষ্ঠা395

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    সমিতির এবং সংবিধির নথি

    10 পৃষ্ঠাMA

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed ark plastic products LIMITED\certificate issued on 07/06/06
    2 পৃষ্ঠাCERTNM

    COX PLASTICS TECHNOLOGIES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CRAWFORD, Peter
    Flintwall Cottage
    Ashmansworth
    RG20 9SS Newbury
    Berkshire
    সচিব
    Flintwall Cottage
    Ashmansworth
    RG20 9SS Newbury
    Berkshire
    British116054670001
    CRAWFORD, Peter
    Flintwall Cottage
    Ashmansworth
    RG20 9SS Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    Flintwall Cottage
    Ashmansworth
    RG20 9SS Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish116054670001
    LUMB, Frederick Jan
    24 High Street
    Great Cheverell
    SN10 5TH Devizes
    Wiltshire
    পরিচালক
    24 High Street
    Great Cheverell
    SN10 5TH Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritish53013890002
    BARBER, Andrew Kevin
    4 The Smithy
    NN3 3PL Northampton
    Northamptonshire
    সচিব
    4 The Smithy
    NN3 3PL Northampton
    Northamptonshire
    British17925340003
    JAMESON, Robert Anthony
    4 Barbers Wood Road
    HP12 4EP High Wycombe
    Buckinghamshire
    সচিব
    4 Barbers Wood Road
    HP12 4EP High Wycombe
    Buckinghamshire
    British15014980001
    BARBER, Andrew Kevin
    4 The Smithy
    NN3 3PL Northampton
    Northamptonshire
    পরিচালক
    4 The Smithy
    NN3 3PL Northampton
    Northamptonshire
    British17925340003
    BARBER, Keith
    24 Manor Plc
    Nether Heyford
    NN7 3NN
    Northants
    পরিচালক
    24 Manor Plc
    Nether Heyford
    NN7 3NN
    Northants
    British17925350001
    JAMESON, Robert Anthony
    4 Barbers Wood Road
    HP12 4EP High Wycombe
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    4 Barbers Wood Road
    HP12 4EP High Wycombe
    Buckinghamshire
    British15014980001
    PORTER, David
    6 Kenwin Close
    Stratton St Margaret
    SN3 4NY Swindon
    Wiltshire
    পরিচালক
    6 Kenwin Close
    Stratton St Margaret
    SN3 4NY Swindon
    Wiltshire
    British58295100001

    COX PLASTICS TECHNOLOGIES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ নভে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ ডিসে, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Venture Finance PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ ডিসে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ জানু, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জানু, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first fixed charge the plant, machinery, chattels and/or other equipment specified in the schedule being, demag ergotech 250-840 NC4 vdu moulding machine s/no:878-0329, demag ergotech 250-840 NC4 vdu moulding machine s/no:878-0574, 2 off isolator switches, for details of further chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২০ জানু, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জানু, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জুল, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ জুল, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৬ জুল, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ ডিসে, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জানু, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জানু, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ জানু, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০১ জুন, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0