VENTUREWORLD LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামVENTUREWORLD LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02439474
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    VENTUREWORLD LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (9999) /

    VENTUREWORLD LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Lynton House
    Ackhurst Park
    PR7 1NY Foxhole Road Chorley
    Lancashire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    VENTUREWORLD LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১০

    VENTUREWORLD LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৩ নভে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৯ নভে, ২০১০

    ১৯ নভে, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2,302,272
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৩ নভে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    ২৬ নভে, ২০০৯ তারিখে John Clement Kay-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ২৬ নভে, ২০০৯ তারিখে Mr St John Stott-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৬ নভে, ২০০৯ তারিখে John Clement Kay-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    legacy

    10 পৃষ্ঠা395

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    3 পৃষ্ঠা403a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    6 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    VENTUREWORLD LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    KAY, John Clement
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United Kingdom
    সচিব
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United Kingdom
    British27891540001
    KAY, John Clement
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    পরিচালক
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    EnglandBritish27891540001
    STOTT, St John
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    পরিচালক
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United KingdomBritish83024660001
    LIVESEY, Frederick Joseph
    86d Whitley Crescent
    WN1 2PP Wigan
    Lancashire
    সচিব
    86d Whitley Crescent
    WN1 2PP Wigan
    Lancashire
    British32145610003
    LLOYD, Roger William
    1 Glen Park Close
    Chellaston
    DE73 5NT Derby
    Derbyshire
    সচিব
    1 Glen Park Close
    Chellaston
    DE73 5NT Derby
    Derbyshire
    British123160110001
    PENROSE, Ian Richard
    17 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    সচিব
    17 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    British32311080001
    STOTT, St John
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    সচিব
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    British83024660001
    BROOME, John Lawson
    Rednal Manor
    Rednal, West Felton
    SY11 4HT Oswestry
    Shropshire
    পরিচালক
    Rednal Manor
    Rednal, West Felton
    SY11 4HT Oswestry
    Shropshire
    British67181090001
    FRANCE-HAYHURST, James Robert
    Mayfield House
    Bunbury
    CW6 9SY Tarporley
    Cheshire
    পরিচালক
    Mayfield House
    Bunbury
    CW6 9SY Tarporley
    Cheshire
    EnglandBritish73943640003
    HEMMINGS, Craig John
    Charnock House Preston Road
    Charnock Richard
    PR7 5LH Chorley
    Lancashire
    পরিচালক
    Charnock House Preston Road
    Charnock Richard
    PR7 5LH Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish180952730001
    HEMMINGS, Craig John
    Charnock House Preston Road
    Charnock Richard
    PR7 5LH Chorley
    Lancashire
    পরিচালক
    Charnock House Preston Road
    Charnock Richard
    PR7 5LH Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish180952730001
    HEMMINGS, Peter Graham
    Shannon Court Bowring Road
    IM8 2LQ Ramsey
    Isle Of Man
    পরিচালক
    Shannon Court Bowring Road
    IM8 2LQ Ramsey
    Isle Of Man
    British16512550007
    HEMMINGS, Trevor James
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    পরিচালক
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    United KingdomBritish65090920001
    KILBY, Eric Melvyn
    The Coach House
    Didsbury
    M20 0DA Manchester
    পরিচালক
    The Coach House
    Didsbury
    M20 0DA Manchester
    British165870001
    PENROSE, Ian Richard
    17 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    পরিচালক
    17 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    British32311080001
    STOTT, St John
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    পরিচালক
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    United KingdomBritish83024660001
    SUNLEY, Anthony William
    22 East Grinstead Road
    RH7 6EP Lingfield
    Surrey
    পরিচালক
    22 East Grinstead Road
    RH7 6EP Lingfield
    Surrey
    British6467980001
    WIDDERS, Mark Lorimer
    12 Clovelly Drive
    Hillside
    PR8 3AJ Southport
    Merseyside
    পরিচালক
    12 Clovelly Drive
    Hillside
    PR8 3AJ Southport
    Merseyside
    EnglandBritish2272770002

    VENTUREWORLD LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ অক্টো, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জুল, ২০০৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Guild Ventures Limited
    ব্যবসায়
    • ২৪ জুল, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    1ST party commercial legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ আগ, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ আগ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms and conditions as set out in this legal charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land on the south east of pit lane shipley derbyshire t/n-DY137890.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৮ আগ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ এপ্রি, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ এপ্রি, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0