OSS ENVIRONMENTAL LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামOSS ENVIRONMENTAL LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02440440
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    OSS ENVIRONMENTAL LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • জ্বালানী, আকরিক, ধাতু এবং শিল্প রাসায়নিক বিক্রয় জড়িত এজেন্ট (46120) / হোলসেল এবং খুচরা বিক্রয়; মোটর গাড়ি এবং মোটরসাইকেল মেরামত

    OSS ENVIRONMENTAL LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    OSS ENVIRONMENTAL LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    BCS FUELS LIMITED০৬ নভে, ১৯৮৯০৬ নভে, ১৯৮৯

    OSS ENVIRONMENTAL LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১১

    OSS ENVIRONMENTAL LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    OSS ENVIRONMENTAL LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ২৮ ফেব, ২০১৪ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    20 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসন থেকে দ্রবণে স্থানান্তরের নোটিশ

    23 পৃষ্ঠা2.35B

    প্রস্তাবগুলির অনুমোদিত অনুমোদনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠাF2.18

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    36 পৃষ্ঠা2.17B

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 2.14B

    7 পৃষ্ঠা2.16B

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    চার্জ 7 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 4 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৬ জুন, ২০১৩

    ২৬ জুন, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ জুন, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    legacy

    3 পৃষ্ঠা395

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    OSS ENVIRONMENTAL LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    LEES, Iain Roger
    Church Farm
    School Lane
    WA16 0JF Pickmere
    Cheshire
    সচিব
    Church Farm
    School Lane
    WA16 0JF Pickmere
    Cheshire
    BritishDirector72628960001
    LEES, Iain Roger
    Church Farm
    School Lane
    WA16 0JF Pickmere
    Cheshire
    পরিচালক
    Church Farm
    School Lane
    WA16 0JF Pickmere
    Cheshire
    EnglandBritishDirector72628960001
    MCNAIR, Andrew Malcolm
    Tamarind House
    Cleghorn
    ML11 8NZ Lanark
    Lanarkshire
    পরিচালক
    Tamarind House
    Cleghorn
    ML11 8NZ Lanark
    Lanarkshire
    United KingdomBritishManaging Director68954380002
    FAGAN, Brian
    Lambay House, 2 Abbey Street
    Howth
    Dublin
    Ireland
    সচিব
    Lambay House, 2 Abbey Street
    Howth
    Dublin
    Ireland
    Irish58330390001
    HESKETH, Mark James
    19 Littlecote Gardens
    Appleton
    WA4 5DL Warrington
    Cheshire
    সচিব
    19 Littlecote Gardens
    Appleton
    WA4 5DL Warrington
    Cheshire
    BritishCompany Director77855520001
    MCNAIR, Andrew Malcolm
    Tamarind House
    Cleghorn
    ML11 8NZ Lanark
    Lanarkshire
    সচিব
    Tamarind House
    Cleghorn
    ML11 8NZ Lanark
    Lanarkshire
    BritishManaging Director68954380002
    BEAUMONT, David Michael Leslie
    871 Manchester Road
    Linthwaite
    HD7 5NE Huddersfield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    871 Manchester Road
    Linthwaite
    HD7 5NE Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director30052810001
    CACKETT, John William
    White House
    Barrison Green, Scarisbrick
    L40 8HX Ormskirk
    Lancashire
    পরিচালক
    White House
    Barrison Green, Scarisbrick
    L40 8HX Ormskirk
    Lancashire
    BritishChairman64146540001
    FACIAN, Brian
    4 Norbour View
    IRISH Howth
    Co Dublin
    পরিচালক
    4 Norbour View
    IRISH Howth
    Co Dublin
    IrishCompany Director28941990001
    GALLAGHER, Adrian
    83 Hollybank Road
    IRISH Drumcondra
    Dublin 9
    Ireland
    পরিচালক
    83 Hollybank Road
    IRISH Drumcondra
    Dublin 9
    Ireland
    IrishCompany Director13373910001
    HESKETH, Mark James
    19 Littlecote Gardens
    Appleton
    WA4 5DL Warrington
    Cheshire
    পরিচালক
    19 Littlecote Gardens
    Appleton
    WA4 5DL Warrington
    Cheshire
    BritishCompany Director77855520001
    KIRRANE, Thomas
    1 Castlecove
    Yellow Walls Road
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Ireland
    পরিচালক
    1 Castlecove
    Yellow Walls Road
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director1213760001
    PHILLIPS, John
    21 Beech Tree Close
    Oakley
    RG23 7EF Basingstoke
    Hampshire
    পরিচালক
    21 Beech Tree Close
    Oakley
    RG23 7EF Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director27081540001
    STURDY, Richard Alan
    Warren House Farm
    Galphay
    HG4 3PB Ripon
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Warren House Farm
    Galphay
    HG4 3PB Ripon
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director44637280001
    WILSON, Anthony
    34 Battenhall Rise
    WR5 2DE Worcester
    Hereford & Worcester
    পরিচালক
    34 Battenhall Rise
    WR5 2DE Worcester
    Hereford & Worcester
    BritishCompany Director54806510002

    OSS ENVIRONMENTAL LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জুল, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ জুল, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the mortgagor to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings on north west side of barracks road sandy lane industrial estate titton stourport on seven t/n HW125790.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ জুল, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ সেপ, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Composite debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ মে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ing Bank N.V., London Branch
    ব্যবসায়
    • ০২ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ মে, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ অক্টো, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ নভে, ২০০১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All liabilities and obligations due or to become due from the company to (1) the holders of the £4,774,000 8% loan stock 2009 ("loan stock") or any of them under the loan stock deed of even date or the loan stock and to (2) the security trustee under this instrument. (All terms as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first legal mortgage all land now owned by the company. By way of first fixed equitable charge all land which, the company acquires in the future. By way of separate first fixed charges the goodwill and uncalled capital, the securities, insurances, intellectual property, debts, rents, asset contracts, other claims, fixed plant and equipment and the loose plant and equipment. By way of first floating charge all those assets which are not for any reason effectively charged by way of fixed charge.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dunedin Enterprise Investment Trust PLC ("Security Trustee" as Agent Andtrustee for Itself and Each of the Holders of the "Loan Stock")
    ব্যবসায়
    • ০২ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    A deed of accession between the company oss group limited and dunedin enterprise investment trust PLC
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জুল, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জুল, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future liabilities and obligations owed by the company to the stockholders (as defined) or any of them under the loan stock deed or the loan stock and to the chargee (the security trustee) under the guarantee and debenture dated 13 march 2000
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the undertaking property and assets of the company whatsoever and wheresoever present and future. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dunedin Enterprise Investment Trust PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ জুল, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ সেপ, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Composite debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ মে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ জুন, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and liabilities due or to become due from the company and each other obligor (as defined) to the chargee under the finance documents (as defined) or any of them on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bhf-Bank Ag
    ব্যবসায়
    • ০১ জুন, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ মে, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১১ সেপ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ সেপ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ সেপ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ জানু, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১১ সেপ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ সেপ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a land at barracks road, stourport on severn in the county of worcestershire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ সেপ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    OSS ENVIRONMENTAL LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৮ ফেব, ২০১৪প্রশাসন শেষ
    ০৬ সেপ, ২০১৩প্রশাসন শুরু
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    অভ্যাসকারী
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Paul Andrew Flint
    Kpmg
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    অভ্যাসকারী
    Kpmg
    St James' Square
    M2 6DS Manchester

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0