TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02449641
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (9999) /

    TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HORNGLADE PROJECTS LIMITED১৪ আগ, ১৯৯০১৪ আগ, ১৯৯০
    PROPERTY DEVELOPMENT PROJECT LIMITED২৯ ডিসে, ১৯৮৯২৯ ডিসে, ১৯৮৯
    HARLACRE LIMITED০৫ ডিসে, ১৯৮৯০৫ ডিসে, ১৯৮৯

    TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৭

    TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    পরিচালক হিসাবে Mr Stephen Derrick Breach-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Simon Lawton এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Mr Peter John Martin-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Mr Simon Marcus Lawton-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Richard Hawke Collins-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা225

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    9 পৃষ্ঠা395

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    COLLINS, Richard Hawke
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    সচিব
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    British53398040001
    BREACH, Stephen Derrick
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    পরিচালক
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    United KingdomBritish147928530001
    MARTIN, Peter John
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    পরিচালক
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    EnglandBritish176044430001
    BLANKS, Gareth John Ryder
    Little Sir Hughes
    West Hanningfield Road Great Baddow
    CM2 7SZ Chelmsford
    Essex
    সচিব
    Little Sir Hughes
    West Hanningfield Road Great Baddow
    CM2 7SZ Chelmsford
    Essex
    British89781940001
    CANNINGS, Colin Graham
    20 Red Lion Street
    WC1R 4PS London
    সচিব
    20 Red Lion Street
    WC1R 4PS London
    British4936580001
    LAWTON, Simon Marcus
    Long Ash
    Woodbridge Lane Withington
    GL54 4BP Cheltenham
    Gloucestershire
    সচিব
    Long Ash
    Woodbridge Lane Withington
    GL54 4BP Cheltenham
    Gloucestershire
    British68807890004
    APPLEBY, Robert
    8 Stevenson Way
    Larkfield
    ME20 6UN Aylesford
    Kent
    পরিচালক
    8 Stevenson Way
    Larkfield
    ME20 6UN Aylesford
    Kent
    British100449850001
    BLANKS, Gareth John Ryder
    Little Sir Hughes
    West Hanningfield Road Great Baddow
    CM2 7SZ Chelmsford
    Essex
    পরিচালক
    Little Sir Hughes
    West Hanningfield Road Great Baddow
    CM2 7SZ Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish89781940001
    DICKS, Steven Trevor
    60 Penningtons
    CM23 4LF Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    60 Penningtons
    CM23 4LF Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    British72561270001
    GRANGER, Adam
    1 Wormbwell Gardens
    DA11 8BL Northfleet
    Kent
    পরিচালক
    1 Wormbwell Gardens
    DA11 8BL Northfleet
    Kent
    EnglandBritish97482630002
    JENKINS, David Charles
    12 Queens Road
    SS7 1JW Benfleet
    Essex
    পরিচালক
    12 Queens Road
    SS7 1JW Benfleet
    Essex
    British13763330002
    LAWTON, Simon Marcus
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    পরিচালক
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    EnglandBritish68807890004
    NEILSON, Lindsay Stewart
    Ash House
    Ash Road New Ash Green
    DA3 8JD Longfield
    Kent
    পরিচালক
    Ash House
    Ash Road New Ash Green
    DA3 8JD Longfield
    Kent
    British60819520001
    PITMAN, Henry John
    Pinbury Park
    Duntisbourne Rouse
    GL7 7LG Cirencester
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Pinbury Park
    Duntisbourne Rouse
    GL7 7LG Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritish55231490005
    TODMAN, Andrew William
    4 St Marys Close
    Laddingford
    ME18 6DG Maidstone
    Kent
    পরিচালক
    4 St Marys Close
    Laddingford
    ME18 6DG Maidstone
    Kent
    UkBritish115840330001

    TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জুন, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ জুন, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each group company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২১ জুন, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ অক্টো, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ অক্টো, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ অক্টো, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৩ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ অক্টো, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ এপ্রি, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Each of the Financeparties (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ৩০ এপ্রি, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ অক্টো, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Guarantee and debenture between the company (1) and the south place gresham partnership 2000 as trustee for itself and the noteholders ("trustee") (2)
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ ডিসে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ ডিসে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and liabilities due, owing or incurred in whatever manner by the principal (as defined) to any noteholder (as defined) under or in respect of any designated loan note or any other secured party (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The South Place Gresham Partnership 2000
    ব্যবসায়
    • ২৮ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ এপ্রি, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ ডিসে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২২ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ অক্টো, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুন, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    ব্যবসায়
    • ১২ জুন, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ নভে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0