LSUK 2009 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামLSUK 2009 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02456232
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    LSUK 2009 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (5156) /
    • (5190) /

    LSUK 2009 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    LSUK 2009 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    LITHO SUPPLIES (UK) LIMITED১৯ অক্টো, ১৯৯৩১৯ অক্টো, ১৯৯৩
    LITHO SUPPLIES LIMITED০৫ ফেব, ১৯৯১০৫ ফেব, ১৯৯১
    DRG LITHO SUPPLIES LIMITED২৬ জানু, ১৯৯০২৬ জানু, ১৯৯০
    TESTRICH LIMITED২৯ ডিসে, ১৯৮৯২৯ ডিসে, ১৯৮৯

    LSUK 2009 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৮

    LSUK 2009 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    14 পৃষ্ঠা4.72

    ২৫ আগ, ২০১১ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    19 পৃষ্ঠা4.68

    প্রশাসন থেকে ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেশনে স্থানান্তরের নোটিশ

    24 পৃষ্ঠা2.34B

    ২১ জুন, ২০১০ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    24 পৃষ্ঠা2.24B

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    ক্রেডিটরদের সভার ফলাফল

    3 পৃষ্ঠা2.23B

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 2.14B

    9 পৃষ্ঠা2.16B

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    81 পৃষ্ঠা2.17B

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    81 পৃষ্ঠা2.17B

    সচিব হিসাবে Simon Wellings এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Simon Wellings এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Edward Williams এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ৩০ ডিসে, ২০০৯

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসক নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠা2.12B

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Facility agreement 03/12/2009
    RES13
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES01

    legacy

    14 পৃষ্ঠাMG01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    38 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা395

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    LSUK 2009 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HAMMOND, Michael John
    Cover Point 195 Attenborough Lane
    Attenborough
    NG9 6AB Nottingham
    পরিচালক
    Cover Point 195 Attenborough Lane
    Attenborough
    NG9 6AB Nottingham
    EnglandBritish49566080001
    MITCHELL, John Gerald
    13 Old Sneed Road
    Stoke Bishop
    BS9 1ES Bristol
    সচিব
    13 Old Sneed Road
    Stoke Bishop
    BS9 1ES Bristol
    British48246470002
    RAMCHANDANI, Gulab Nanikram
    4 Off The Scop
    Lower Almondsbury
    BS12 4DU Bristol
    সচিব
    4 Off The Scop
    Lower Almondsbury
    BS12 4DU Bristol
    British15144500001
    WELLINGS, Simon James
    91 Holbrook Road
    Alvaston
    DE24 0LX Derby
    Derbyshire
    সচিব
    91 Holbrook Road
    Alvaston
    DE24 0LX Derby
    Derbyshire
    British76667130001
    BYFORD, John Peter
    The Orchard Hilfield Lane South
    WD23 4EL Bushey Heath
    Hertfordshire
    পরিচালক
    The Orchard Hilfield Lane South
    WD23 4EL Bushey Heath
    Hertfordshire
    British17458340001
    COOPER, Terence Francis Charles
    34 Castle Road
    BS21 7DE Clevedon
    Avon
    পরিচালক
    34 Castle Road
    BS21 7DE Clevedon
    Avon
    EnglandBritish102793570001
    MITCHELL, John Gerald
    13 Old Sneed Road
    Stoke Bishop
    BS9 1ES Bristol
    পরিচালক
    13 Old Sneed Road
    Stoke Bishop
    BS9 1ES Bristol
    EnglandBritish48246470002
    MULVANEY, Gerald Owen
    17 Mapperley Hall Drive
    Mapperley Park
    NG3 5EP Nottingham
    পরিচালক
    17 Mapperley Hall Drive
    Mapperley Park
    NG3 5EP Nottingham
    United KingdomBritish36169070001
    RAMCHANDANI, Gulab Nanikram
    4 Off The Scop
    Lower Almondsbury
    BS12 4DU Bristol
    পরিচালক
    4 Off The Scop
    Lower Almondsbury
    BS12 4DU Bristol
    British15144500001
    STOCKTON, James Wardlaw
    4 Oswald Walk
    Milngavie
    G62 6AY Glasgow
    Lanarkshire
    পরিচালক
    4 Oswald Walk
    Milngavie
    G62 6AY Glasgow
    Lanarkshire
    British1381020001
    WELLINGS, Simon James
    91 Holbrook Road
    Alvaston
    DE24 0LX Derby
    Derbyshire
    পরিচালক
    91 Holbrook Road
    Alvaston
    DE24 0LX Derby
    Derbyshire
    EnglandBritish76667130001
    WILLIAMS, Edward Gordon
    Amberley 129 Nottingham Road
    Ravenshead
    NG15 9HJ Nottingham
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    Amberley 129 Nottingham Road
    Ravenshead
    NG15 9HJ Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish100565740001

    LSUK 2009 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ডিসে, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ডিসে, ২০০৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Db Invoice Finance 12 Limited
    ব্যবসায়
    • ১৭ ডিসে, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    All asset debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ মে, ২০০৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Eurofactor (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ১২ মে, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Guarantee and collateral debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জানু, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from h s holdings limited to the chargee under the terms of the mezzanine loan agreement dated 14/1/91.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All property as described in schedule, the goodwill and uncalled capital bookdebts, see form 395 (ref 436) and schedule for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I Group Plcers as Definedfor Itself and as Agent and Trustee for the Lend
    ব্যবসায়
    • ২৪ জানু, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৫ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জানু, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জানু, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Unit 4 avon trading estate albert road st philips bristol avon T.no av 168492.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ জানু, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৩ জুন, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জানু, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জানু, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and premises at dale street bilston wolverhampton west midlands t/no sf 103559, wm 164694 and sf 112396.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ জানু, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৫ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Letter of offset
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জানু, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জানু, ১৯৯১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company or l s holdings limited to the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sums now or hereafter standing to the credit of any account or accounts in the name of the company.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ জানু, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জানু, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জানু, ১৯৯১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ জানু, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৫ নভে, ১৯৯৭বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৩ জুন, ২০০৭বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)

    LSUK 2009 LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২২ ডিসে, ২০০৯প্রশাসন শুরু
    ২৬ আগ, ২০১০প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Phillip Francis Duffy
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    অভ্যাসকারী
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Andrew Gordon Stoneman
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    অভ্যাসকারী
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    2
    তারিখপ্রকার
    ২৬ আগ, ২০১০ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ২২ আগ, ২০১২ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Phillip Francis Duffy
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    অভ্যাসকারী
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Andrew Gordon Stoneman
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    অভ্যাসকারী
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0