REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামREGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02456356
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ভবন নির্মাণ প্রকল্প উন্নয়ন (41100) / নির্মাণ
    • ফি বা চুক্তিভিত্তিক ভিত্তিতে রিয়েল এস্টেট পরিচালনা (68320) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম

    REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    The Hall Barn Church Lane
    Lewknor
    OX49 5TP Watlington
    Oxfordshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    NORTH WEST ESTATES (WHITCHURCH) LIMITED১৯ নভে, ১৯৯২১৯ নভে, ১৯৯২
    NORTH WEST ESTATES (HATHERN) LIMITED২৬ ফেব, ১৯৯০২৬ ফেব, ১৯৯০
    GRANDMILE LIMITED২৯ ডিসে, ১৯৮৯২৯ ডিসে, ১৯৮৯

    REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১১

    REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ নভে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৩ নভে, ২০১৩

    ১৩ নভে, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ নভে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Miss Carly Colman-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে Richard Ashken এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩০ সেপ, ২০১১ থেকে ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    legacy

    4 পৃষ্ঠাMG02

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ নভে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ নভে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ নভে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    বিবিধ

    Section 394
    1 পৃষ্ঠাMISC

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    2 পৃষ্ঠা88(2)R

    legacy

    1 পৃষ্ঠা123

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    অনুমোদিত শেয়ার মূলধন বাড়ানোর রেজুলেশন

    RES04

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    7 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের স্মারকলিপি এবং/অথবা নিবন্ধের রেজুলেশন

    RES01

    legacy

    3 পৃষ্ঠা395

    REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    COLMAN, Carly
    Church Lane
    Lewknor
    OX49 5TP Watlington
    The Hall Barn
    Oxfordshire
    সচিব
    Church Lane
    Lewknor
    OX49 5TP Watlington
    The Hall Barn
    Oxfordshire
    169548470001
    ASHKEN, Richard Laurence
    3 Heriots Close
    HA7 3EE Stanmore
    Middlesex
    পরিচালক
    3 Heriots Close
    HA7 3EE Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish10187380006
    FINCKEN, Paul Edward
    Elm Lodge
    Chinnor Road
    OX49 5SH Aston Rowant
    পরিচালক
    Elm Lodge
    Chinnor Road
    OX49 5SH Aston Rowant
    United KingdomBritish109887450001
    ASHKEN, Richard Laurence
    3 Heriots Close
    HA7 3EE Stanmore
    Middlesex
    সচিব
    3 Heriots Close
    HA7 3EE Stanmore
    Middlesex
    British10187380006
    FLICK SMITH, Sarah Louise
    16 Furzeham Road
    UB7 9DD West Drayton
    Middlesex
    সচিব
    16 Furzeham Road
    UB7 9DD West Drayton
    Middlesex
    British85593040001
    MANGAR, Sahadeo
    15 St Agnes Close
    Gore Road
    E9 7HS London
    সচিব
    15 St Agnes Close
    Gore Road
    E9 7HS London
    British48304010001
    PEARL, Brian Irving
    Minster House
    9 Peterborough Road
    HA1 2YW Harrow
    Middlesex
    সচিব
    Minster House
    9 Peterborough Road
    HA1 2YW Harrow
    Middlesex
    British36426610001
    PEARL, Brian Irving
    Minister House
    8 Peterborough Road
    HA1 2BQ Harrow
    Middlesex
    সচিব
    Minister House
    8 Peterborough Road
    HA1 2BQ Harrow
    Middlesex
    British36426610002
    POWER, Anthony John
    Flat 11 Isobel House
    106-112 Station Road
    HA1 2RX Harrow
    Middlesex
    সচিব
    Flat 11 Isobel House
    106-112 Station Road
    HA1 2RX Harrow
    Middlesex
    British64225190001
    TURNER, Martin Neely
    54 Grenfell Park
    Neston
    L64 6TT South Wirral
    Merseyside
    সচিব
    54 Grenfell Park
    Neston
    L64 6TT South Wirral
    Merseyside
    British2308620001
    WILKINS, Christopher Nicholas
    5 Melrose Road
    Barnes
    SW13 9LG London
    সচিব
    5 Melrose Road
    Barnes
    SW13 9LG London
    British37360310001
    HALLAM FINANCIAL PLANNING SERVICES LTD
    145 157 St John Street
    EC1V 4PY London
    কর্পোরেট সচিব
    145 157 St John Street
    EC1V 4PY London
    42486160001
    CARTER, Anthony David
    44 Leighton Drive
    Marple Bridge
    SK6 5BY Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    44 Leighton Drive
    Marple Bridge
    SK6 5BY Stockport
    Cheshire
    British35406890001
    FINCKEN, Kenneth John
    Cookshall Farmhouse
    Cookshall Lane
    HP12 4AP West Wycombe
    পরিচালক
    Cookshall Farmhouse
    Cookshall Lane
    HP12 4AP West Wycombe
    United KingdomBritish41926340010
    MCMILLAN, Robin Chichester
    The Old Malthouse
    Church Lane Ombersley
    WR9 0ER Droitwich
    Worcestershire
    পরিচালক
    The Old Malthouse
    Church Lane Ombersley
    WR9 0ER Droitwich
    Worcestershire
    British35995090001

    REGENERATION (CAMBRIDGE) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Charge over shares
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ সেপ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fifty (50) shares of £1 each in highland trilatera limited together with all allotments, accretions, benefits and advantages whatever now or in the future accruing in respect of them. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bradda Finance and Investment Limited
    ব্যবসায়
    • ২৭ সেপ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ সেপ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bradda Finance and Investment Limited
    ব্যবসায়
    • ২৭ সেপ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ মার্চ, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Deed of assignment
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ মে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জুন, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from cheetham village investments L.P (debtor) to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of security its interest pursuant to the joint venture agreement and amendments and variations thereto; will pay and discharge the secured liabilities in accordance with the terms of the facility letter. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Investec Bank (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ০২ জুন, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or northwest estates PLC to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/Hold land on south west side of newcut west,ipswich,suffolk; t/no sk 39424.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ সেপ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ সেপ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জুল, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ জুল, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ সেপ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ অক্টো, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ অক্টো, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See doc M268C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ অক্টো, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৫ সেপ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুন, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জুল, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ জুল, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৫ সেপ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0