BL HC INVIC LEISURE LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামBL HC INVIC LEISURE LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02464159
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    BL HC INVIC LEISURE LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • হেড অফিসের কার্যক্রম (70100) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    BL HC INVIC LEISURE LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    BL HC INVIC LEISURE LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    INVICTA LEISURE LIMITED২৬ জানু, ১৯৯০২৬ জানু, ১৯৯০

    BL HC INVIC LEISURE LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০২২

    BL HC INVIC LEISURE LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাSOAS(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ২৩ ফেব, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ২৫ নভে, ২০২২ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Bl Hc Health and Fitness Holdings Limited এর বন্ধ

    1 পৃষ্ঠাPSC07

    ২৫ নভে, ২০২২ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Bl Retail Warehousing Holding Company Limited এর বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাPSC02

    ১৭ অক্টো, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Katherine Fyfe এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২০ জুল, ২০২২ তারিখে Mrs Katherine Fyfe-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২০ জুল, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Katherine Fyfe-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ২৩ মে, ২০২৩Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 23rd May 2023 under section 1088 of the Companies Act 2006

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    ২১ এপ্রি, ২০২২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1.00
    5 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Charles John Middleton এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৮ মার্চ, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Gavin Bergin-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৮ মার্চ, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Sarah Morrell Barzycki এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৮ মার্চ, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jonathan Charles Mcnuff এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৮ মার্চ, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Nick Taunt-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৮ মার্চ, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Nigel Mark Webb এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৮ মার্চ, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Paul Stuart Macey এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৩ ফেব, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    ২৩ ফেব, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    BL HC INVIC LEISURE LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইউকে লিমিটেড কোম্পানি
    নিবন্ধন নম্বর8992198
    187856670001
    BERGIN, Gavin
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish251327820001
    TAUNT, Nicholas Henry
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish275050860001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    সচিব
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    British58961410002
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    সচিব
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    162246380001
    FALLOWS, Michael Joseph
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    সচিব
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    British58345490001
    SCALES, Eugene Patrick
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    সচিব
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Other124193970001
    TYSON, Roger Thomas Virley
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    সচিব
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    British113777700001
    WEATHERLEY, Kenneth Frank
    8 Langtons Court
    Sun Lane
    SO24 9UE Alresford
    Hampshire
    সচিব
    8 Langtons Court
    Sun Lane
    SO24 9UE Alresford
    Hampshire
    British50477690001
    WONG, Wai Chung
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    সচিব
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    British123616460002
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    পরিচালক
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritish58961410002
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish32809050044
    BRAINE, Anthony
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish32809000002
    CARTER, Simon Geoffrey
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish170891060001
    CHARLTON, Stephen Paul
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    পরিচালক
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    EnglandBritish96743210001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    পরিচালক
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish146698270001
    CONNON, Daniel Francis
    Elmhurst Dundle Road
    Matfield
    TN12 7HD Tonbridge
    Kent
    পরিচালক
    Elmhurst Dundle Road
    Matfield
    TN12 7HD Tonbridge
    Kent
    British35128740001
    COUPE, David John
    1 Chelsea House
    13 Edith Grove
    SW10 0JZ London
    পরিচালক
    1 Chelsea House
    13 Edith Grove
    SW10 0JZ London
    United KingdomBritish125432970002
    CREED, Stuart John
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    পরিচালক
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    United KingdomBritish3716600001
    CURRY, John Arthur Hugh
    Stokewood Park House Sheardley Lane
    Droxford
    SO32 3QY Southampton
    পরিচালক
    Stokewood Park House Sheardley Lane
    Droxford
    SO32 3QY Southampton
    EnglandBritish2968140002
    DAVIES, Rhian Lynn
    32 Caldervale Road
    SW4 9LZ Clapham
    London
    পরিচালক
    32 Caldervale Road
    SW4 9LZ Clapham
    London
    British48466920001
    DHODY, Jog
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    পরিচালক
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish104269910002
    DICKSON, Peter Alan
    Pointer House Farm
    Langley Lane Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    পরিচালক
    Pointer House Farm
    Langley Lane Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    British13332510001
    FALLOWS, Michael Joseph
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    পরিচালক
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    EnglandBritish58345490001
    FORSHAW, Christopher Michael John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish1898090001
    FYFE, Katherine
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish293284010001
    GIBSON, Clive Patrick, The Honourable
    Monmouth House
    29a Hyde Park Gate
    SW7 5DJ London
    পরিচালক
    Monmouth House
    29a Hyde Park Gate
    SW7 5DJ London
    British45468220001
    GILLIS, Neil Duncan
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    পরিচালক
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    EnglandBritish69204500003
    GRIFFITHS, Paul Richard
    21 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9EF London
    পরিচালক
    21 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9EF London
    British54611260001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    GUYER, Paul John
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    পরিচালক
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    British100971720002
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish30306840002
    LEATHERBARROW, David Jon
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    পরিচালক
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish135618280002

    BL HC INVIC LEISURE LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Bl Retail Warehousing Holding Company Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    ২৫ নভে, ২০২২
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানEngland
    নিবন্ধন নম্বর06002154
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    Bl Hc Health And Fitness Holdings Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    হ্যাঁ
    আইনি ফর্মPrivate Company Limited By Shares
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ ব্যায় করার অধিকার রাখেন বা কার্যত ব্যায় করেন।

    BL HC INVIC LEISURE LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Fixed and floating security document
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ জুন, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Societe Generale as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ২৬ জুন, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ জুল, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Assignment of receivables
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ জুন, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Right title and interest in and to the receivables see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Esporta Financial Services Limited
    ব্যবসায়
    • ২৬ জুন, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জুল, ২০০৯
    • ০৮ ফেব, ২০১৯একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Group debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ ফেব, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ ফেব, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Secured Parties)(in Such Capacity the "Security Agent")
    ব্যবসায়
    • ১৮ ফেব, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জানু, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any other member of the group to the note finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Electra Partners Europe Limited as Noteholders' Agent and Noteholders' Security Trustee Andnoteholders Security Trust (The "Noteholders' Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ০৭ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ নভে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জানু, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ ফেব, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any member of the group (meaning the borrower or its subsidiaries from time to time) to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Dukes meadow chiswick hounslow t/no NGL147830; imperial way croydon surrey t/no SGL454522; llandarcy neath swansea t/no CYM43829 and WA953690 for details of further properties charged please refer to form 395 unscheduled property, rental income, fixed or other plant and machinery, insurances, licences on land, reights as tenant, book and other debts, bank accounts, charged securities, uncalled capital , goodwill, intellectual property, licences, credit agreements, contracts floating charge undertaking property rights and assets. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ মার্চ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ সেপ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ সেপ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H premises together with buildings erected on them k/a the bridgend health & fitness club, waterton park, waterton lane, bridgend, mid glamorgan together with all buildings and fixtures thereon and the proceeds of sale or any part thereon, all other estates or interests in the property and any rights under any licence or other agreement fixed charge present and future book and other debts, all equipment owned present and future , the benefit of all licences, permissions, consents and authorisations present and future, benefits of all insurance by way of assignment all its right, title and interest in and to all contracts and insurances.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    ব্যবসায়
    • ১২ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ মার্চ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ সেপ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from the issuer and by each charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first legal mortgage all properties now owned by or vested in each charging company including t/n HS293663 humberston country club, humberston avenue, grimsby. T/n HS293701 humberston country club, humberston avenue, grimsby and leasehold unit 9C, upper winbury farm, wingrave, aylesbury, buckinghamshire. By way of first fixed mortgage the securities, first fixed charge all properties thereafter acquired, all present and future interests in or over freehold or leasehold property; all present and future rights, licences, guarantees, rents, deposits, contracts, covenants and warranties relating to the properties.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Electra Partners Europe Limited (As Noteholders' Agent and Noteholders' Security Agent for Thenote Finance Parties)
    ব্যবসায়
    • ০৯ সেপ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জানু, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জুন, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ জুন, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £100,000 including all monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deposit and all rights titles and benefits whatsoever present and future therein.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Arrowcroft Leisure Limited
    ব্যবসায়
    • ২৮ জুন, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ মার্চ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ এপ্রি, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ এপ্রি, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £100,000 due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Charge over the deposit of £100,000.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Arrowcroft Leisure Limited
    ব্যবসায়
    • ২৬ এপ্রি, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ মার্চ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ অক্টো, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and security trustee for the finance parties (as therein defined)) on any account whatsoever, under or in connection with the financing documents (including, without limitation, the guarantee and debenture)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Coutts & Company
    ব্যবসায়
    • ২৮ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ মার্চ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১০ মার্চ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ মার্চ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and buildings lying to the north of humberston avenue humberston north east lincolnshire t/no;-HS228117 together with goodwill of any business carried on at the property and all right title and interest in and to the "acquisition documents" (as defined in the charge). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Kingsway Nominees Limitedas Trustee on Behalf of Electra Fleming Privateequity Partners (The Lender)
    ব্যবসায়
    • ২৪ মার্চ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ মার্চ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ মার্চ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    191 humberston avenue grimsby t/no ;-HS256419 together with land at the rear with title number HS228117 (part) and goodwill of any business carried on at the property and all the company's interest in and to the acquisition documents. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Coutts & Company
    ব্যবসায়
    • ২৩ মার্চ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ মার্চ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ মে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জুন, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Coutts & Company
    ব্যবসায়
    • ১০ জুন, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ জুল, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ মে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জুন, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or any group member to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Kingsway Nominees Limitedas Trustee on Behalf of Electra Fleming Privateequity Partners
    ব্যবসায়
    • ০৭ জুন, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ মার্চ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ জুল, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জুল, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £150000 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land to south of batlet road west end hampshire t/n HP471547.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Lawn Tennis Association
    ব্যবসায়
    • ২০ জুল, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ মার্চ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of amendment
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ ফেব, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    As specified in previous debenture see form 395 m/66/l for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Coutts & Co.
    ব্যবসায়
    • ২০ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ জুল, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment of life policies
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ জানু, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জানু, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility agreement dated 16/9/91 and/or this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The policies as defined below and all moneys thereby assured which may become payable thereunder and all the full benefit thereof please see form 395 5 16/1 for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Coutts & Co.
    ব্যবসায়
    • ১৫ জানু, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ জুল, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ সেপ, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ সেপ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 16 sept, 1991 and the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See form 395 and continuation sheets relevant to this charge). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Coutts & Co.
    ব্যবসায়
    • ২৩ সেপ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৬ জুল, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0