NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামNEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02470056
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ভবন নির্মাণ প্রকল্প উন্নয়ন (41100) / নির্মাণ

    NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    140 Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    GLE PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED১৪ ফেব, ১৯৯০১৪ ফেব, ১৯৯০

    NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০২০

    NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    1 পৃষ্ঠাDS01

    ২৮ জুল, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    19 পৃষ্ঠাAA

    ২৮ জুল, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ০৮ নভে, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Steven Carl Wright এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১১ ডিসে, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Christopher Arthur Rushton এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    ২৮ জুল, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    চার্জ 9 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    ২৮ জুল, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ১৪ নভে, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Steven Carl Wright-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    20 পৃষ্ঠাAA

    ০৭ অক্টো, ২০১৬ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Greater London Enterprise Investments Limited এর বিবরণের পরিবর্তন

    2 পৃষ্ঠাPSC05

    ২৮ জুল, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    ২৫ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 40 Aldersgate Street London EC1A 4HY England থেকে 140 Aldersgate Street London EC1A 4HYপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ২৪ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 10-12 Queen Elizabeth Street London SE1 2JN England থেকে 40 Aldersgate Street London EC1A 4HYপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name০৭ অক্টো, ২০১৬

    রেজোলিউশন দ্বারা নাম পরিবর্তন

    NM01
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ০৭ অক্টো, ২০১৬

    RES15

    ০৬ অক্টো, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 5th Floor Valiant Building 14 South Parade Leeds LS1 5QS থেকে 10-12 Queen Elizabeth Street London SE1 2JNপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    24 পৃষ্ঠাAA

    ২৮ জুল, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    ৩১ মে, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Michael Hofman-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ৩১ মে, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Michael Bernard Walsh এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HOFMAN, Michael
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    সচিব
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    209188220001
    MANSON, Christopher John
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    পরিচালক
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    United KingdomBritish175493670001
    WALSH, Michael Bernard
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    পরিচালক
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    EnglandBritish74086660002
    CHAPMAN, Paul Stephen
    13 Southbourne
    Hayes
    BR2 7NJ Bromley
    Kent
    সচিব
    13 Southbourne
    Hayes
    BR2 7NJ Bromley
    Kent
    British1403010005
    GERVASIO, James Ernest Peter
    Chapeltown Road
    LS7 4HZ Leeds
    Saint Martins House 210-212
    West Yorkshire
    সচিব
    Chapeltown Road
    LS7 4HZ Leeds
    Saint Martins House 210-212
    West Yorkshire
    British2093810001
    NOEL, Dawn
    6 Cantley Road
    Hanwell
    W7 2BQ London
    সচিব
    6 Cantley Road
    Hanwell
    W7 2BQ London
    British79021070001
    WALSH, Michael Bernard
    14 South Parade
    LS1 5QS Leeds
    5th Floor Valiant Building
    England
    সচিব
    14 South Parade
    LS1 5QS Leeds
    5th Floor Valiant Building
    England
    159189680001
    WOODALL, Michael David
    Glovers Cottage Reigate Hill
    RH2 9PN Reigate
    Surrey
    সচিব
    Glovers Cottage Reigate Hill
    RH2 9PN Reigate
    Surrey
    British4777030001
    COMPTON, Colin Richard
    Kingsland House Kingsland Lane
    Leavenheath
    CO6 4PD Colchester
    Essex
    পরিচালক
    Kingsland House Kingsland Lane
    Leavenheath
    CO6 4PD Colchester
    Essex
    British12075710001
    LARGE, Martin Gerald
    14 South Parade
    LS1 5QS Leeds
    5th Floor Valiant Building
    England
    পরিচালক
    14 South Parade
    LS1 5QS Leeds
    5th Floor Valiant Building
    England
    EnglandBritish44118740003
    ROGERS, Mary
    Basement Flat
    46 Gordon Square
    WC1H 0PD London
    পরিচালক
    Basement Flat
    46 Gordon Square
    WC1H 0PD London
    British85165800001
    RUSHTON, Christopher Arthur
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    পরিচালক
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    EnglandBritish44369580002
    WRIGHT, Steven Carl
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    পরিচালক
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    EnglandBritish232556880001

    NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Newable Uk Holdings Limited
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    না
    আইনি ফর্মLimited Company
    নিবন্ধিত দেশUnited Kingdom
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানEngland And Wales Companies Register
    নিবন্ধন নম্বর5547054
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Assignment of share sale agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ অক্টো, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company with full title guarantee assigns to the bank by way of charge all that an agreement relating inter alia to the sale by the company of it's shares in gle property developments (kingston) limited dated 02 february 2001... see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Co-Operative Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ অক্টো, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ ফেব, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment of building contract
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ অক্টো, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company with full title guarantee assigns to the bank by way of charge all that the agreement dated 05 june 2001 and the full benefit thereof and the benefit of any claims or compensation whatsoever arising thereunder... See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Co-Operative Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ অক্টো, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ ফেব, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge on shares
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ অক্টো, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All of the company's obligations to the chargee (or any company which is a member of the same group of companies of the bank) of any kind and in any currency
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The one ordinary share held by the company in gle property developments (kingston) limited (which constitutes the entire issued share capital of that company) together with all other stocks, shares, bonds, or other securities at any time deposited with or transferred to the bank or its nominee by the company.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Co-Operative Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ অক্টো, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ ফেব, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment of building contract
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Building contract means the agreement dated the 6 february 2001 made between the customer and the contractor and includes the drawings specifications and attachments referred to therein contractor means buxton building contractors limited c/number 2261235 of cedar house 91 high street caterham surrey CR3 5UH. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Co-Operative Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ সেপ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Co-Operative Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ ফেব, ২০০২বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২০ ফেব, ২০১৯একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deed of legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The property k/a land and premises at st georges square (west) gore street deptford london SE8 t/n TGL182465.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Co-Operative Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ সেপ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ মে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H-part of number 90 and the wholes of numbers 92 to 104 (even) newington butts kennington london. Fixed charge over the plant machinery and fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils of the company and the present or future goodwill of any business.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ মে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ ফেব, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ ডিসে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    112,114,116,118,120,122,124 newington butts and 76/77 holyoak road kenniongton t/ns ln 13388 sgl 298102. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ ফেব, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ নভে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ নভে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H-land lying to the north east of therapia lane L.B. of sutton land and buildings to the north east of therapia lane L.B. of sutton and land on the south east side of the south east of the junction of therapia lane and beddington lane beddington L.B. of sutton greater london t/n-SGL532994, SGL556142, SGL213815.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ নভে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ ফেব, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ আগ, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H- parcels of land in boot street hoxton market shoreditch london N1 t/n-EGL287091. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Co-Operative Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ আগ, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ ফেব, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Letter
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ আগ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ সেপ, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the letter
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Cash sum of £4,000.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Snowcem Pmc Limited
    ব্যবসায়
    • ০১ সেপ, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ ফেব, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জানু, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £200,000
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land containing 5.81 acres or thereabouts at therapia lane off beddington lane L.B. of sutton.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Blue Circle Industries PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জানু, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land containing 5.81 acres or thereabouts at therapia lane off beddington lane L.B. of sutton together with all buildings and fixtures fixed charge on all attached plant and machinery and other chattels floatings charge over all unattached plant and machinery and other chattels.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Co-Operative Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ অক্টো, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0