DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামDONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট আনলিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02475089
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL এর উদ্দেশ্য কী?

    • (6712) /

    DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    One Cabot Square
    London
    E14 4QJ
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    DLJ (UK) LIMITED০৯ জুল, ১৯৯০০৯ জুল, ১৯৯০
    HACKREMCO (NO.575) LIMITED২৮ ফেব, ১৯৯০২৮ ফেব, ১৯৯০

    DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৯

    DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৩ ফেব, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৩ ফেব, ২০১১

    ২৩ ফেব, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: USD 1.5
    SH01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    8 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    পরিচালক হিসাবে Susannah Louise Aliker-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    20 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে David Long এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ ফেব, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Paul Edward Hare-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Kevin Studd এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Costas Michaelides-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Costas Michaelides-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে David Long-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Paul Edward Hare-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Kevin Lester Studd-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    21 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    5 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    21 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    3 পৃষ্ঠা288a

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    9 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের স্মারকলিপি এবং/অথবা নিবন্ধের রেজুলেশন

    RES01

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    20 পৃষ্ঠাAA

    DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HARE, Paul Edward
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    সচিব
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    British23220350004
    ALIKER, Susannah Louise
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    1
    পরিচালক
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    1
    United KingdomBritish99766410001
    HARE, Paul Edward
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    পরিচালক
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United KingdomBritish23220350004
    MICHAELIDES, Costas, Chair Of The Board Of Directors
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    পরিচালক
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    United KingdomAmerican,Cypriot73091230001
    HARRIMAN, John Patrick William
    Flat 3 6 Tedworth Square
    SW3 4DY London
    সচিব
    Flat 3 6 Tedworth Square
    SW3 4DY London
    British49828030001
    HORNSEY, Nicholas John
    Eremue
    8 The Avenue
    TW12 3RS Hampton
    Middlesex
    সচিব
    Eremue
    8 The Avenue
    TW12 3RS Hampton
    Middlesex
    British50650950002
    SIEGLER, Thomas Edmund
    39 Wildwood Drive
    Dix Hills
    New York 11746
    Usa
    সচিব
    39 Wildwood Drive
    Dix Hills
    New York 11746
    Usa
    American47358850001
    AITCHINSON, Carolyn Jane
    126 Palace Gardens Terrace
    W8 4RT London
    পরিচালক
    126 Palace Gardens Terrace
    W8 4RT London
    British62873110004
    ALEXANDRE, James Lawrence
    33 Blomfield Road
    W9 1AA London
    পরিচালক
    33 Blomfield Road
    W9 1AA London
    American63091430001
    BRETTON, Nigel Paul
    Blue Clay
    33 Rose Walk
    AL4 9AA St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Blue Clay
    33 Rose Walk
    AL4 9AA St Albans
    Hertfordshire
    British75188550001
    BURROWES, Kevin James
    Samuelson House
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LP Cobham
    Surrey
    পরিচালক
    Samuelson House
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LP Cobham
    Surrey
    British105411790001
    CATANIA, Alejandro Miguel
    90 Palace Gardens Terrace
    W8 4RF London
    পরিচালক
    90 Palace Gardens Terrace
    W8 4RF London
    Itialian74299160001
    DISLEY, Kevin John
    18 Larksway
    CM23 4DG Bishops Stortford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    18 Larksway
    CM23 4DG Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish147923330001
    GORMLEY, Peter Vincent
    Pinehill
    Sunning Avenue
    SL5 9PW Sunningdale
    Berkshire
    পরিচালক
    Pinehill
    Sunning Avenue
    SL5 9PW Sunningdale
    Berkshire
    Usa52530740001
    GREEN, Darryl John
    Wychden
    Wildernesse Avenue
    TN15 0EA Sevenoaks
    Kent
    পরিচালক
    Wychden
    Wildernesse Avenue
    TN15 0EA Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish60672010001
    HALE, Charles Martin
    33 Lyall Mews
    SW1X 8DJ London
    পরিচালক
    33 Lyall Mews
    SW1X 8DJ London
    United KingdomBritish105772830001
    HARRIMAN, John Patrick William
    Flat 3 6 Tedworth Square
    SW3 4DY London
    পরিচালক
    Flat 3 6 Tedworth Square
    SW3 4DY London
    British49828030001
    HART, Mark
    39 Gilhams Avenue
    SM7 1QW Banstead
    Surrey
    পরিচালক
    39 Gilhams Avenue
    SM7 1QW Banstead
    Surrey
    British67366820001
    HIARD, Michael Henry
    Foxes
    High Wych Road
    CM21 OHH Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Foxes
    High Wych Road
    CM21 OHH Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    British18403810002
    HOHMANN III, Frank Lynn
    242 Hendrickson Drive
    Princeton Junction
    New Jersey 08550
    Usa
    পরিচালক
    242 Hendrickson Drive
    Princeton Junction
    New Jersey 08550
    Usa
    American33491720001
    KAWKABANI, Nagi Robert
    47 Lennox Gardens
    SW1 London
    পরিচালক
    47 Lennox Gardens
    SW1 London
    United KingdomCanadian33491730003
    LONG, David
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    পরিচালক
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    United KingdomBritish126956520001
    MASMEJEAN, Pierre Olivier
    66 Redcliffe Road
    SW10 9NQ London
    পরিচালক
    66 Redcliffe Road
    SW10 9NQ London
    French49032650001
    PETRILLI, Anthony Mario
    18 Icklingham Road
    KT11 2NQ Cobham
    Surrey
    পরিচালক
    18 Icklingham Road
    KT11 2NQ Cobham
    Surrey
    British54390740001
    PIKE, Catherine Elizabeth
    75 Noel Road
    N1 8HE London
    পরিচালক
    75 Noel Road
    N1 8HE London
    British45313610002
    RATTNER, Steven Charles
    408 Grace Church Street
    Rye
    New York
    Ny 10580
    Usa
    পরিচালক
    408 Grace Church Street
    Rye
    New York
    Ny 10580
    Usa
    American70635020001
    ROBINSON, Nicholas Ian
    Beechwood Little Orchards
    Salvington Hill
    BN13 3BD Worthing
    West Sussex
    পরিচালক
    Beechwood Little Orchards
    Salvington Hill
    BN13 3BD Worthing
    West Sussex
    British44793820001
    ROE, Steven Robin Charles
    10 Eastwood
    Bridgewater Road
    KT13 0EG Weybridge
    Surrey
    পরিচালক
    10 Eastwood
    Bridgewater Road
    KT13 0EG Weybridge
    Surrey
    British34616850002
    SANTS, Hector William Hepburn
    Court Farm
    Worminghall
    HP18 9LD Aylesbury
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Court Farm
    Worminghall
    HP18 9LD Aylesbury
    Buckinghamshire
    British1576920001
    SEET, Joe Lip Poh
    6 Padbrook
    RH8 0DW Oxted
    Surrey
    পরিচালক
    6 Padbrook
    RH8 0DW Oxted
    Surrey
    British52359050001
    SMITH, Martin, Sir
    4 Essex Villas
    W8 7BN London
    পরিচালক
    4 Essex Villas
    W8 7BN London
    United KingdomBritish35552480001
    STUDD, Kevin Lester
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    পরিচালক
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    United KingdomBritish86302520001
    WRIGHT, Geraldine Helen
    30 High Gables
    1 Scotts Avenue
    BR2 0NB Bromley
    Kent
    পরিচালক
    30 High Gables
    1 Scotts Avenue
    BR2 0NB Bromley
    Kent
    British83599210001

    DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Collateral agreement governing secured borrowings by participants in the euroclear system
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ সেপ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ সেপ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All borrowings (meaning overdraft, fixed term advances or securities borrowing, or any other extension of credit by morgan guaranty trust company of new york to the borrower, in whatever form, that relates to or results from the borrower's use of the euroclear system, as well as any fees or accrued interest with respect thereto), and other obligations, in whatever form, that relate to or result from the borrower's use of the euroclear system, now outstanding or which may be outstanding at any time in the future to morgan guaranty brussels and to any other office of morgan guaranty trust company of new york
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All "collateral" including in particular cash and securities clearance accounts opened in connection with the euroclear system by the brussels office of morgan guaranty on its books in the name of the company. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    ব্যবসায়
    • ১১ সেপ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ জুল, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ সেপ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ অক্টো, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All shares, stock and other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities, together with all benefits arising therefrom and not transferred or delivered by or at the direction of the stock exchange to the company.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The International Stock Exchange of the United Kingdom and Republic of Ireland Limited
    ব্যবসায়
    • ০৭ অক্টো, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ সেপ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0