ISI DISTRIBUTION LTD

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামISI DISTRIBUTION LTD
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02478802
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ISI DISTRIBUTION LTD এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবা কার্যক্রম (62090) / তথ্য এবং যোগাযোগ

    ISI DISTRIBUTION LTD কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Redwood 2 Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Hampshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ISI DISTRIBUTION LTD এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    IQ SYS LIMITED০৫ অক্টো, ২০০৬০৫ অক্টো, ২০০৬
    INTERQUAD SYSTEMS LIMITED২৯ ডিসে, ২০০০২৯ ডিসে, ২০০০
    INTERQUAD DISTRIBUTION LIMITED১৪ মে, ১৯৯৮১৪ মে, ১৯৯৮
    EXOCOM INTERNATIONAL LIMITED০৩ জুল, ১৯৯০০৩ জুল, ১৯৯০
    POWERBAND LIMITED০৮ মার্চ, ১৯৯০০৮ মার্চ, ১৯৯০

    ISI DISTRIBUTION LTD এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০১৫

    ISI DISTRIBUTION LTD এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    8 পৃষ্ঠাLIQ13

    ১০ আগ, ২০১৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    9 পৃষ্ঠাLIQ03

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    4 পৃষ্ঠাLIQ01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১১ আগ, ২০১৭ তারিখে

    LRESSP

    ২৭ জুন, ২০১৭ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    5 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Share premium account cancelled 20/06/2017
    RES13
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    ০৮ মার্চ, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৯ জুল, ২০১৬

    ১৯ জুল, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,100
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Appointment of dirs 12/10/2015
    RES13

    ২৯ জুন, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Peter Hubbard এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৬ অক্টো, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr David Watts-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৬ অক্টো, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Howard Tuffnail-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৬ অক্টো, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Andy Gass-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    19 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০২ জুন, ২০১৫

    ০২ জুন, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,100
    SH01

    ২৮ নভে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Paul Andrew Eccleston এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    20 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৫ মার্চ, ২০১৪

    ২৫ মার্চ, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,100
    SH01

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩১ মার্চ, ২০১৪ থেকে ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত

    3 পৃষ্ঠাAA01

    ISI DISTRIBUTION LTD এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    OLLIS, Rachel Anne
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    সচিব
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    178574660001
    GASS, Andrew
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    পরিচালক
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    EnglandBritish49358720003
    TUFFNAIL, Howard
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    পরিচালক
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United KingdomCanadian202334610001
    WATTS, David
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    পরিচালক
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    EnglandBritish160214110001
    ARNETT, Edward Alan
    21 Clearwater Place
    Long Ditton
    KT6 4ET Surbiton
    Surrey
    সচিব
    21 Clearwater Place
    Long Ditton
    KT6 4ET Surbiton
    Surrey
    British84568350002
    HYAMS, Mitchell Spencer
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    সচিব
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    British13800580002
    JOHNSON, Ian Paul
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    সচিব
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    British136279590001
    PENNELLS, John Richard
    Enclave
    Wych Hill Way
    GU22 0AE Woking
    Surrey
    সচিব
    Enclave
    Wych Hill Way
    GU22 0AE Woking
    Surrey
    British7347950001
    TRAINER, Martin John
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    সচিব
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    British124180840001
    ARNETT, Edward Alan
    21 Clearwater Place
    Long Ditton
    KT6 4ET Surbiton
    Surrey
    পরিচালক
    21 Clearwater Place
    Long Ditton
    KT6 4ET Surbiton
    Surrey
    British84568350002
    CORNWALL, Douglas Charles
    Domaine De La Roche
    Le Bigard
    GY8 0HT Forest
    Guernsey
    Channel Islands
    পরিচালক
    Domaine De La Roche
    Le Bigard
    GY8 0HT Forest
    Guernsey
    Channel Islands
    United KingdomBritish84669710001
    ECCLESTON, Paul Andrew
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish139879610001
    FANE, Sean Paul
    Nashgrove Lane
    Finchampstead
    RG40 4HG Wokingham
    131
    Berkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Nashgrove Lane
    Finchampstead
    RG40 4HG Wokingham
    131
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish67225450007
    HERRON, Bonnie Lea
    1959 Trotters Lane
    Stone Mountain
    30087 Georgia
    Usa
    পরিচালক
    1959 Trotters Lane
    Stone Mountain
    30087 Georgia
    Usa
    American16958430002
    HUBBARD, Peter
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish167795150001
    HYAMS, Mitchell Spencer
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish13800580002
    JAMES, Philip John
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish118754760002
    JOHNSON, Ian Paul
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish136279590001
    MACPHERSON, William Robert George
    Benenden
    TN17 4LG Cranbrook
    Little Nineveh
    Kent
    United Kingdom
    পরিচালক
    Benenden
    TN17 4LG Cranbrook
    Little Nineveh
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish132097710001
    MARTIN, Christian John
    Kingswood House
    Tag Lane Wargrave
    RG10 9ST Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    Kingswood House
    Tag Lane Wargrave
    RG10 9ST Reading
    Berkshire
    EnglandBritish113992220001
    MCCORMICK, John Edgar
    5275 Cameron Forest Parkway
    FOREIGN Alpharetti
    Georgia
    Usa
    পরিচালক
    5275 Cameron Forest Parkway
    FOREIGN Alpharetti
    Georgia
    Usa
    American16958460001
    MINNS, Gregory Leslie John
    113 Paddick Drive
    RG6 4HF Lower Earley
    Berkshire
    পরিচালক
    113 Paddick Drive
    RG6 4HF Lower Earley
    Berkshire
    United KingdomBritish72170360001
    PENNELLS, John Richard
    Enclave
    Wych Hill Way
    GU22 0AE Woking
    Surrey
    পরিচালক
    Enclave
    Wych Hill Way
    GU22 0AE Woking
    Surrey
    EnglandBritish7347950001
    RIGBY, James Peter
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish88633720001
    RIGBY, Peter, Sir
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Crockford Lane
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WQ Basingstoke
    Redwood 2
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish15654920006
    STRANGE, John Leland
    2714 Meadow Church Road
    FOREIGN Duluth
    Georgia
    Usa
    পরিচালক
    2714 Meadow Church Road
    FOREIGN Duluth
    Georgia
    Usa
    American16958470001
    TRAINER, Martin John
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    পরিচালক
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    EnglandBritish124180840001

    ISI DISTRIBUTION LTD এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Specialist Distribution Group (Sdg) Ltd
    Guildford Road
    Normandy
    GU3 2AW Guildford
    Redwood 2
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Guildford Road
    Normandy
    GU3 2AW Guildford
    Redwood 2
    England
    না
    আইনি ফর্মLimited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষEngland And Wales
    নিবন্ধিত স্থানEngland
    নিবন্ধন নম্বর1769690
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    ISI DISTRIBUTION LTD এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A fixed charge on book and other debts
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ নভে, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All book debts and other debts and monetary claims and any rent licence fees or other payments due from any lessee, licensee or occupier of any immovable property wherever.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ নভে, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২১ নভে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal assignment
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ নভে, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any credit balance due under the contract (the contract monies).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ নভে, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২১ নভে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ নভে, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ নভে, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed equitable charge all purchased debts which fail to vest effectively or absolutely in the security holder pursuant to the agreement see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    ব্যবসায়
    • ০৯ নভে, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২১ নভে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    All assets debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ অক্টো, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ অক্টো, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ২৭ অক্টো, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১২ নভে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Fixed & floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ মে, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Rbs Invoice Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ২৭ মে, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ আগ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ অক্টো, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ নভে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland, as Security Trustee for the Finance Parties
    ব্যবসায়
    • ০৩ নভে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ মে, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জুন, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জুন, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৫ জুন, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ নভে, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    All assets debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ নভে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ২৩ নভে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ নভে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ নভে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ মে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a guarantee agreement of even date and the deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Isc (Guernsey) Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ মে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ ফেব, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ ফেব, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 3 february 1999
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Isc (Guernsey) Limited
    ব্যবসায়
    • ১৬ ফেব, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ মে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জানু, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ ফেব, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ ফেব, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ ডিসে, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge over all book and other debts present and future and the benefit of all contracts and policies of insurance and by way of floating charge the undertaking and all property assets and rights of the company present and future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Euro Sales Finance PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ ডিসে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ ডিসে, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    ISI DISTRIBUTION LTD এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১১ আগ, ২০১৭ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১৬ জানু, ২০২০ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0