HOZELOCK GROUP LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামHOZELOCK GROUP LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 02496708
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    HOZELOCK GROUP LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন (22290) / উৎপাদন

    HOZELOCK GROUP LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    HOZELOCK GROUP LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    FLYVILLE LIMITED২৭ এপ্রি, ১৯৯০২৭ এপ্রি, ১৯৯০

    HOZELOCK GROUP LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১৯

    HOZELOCK GROUP LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাSOAS(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    1 পৃষ্ঠাDS01

    ২১ এপ্রি, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ১৭ ডিসে, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Yves Emile Pierre Belegaud-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৭ ডিসে, ২০১৯ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Guerric Ballu এর বন্ধ

    1 পৃষ্ঠাPSC07

    ১৭ ডিসে, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Guerric Ballu এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    20 পৃষ্ঠাAA

    ২১ এপ্রি, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    ২১ এপ্রি, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    ৩০ নভে, ২০১৭ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Emmanuel Julien Perrousset-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ৩০ নভে, ২০১৭ তারিখে সচিব হিসাবে Gary Thorington Jones এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ২১ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২১ এপ্রি, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৮ মে, ২০১৬

    ১৮ মে, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,227,636.45
    SH01

    ২৪ মার্চ, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Gary Thorington Jones-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ২৩ মার্চ, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Helen Semmens এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩১ আগ, ২০১৬ থেকে ৩০ সেপ, ২০১৬ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ আগ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    ০১ আগ, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Helen Semmens-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    পূর্ণ হিসাব ৩১ আগ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২১ এপ্রি, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৮ মে, ২০১৫

    ১৮ মে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,227,636.45
    SH01

    HOZELOCK GROUP LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PERROUSSET, Emmanuel Julien
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    সচিব
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    240709370001
    BALLU, Marc
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    পরিচালক
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    United KingdomFrenchDirector174120160002
    BELEGAUD, Yves Emile Pierre
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    পরিচালক
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    FranceFrenchChairman265689980001
    JONES, Gary Thorington
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    সচিব
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    207074230001
    POTTER, Donald Stanley
    Crispins 64 The Avenue
    Worminghall
    HP18 9LE Aylesbury
    Buckinghamshire
    সচিব
    Crispins 64 The Avenue
    Worminghall
    HP18 9LE Aylesbury
    Buckinghamshire
    British14077190001
    SEMMENS, Helen
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    সচিব
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    199904670001
    WOOD, Martin
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    সচিব
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    153428180001
    ADAMS, Peter George
    Lower Northcott Farm
    Sheldon
    EX15 2JF Cullompton
    Devon
    পরিচালক
    Lower Northcott Farm
    Sheldon
    EX15 2JF Cullompton
    Devon
    BritishChief Executive112143030001
    ALGAR, David Stanley
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    পরিচালক
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    EnglandBritishDirector104137450004
    BALLU, Guerric
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    পরিচালক
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    FranceFrenchDirector80574650002
    CODLING, David Fletcher
    Bowers Farm
    Magpie Lane
    HP7 0LU Coleshill Amersham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Bowers Farm
    Magpie Lane
    HP7 0LU Coleshill Amersham
    Buckinghamshire
    BritishChairman14064770002
    DUDEK, Michael Henry
    Walnut Tree Cottage Walton Lane
    Wellesbourne
    CV35 9RD Warwickshire
    পরিচালক
    Walnut Tree Cottage Walton Lane
    Wellesbourne
    CV35 9RD Warwickshire
    BritishOperations Director39236340002
    FEWELL, Peter William Charles
    Mount Pleasant Farm
    Thame Road
    OX44 7HX Great Milton
    Oxon
    পরিচালক
    Mount Pleasant Farm
    Thame Road
    OX44 7HX Great Milton
    Oxon
    BritishTechnical Director14037250003
    FLEURAT, Pierre
    9 Avenue Elisee Reclus
    FOREIGN 75007
    Paris
    France
    পরিচালক
    9 Avenue Elisee Reclus
    FOREIGN 75007
    Paris
    France
    FrenchDirector72217940002
    FOBEL, Anthony Peter
    1st Floor Flat 105 King Henrys Road
    NW3 3QX London
    পরিচালক
    1st Floor Flat 105 King Henrys Road
    NW3 3QX London
    BritishVenture Capitalist71917500001
    HALL, Stephen John
    Adringal Cottages
    Horton Horton Hill
    BS37 6QP Bristol
    1
    পরিচালক
    Adringal Cottages
    Horton Horton Hill
    BS37 6QP Bristol
    1
    EnglandBritishChief Executive147526740001
    HARGREAVES, David
    Willards Farm The Common
    Dunsfold
    GU8 4LB Godalming
    Surrey
    পরিচালক
    Willards Farm The Common
    Dunsfold
    GU8 4LB Godalming
    Surrey
    BritishFinancier54809160001
    HART, Raymond John
    Witches Broom Raggleswood
    BR7 5NH Chislehurst
    Kent
    পরিচালক
    Witches Broom Raggleswood
    BR7 5NH Chislehurst
    Kent
    BritishCompany Director63042500002
    MACKENZIE, Alexander Donald
    Shalden Lodge
    Shalden Lane Shalden
    GU34 4DU Alton
    Hampshire
    পরিচালক
    Shalden Lodge
    Shalden Lane Shalden
    GU34 4DU Alton
    Hampshire
    United KingdomBritishBanker105120270001
    MASKELL, Philip John
    1 Grange Cottages
    Broad Common Road
    RG10 0RD Hurst
    Berkshire
    পরিচালক
    1 Grange Cottages
    Broad Common Road
    RG10 0RD Hurst
    Berkshire
    BritishBanker5733160002
    POTTER, Donald Stanley
    Crispins 64 The Avenue
    Worminghall
    HP18 9LE Aylesbury
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Crispins 64 The Avenue
    Worminghall
    HP18 9LE Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinancial Director14077190001
    ROLLAND, Stuart Stacy
    Rosemary Cottage
    Northchurch
    HP4 3QS Berkhamsted
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Rosemary Cottage
    Northchurch
    HP4 3QS Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritishManaging Director206839450001
    RUSH, Peter John
    2 The Conifers
    Birches Lane
    CV8 2BF Kenilworth
    Warwickshire
    পরিচালক
    2 The Conifers
    Birches Lane
    CV8 2BF Kenilworth
    Warwickshire
    EnglandBritishDirector94039640002
    SNOWDEN, Paul Boothby
    10 Dunton Close
    Four Oaks
    B75 5QD Sutton Coldfield
    Birmingham
    পরিচালক
    10 Dunton Close
    Four Oaks
    B75 5QD Sutton Coldfield
    Birmingham
    BritishTechnical Director69874210002
    WALKER, Gerald Neill
    The Laurels 5 Aston Gardens
    Aston Rowant
    OX49 5SY Watlington
    Oxfordshire
    পরিচালক
    The Laurels 5 Aston Gardens
    Aston Rowant
    OX49 5SY Watlington
    Oxfordshire
    BritishCommercial Director84568760001
    WOOD, Martin Richard
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    পরিচালক
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    EnglandBritishDirector152495780001

    HOZELOCK GROUP LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Mr Guerric Ballu
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    হ্যাঁ
    জাতীয়তা: French
    বাসস্থানের দেশ: France
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তি কোম্পানির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ ব্যায় করার অধিকার রাখেন বা কার্যত ব্যায় করেন।
    Mr Marc Ballu
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Midpoint Park
    Minworth
    B76 1AB Sutton Coldfield
    না
    জাতীয়তা: French
    বাসস্থানের দেশ: United Kingdom
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তি কোম্পানির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ ব্যায় করার অধিকার রাখেন বা কার্যত ব্যায় করেন।

    HOZELOCK GROUP LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মার্চ, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ মার্চ, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২৪ মার্চ, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ৩০ জানু, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ জানু, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জানু, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ জানু, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ জানু, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুল, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the credit agreement (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Agent and Trustee for the Secured Parties(As Defined)
    ব্যবসায়
    • ১২ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ জানু, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture and guarantee
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জুল, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facilities agreement dated 25TH april 1990 (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Lenders
    ব্যবসায়
    • ০৭ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture & guarantee.
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ জুল, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ আগ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein on the chargee under the terms of the facilities agreement dated 17/7/90 and this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent
    ব্যবসায়
    • ০৬ আগ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৭ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0